IMPROVEMENT SERVICE COMPANY

IMPROVEMENT SERVICE COMPANY

  • Visión general
  • Resumen
  • Propósito
  • Dirección
  • Cuentas
  • Declaración de confirmación
  • Presentaciones
  • Directivos
  • Declaraciones de personas con control significativo
  • Fuente de datos
  • Visión general

    Nombre de la empresaIMPROVEMENT SERVICE COMPANY
    Estado de la empresaActiva
    Forma jurídicaSociedad de responsabilidad limitada por garantía sin capital social, exención del uso de 'Limited'
    Número de empresa SC287978
    JurisdicciónEscocia
    Fecha de constitución

    Resumen

    Tiene PSCs súper segurosNo
    Tiene gravámenesNo
    Tiene historial de insolvenciaNo
    La sede social está en disputaNo

    ¿Cuál es el propósito de IMPROVEMENT SERVICE COMPANY?

    • Actividades de consultoría de gestión que no sean gestión financiera (70229) / Actividades profesionales, científicas y técnicas

    ¿Dónde se encuentra IMPROVEMENT SERVICE COMPANY?

    Dirección de la sede social
    West Lothian Council Civic Centre
    Howden South Road
    EH54 6FF Livingston
    Scotland
    Dirección de la sede social no entregableNo

    ¿Cuáles son las últimas cuentas de IMPROVEMENT SERVICE COMPANY?

    VencidoNo
    Próximas cuentas
    Próximo período contable finaliza el31 mar 2026
    Próximas cuentas vencen el31 dic 2026
    Últimas cuentas
    Últimas cuentas cerradas hasta31 mar 2025

    ¿Cuál es el estado de la última declaración de confirmación para IMPROVEMENT SERVICE COMPANY?

    Última declaración de confirmación cerrada hasta07 jun 2026
    Próxima declaración de confirmación vence21 jun 2026
    Última declaración de confirmación
    Próxima declaración de confirmación cerrada hasta07 jun 2025
    VencidoNo

    ¿Cuáles son las últimas presentaciones para IMPROVEMENT SERVICE COMPANY?

    Presentaciones
    FechaDescripciónDocumentoTipo

    Cuentas completas preparadas hasta el 31 mar 2025

    39 páginasAA

    replacement-filing-of-director-appointment-with-name

    3 páginasRP01AP01

    Declaración de confirmación presentada el 07 jun 2025 sin actualizaciones

    3 páginasCS01

    Nombramiento de Mr Derek Brown como director el 30 abr 2025

    3 páginasAP01
    Anotaciones
    FechaAnotación
    13 oct 2025Clarification A replacement AP01 was registered on 13/10/2025.

    Cese del nombramiento de Louise Long como director el 24 mar 2025

    1 páginasTM01

    Nombramiento de Cllr Heather Jane Dow Anderson como director el 14 ene 2025

    2 páginasAP01

    Cuentas completas preparadas hasta el 31 mar 2024

    39 páginasAA

    Cese del nombramiento de Joanna Mowat como director el 25 nov 2024

    1 páginasTM01

    Nombramiento de Ms Lesley Ritchie Brown como director el 21 oct 2024

    2 páginasAP01

    Cambio de datos del director Ms Sarah Gadsden el 03 may 2023

    2 páginasCH01

    Cese del nombramiento de Angela Scott como director el 10 sept 2024

    1 páginasTM01

    Declaración de confirmación presentada el 07 jun 2024 sin actualizaciones

    3 páginasCS01

    Memorándum y Estatutos

    20 páginasMA

    Resoluciones

    Resolutions
    1 páginasRESOLUTIONS
    Acuerdos
    CategoríaFechaDescripciónTipo
    capital

    Resoluciones

    Section 175(5)(a) authorisation of conflicts of interests 17/05/2024
    RES13
    incorporation

    Resolución de adopción de los Artículos de Asociación

    RES01

    Nombramiento de Cllr Claire Helen Innes Miller como director el 09 abr 2024

    2 páginasAP01

    Nombramiento de Cllr Joanna Mowat como director el 09 abr 2024

    2 páginasAP01

    Nombramiento de Mr Paul Thomas Manning como director el 01 abr 2024

    2 páginasAP01

    Cese del nombramiento de Andrew Cameron Kerr como director el 13 mar 2024

    1 páginasTM01

    Cese del nombramiento de Ellen Forson como director el 01 dic 2023

    1 páginasTM01

    Cese del nombramiento de Neil Collington Benny como director el 01 dic 2023

    1 páginasTM01

    Cuentas completas preparadas hasta el 31 mar 2023

    34 páginasAA

    Cese del nombramiento de Loraine Mcmillan como director el 12 jun 2023

    1 páginasTM01

    Declaración de confirmación presentada el 07 jun 2023 sin actualizaciones

    3 páginasCS01

    Domicilio social registrado cambiado de I Hub Quarrywood Court Livingston Village Livingston EH54 6AZ Scotland a West Lothian Council Civic Centre Howden South Road Livingston EH54 6FF el 03 may 2023

    1 páginasAD01

    Nombramiento de Ms Louise Long como director el 01 may 2023

    2 páginasAP01

    ¿Quiénes son los directivos de IMPROVEMENT SERVICE COMPANY?

    Directivos
    NombreNombrado elRenunció elRolDirecciónIdentificación de la empresaPaís de residenciaNacionalidadFecha de nacimientoOcupaciónNúmero
    ANDERSON, Heather Jane Dow, Cllr
    17 City Square
    DD1 3BY Dundee
    City Chambers
    Scotland
    Director
    17 City Square
    DD1 3BY Dundee
    City Chambers
    Scotland
    ScotlandScottish297102150001
    BROWN, Derek
    Glenurquhart Road
    IV3 5NX Inverness
    Highland Council Headquarters
    Scotland
    Director
    Glenurquhart Road
    IV3 5NX Inverness
    Highland Council Headquarters
    Scotland
    ScotlandBritish335591720001
    BROWN, Lesley Ritchie
    Howden South Road
    EH54 6FF Livingston
    West Lothian Council Civic Centre
    Scotland
    Director
    Howden South Road
    EH54 6FF Livingston
    West Lothian Council Civic Centre
    Scotland
    ScotlandBritish328519120001
    GADSDEN, Sarah
    Howden South Road
    EH54 6FF Livingston
    West Lothian Council Civic Centre
    Scotland
    Director
    Howden South Road
    EH54 6FF Livingston
    West Lothian Council Civic Centre
    Scotland
    ScotlandBritish247564720001
    MACDONALD, Sandra Mary
    Broad Street
    AB10 1FY Aberdeen
    Town House
    Scotland
    Director
    Broad Street
    AB10 1FY Aberdeen
    Town House
    Scotland
    United KingdomBritish97466610001
    MANNING, Paul Thomas
    Almada Street
    ML3 0AA Hamilton
    Council Offices
    Scotland
    Director
    Almada Street
    ML3 0AA Hamilton
    Council Offices
    Scotland
    ScotlandBritish118633100001
    MILLER, Claire Helen Innes, Cllr
    High Street
    EH1 1YJ Edinburgh
    City Chambers
    Scotland
    Director
    High Street
    EH1 1YJ Edinburgh
    City Chambers
    Scotland
    ScotlandBritish264850570001
    MORRISON, Shona, Cllr
    9 Haymarket Yards
    EH12 5BH Edinburgh
    Verity House
    Scotland
    Director
    9 Haymarket Yards
    EH12 5BH Edinburgh
    Verity House
    Scotland
    ScotlandBritish301350260001
    SANDISON, Maggie
    North Ness
    Lerwick
    ZE1 0LZ Shetland
    8
    Scotland
    Director
    North Ness
    Lerwick
    ZE1 0LZ Shetland
    8
    Scotland
    ScotlandBritish302835360001
    MITRE SECRETARIES LIMITED
    160 Aldersgate Street
    EC1A 4DD London
    Mitre House
    England
    Secretario corporativo
    160 Aldersgate Street
    EC1A 4DD London
    Mitre House
    England
    Tipo de identificaciónEEE
    Número de registro01447749
    38565160001
    BELL, Malcolm John
    Hillhead
    Lerwick
    ZE1 0HB Shetland
    Town Hall
    Scotland
    Director
    Hillhead
    Lerwick
    ZE1 0HB Shetland
    Town Hall
    Scotland
    United KingdomBritish170177780001
    BENNY, Neil Collington
    Pitt Terrace
    FK8 2ET Stirling
    Old Viewforth
    Scotland
    Director
    Pitt Terrace
    FK8 2ET Stirling
    Old Viewforth
    Scotland
    ScotlandBritish239782270001
    EVISON, Alison, Cllr
    Haymarket Yards
    EH12 5BH Edinburgh
    19
    Scotland
    Director
    Haymarket Yards
    EH12 5BH Edinburgh
    19
    Scotland
    ScotlandBritish238290750001
    FAWCETT, Aubrey
    Clyde Square
    PA15 1LY Greenock
    Municipal Buildings
    Scotland
    Director
    Clyde Square
    PA15 1LY Greenock
    Municipal Buildings
    Scotland
    ScotlandBritish265969000001
    FORSON, Ellen, Cllr
    Greenside Street
    FK10 1EB Alloa
    Kilncraigs
    Scotland
    Director
    Greenside Street
    FK10 1EB Alloa
    Kilncraigs
    Scotland
    ScotlandScottish302770250001
    GRIMMOND, Steven David
    Quarrywood Court
    Livingston Village
    EH54 6AZ Livingston
    I Hub
    Scotland
    Director
    Quarrywood Court
    Livingston Village
    EH54 6AZ Livingston
    I Hub
    Scotland
    ScotlandBritish42661190003
    HOUSTON, Graham, Cllr
    Haymarket Yards
    EH12 5BH Edinburgh
    Varity House
    Scotland
    Director
    Haymarket Yards
    EH12 5BH Edinburgh
    Varity House
    Scotland
    ScotlandBritish89134690001
    KERR, Andrew Cameron
    4 East Market Street
    EH8 8BG Edinburgh
    Waverley Court
    Scotland
    Director
    4 East Market Street
    EH8 8BG Edinburgh
    Waverley Court
    Scotland
    ScotlandBritish284956760001
    LEITCH, Angela Marie
    Quarrywood Court
    Livingston Village
    EH54 6AZ Livingston
    I Hub
    Scotland
    Director
    Quarrywood Court
    Livingston Village
    EH54 6AZ Livingston
    I Hub
    Scotland
    ScotlandBritish138521450001
    LONG, Louise
    Municipal Buildings
    Clyde Square
    PA15 1LY Greenock
    Inverclyde Council
    Scotland
    Director
    Municipal Buildings
    Clyde Square
    PA15 1LY Greenock
    Inverclyde Council
    Scotland
    ScotlandBritish305480910001
    LOUDEN, Sally
    c/o C/O Cosla
    Haymarket Yards
    EH12 5BH Edinburgh
    Verity House
    Scotland
    Director
    c/o C/O Cosla
    Haymarket Yards
    EH12 5BH Edinburgh
    Verity House
    Scotland
    ScotlandScottish214645990001
    MAIR, Colin Peter Caldwell
    7 Calderbankview Cottages
    ML6 9RE Airdrie
    Lanarkshire
    Director
    7 Calderbankview Cottages
    ML6 9RE Airdrie
    Lanarkshire
    ScotlandBritish96557280001
    MAIR, Roderick Ian Douglas
    The Old Stables
    Kincurdie
    IV10 8SJ Rosemarkie
    Ross Shire
    Director
    The Old Stables
    Kincurdie
    IV10 8SJ Rosemarkie
    Ross Shire
    ScotlandBritish106641550001
    MALONE, Bernadette
    Woodland Way
    DD2 5DZ Kingoodie
    8
    Dundee
    Director
    Woodland Way
    DD2 5DZ Kingoodie
    8
    Dundee
    ScotlandBritish265472170001
    MARTIN, David Robert
    Renfrewshire House
    Cotton Street
    PA1 1WB Paisley
    Renfrewshire Council
    Renfrewshire
    Scotland
    Director
    Renfrewshire House
    Cotton Street
    PA1 1WB Paisley
    Renfrewshire Council
    Renfrewshire
    Scotland
    United KingdomBritish167340580001
    MCCABE, Tom
    35 Orchard Brae
    ML3 6JD Hamilton
    Lanarkshire
    Director
    35 Orchard Brae
    ML3 6JD Hamilton
    Lanarkshire
    British106641540001
    MCMILLAN, Loraine
    Rouken Glen Road
    Giffnock
    G46 6UG Glasgow
    Council Hq
    Scotland
    Director
    Rouken Glen Road
    Giffnock
    G46 6UG Glasgow
    Council Hq
    Scotland
    ScotlandBritish284390600001
    MOWAT, Joanna, Cllr
    High Street
    EH1 1YJ Edinburgh
    City Chambers
    Scotland
    Director
    High Street
    EH1 1YJ Edinburgh
    City Chambers
    Scotland
    ScotlandBritish291632080002
    MURRAY, Elma
    Cunninghame House
    KA12 8EE Irvine
    Cunninghame House
    Ayrshire
    Scotland
    Director
    Cunninghame House
    KA12 8EE Irvine
    Cunninghame House
    Ayrshire
    Scotland
    ScotlandBritish167340720001
    MURRAY, Robert John, Councillor
    Beechgrove
    Monifieth
    DD5 4TE Dundee
    8
    Angus
    Director
    Beechgrove
    Monifieth
    DD5 4TE Dundee
    8
    Angus
    ScotlandBritish141011720001
    O'NEILL, David John Brian
    26 Norman Crescent
    KA12 8SB Irvine
    Ayrshire
    Director
    26 Norman Crescent
    KA12 8SB Irvine
    Ayrshire
    United KingdomBritish39193070001
    PARSONS, Ruth
    5 South Loanhead
    KY11 3LB Dunfermline
    Fife
    Director
    5 South Loanhead
    KY11 3LB Dunfermline
    Fife
    British118809390001
    PITCAITHLY, Mary Laird
    Greenhorn's Well Drive
    FK1 5HJ Falkirk
    Wellside, 15
    Stirlingshire
    Director
    Greenhorn's Well Drive
    FK1 5HJ Falkirk
    Wellside, 15
    Stirlingshire
    ScotlandBritish130837970001
    SCOTT, Angela
    Broad Street
    AB10 1AB Aberdeen
    Marischal College
    Scotland
    Director
    Broad Street
    AB10 1AB Aberdeen
    Marischal College
    Scotland
    ScotlandBritish265799720001
    SINCLAIR, Douglas
    1 Queens Road
    FK8 2QY Stirling
    Director
    1 Queens Road
    FK8 2QY Stirling
    British48820600001

    ¿Cuáles son las últimas declaraciones sobre personas con control significativo para IMPROVEMENT SERVICE COMPANY?

    Declaraciones de personas con control significativo
    Notificado elCesado elDeclaración
    19 jun 2018La empresa sabe o tiene motivos razonables para creer que no existe ninguna persona registrable o entidad jurídica relevante registrable en relación con la empresa.
    20 sept 201601 ene 2017La empresa sabe o tiene motivos razonables para creer que existe una persona registrable en relación con la empresa, pero no la ha identificado.

    Fuente de datos

    • Companies House del Reino Unido
      El registro oficial de empresas en el Reino Unido, que proporciona acceso público a información sobre empresas, como nombres, direcciones, administradores y registros financieros.
    • Licencia: CC0