EUROPEAN COMMERCIAL REAL ESTATE LIMITED
Visión general
| Nombre de la empresa | EUROPEAN COMMERCIAL REAL ESTATE LIMITED |
|---|---|
| Estado de la empresa | Liquidación |
| Forma jurídica | Sociedad de responsabilidad limitada |
| Número de empresa | SC291351 |
| Jurisdicción | Escocia |
| Fecha de constitución |
Resumen
| Tiene PSCs súper seguros | No |
|---|---|
| Tiene gravámenes | No |
| Tiene historial de insolvencia | Sí |
| La sede social está en disputa | No |
¿Cuál es el propósito de EUROPEAN COMMERCIAL REAL ESTATE LIMITED?
- Actividades de otras sociedades holding n.c.o.p. (64209) / Actividades financieras y de seguros
¿Dónde se encuentra EUROPEAN COMMERCIAL REAL ESTATE LIMITED?
| Dirección de la sede social | Cromwell Property Group Spaces, Lochrin Square, 1 Lochrin Square 92-98 Fountainbridge EH3 9QA Edinburgh United Kingdom |
|---|---|
| Dirección de la sede social no entregable | No |
¿Cuáles fueron los nombres anteriores de EUROPEAN COMMERCIAL REAL ESTATE LIMITED?
| Nombre de la empresa | Desde | Hasta |
|---|---|---|
| KENMORE EUROPE LIMITED | 27 oct 2005 | 27 oct 2005 |
| DALGLEN (NO. 1006) LIMITED | 06 oct 2005 | 06 oct 2005 |
¿Cuáles son las últimas cuentas de EUROPEAN COMMERCIAL REAL ESTATE LIMITED?
| Vencido | Sí |
|---|---|
| Próximas cuentas | |
| Próximo período contable finaliza el | 31 dic 2022 |
| Próximas cuentas vencen el | 30 sept 2023 |
| Últimas cuentas | |
| Últimas cuentas cerradas hasta | 31 dic 2021 |
¿Cuál es el estado de la última declaración de confirmación para EUROPEAN COMMERCIAL REAL ESTATE LIMITED?
| Vencido | Sí |
|---|---|
| Última declaración de confirmación cerrada hasta | 07 ene 2024 |
| Próxima declaración de confirmación vence | 21 ene 2024 |
| Última declaración de confirmación | |
| Próxima declaración de confirmación cerrada hasta | 07 ene 2023 |
| Vencido | Sí |
¿Cuáles son las últimas presentaciones para EUROPEAN COMMERCIAL REAL ESTATE LIMITED?
| Fecha | Descripción | Documento | Tipo | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cuenta final antes de la disolución en MVL (cuenta final adjunta) | 10 páginas | LIQ13(Scot) | ||||||||||||||||||||||
Cese del nombramiento de Cromwell Corporate Secretarial Limited como secretario el 24 dic 2024 | 1 páginas | TM02 | ||||||||||||||||||||||
Cese del nombramiento de Cromwell Director Limited como director el 24 dic 2024 | 1 páginas | TM01 | ||||||||||||||||||||||
Cese del nombramiento de Timothy William Sewell como director el 24 dic 2024 | 1 páginas | TM01 | ||||||||||||||||||||||
Modification des détails de Ga Minor Lp Investor Limited en tant que personne disposant d'un contrôle significatif le 09 mar 2023 | 2 páginas | PSC05 | ||||||||||||||||||||||
Cessation de Cromwell Capital Ventures Uk Limited en tant que personne disposant d'un contrôle significatif le 21 ago 2024 | 1 páginas | PSC07 | ||||||||||||||||||||||
Resoluciones Resolutions | 1 páginas | RESOLUTIONS | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
Cambio de datos del director Mr Timothy William Sewell el 10 may 2023 | 2 páginas | CH01 | ||||||||||||||||||||||
Cambio de datos del director Cromwell Director Limited el 10 may 2023 | 1 páginas | CH02 | ||||||||||||||||||||||
Modification des détails de Ga Minor Lp Investor Limited en tant que personne disposant d'un contrôle significatif le 10 may 2023 | 2 páginas | PSC05 | ||||||||||||||||||||||
Modification des détails de Cromwell Capital Ventures Uk Limited en tant que personne disposant d'un contrôle significatif le 10 may 2023 | 2 páginas | PSC05 | ||||||||||||||||||||||
Estado de capital tras una asignación de acciones el 09 mar 2023
| 4 páginas | SH01 | ||||||||||||||||||||||
Estado de capital tras una asignación de acciones el 09 mar 2023
| 4 páginas | SH01 | ||||||||||||||||||||||
Resoluciones Resolutions | 2 páginas | RESOLUTIONS | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
Memorándum y Estatutos | 27 páginas | MA | ||||||||||||||||||||||
Declaración de confirmación presentada el 07 ene 2023 sin actualizaciones | 3 páginas | CS01 | ||||||||||||||||||||||
Cuentas de exención total completas preparadas hasta el 31 dic 2021 | 16 páginas | AA | ||||||||||||||||||||||
Cancelación total de la carga 1 | 1 páginas | MR04 | ||||||||||||||||||||||
Cancelación total de la carga 2 | 1 páginas | MR04 | ||||||||||||||||||||||
Cancelación total de la carga 3 | 1 páginas | MR04 | ||||||||||||||||||||||
Cancelación total de la carga 4 | 1 páginas | MR04 | ||||||||||||||||||||||
Cancelación total de la carga 6 | 1 páginas | MR04 | ||||||||||||||||||||||
Cancelación total de la carga 9 | 1 páginas | MR04 | ||||||||||||||||||||||
Cancelación total de la carga 8 | 1 páginas | MR04 | ||||||||||||||||||||||
Cancelación total de la carga 5 | 1 páginas | MR04 | ||||||||||||||||||||||
¿Quiénes son los directivos de EUROPEAN COMMERCIAL REAL ESTATE LIMITED?
| Nombre | Nombrado el | Renunció el | Rol | Dirección | Identificación de la empresa | País de residencia | Nacionalidad | Fecha de nacimiento | Ocupación | Número | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BROWN, John Kenneth | Secretario | 44 Beech Avenue Newton Mearns G77 5QP Glasgow Lanarkshire | British | 111592160001 | ||||||||||
| MCCALL, Peter Michael | Secretario | 19 Bonaly Terrace EH13 0EL Edinburgh Midlothian | British | 119269620001 | ||||||||||
| CROMWELL CORPORATE SECRETARIAL LIMITED | Secretario corporativo | Spaces, Lochrin Square, 1 Lochrin Square 92-98 Fountainbridge EH3 9QA Edinburgh Cromwell Property Group United Kingdom |
| 133355520004 | ||||||||||
| DALGLEN SECRETARIES LIMITED | Secretario designado corporativo | Dalmore House 310 St Vincent Street G2 5QR Glasgow Strathclyde | 900015270001 | |||||||||||
| BRADLEY, Pauline Anne | Director | Spruce Tree House By Gleneagles PH4 1RG Auchterarder Perthshire | British | 122926460001 | ||||||||||
| BROOK, Robert William Middleton | Director | Ashchurch Park Villas W12 9SP London 9 | United Kingdom | British | 59050120004 | |||||||||
| CARRINGTON, Mark James | Director | Floor Unit 16 Manor Court Business Park YO11 3TU Scarborough 1st United Kingdom | United Kingdom | British | 162638140001 | |||||||||
| CORSTORPHINE, Iain Anderson | Director | 8 Willow Tree Place EH14 5AZ Balerno Midlothian | British | 105798020001 | ||||||||||
| COTTERELL, Robert James | Director | Unit 16 Manor Court Business Park YO11 3TU Scarborough 1st Floor United Kingdom | United Kingdom | British | 172401090002 | |||||||||
| DARLING, Andrew David | Director | 4 Grange Knowe EH49 7HX Linlithgow West Lothian | British | 73218540001 | ||||||||||
| GERVASI, Pierre Rene | Director | 16 Rue Suzanne 95600 Eaubonne 95600 France | French | 109596850001 | ||||||||||
| KENNEDY, Johann | Director | 46 Cammo Gardens EH4 8EG Edinburgh Midlothian | United Kingdom | British | 119260990001 | |||||||||
| KENNEDY, John Anthony Bingham | Director | Newhall Carlops EH26 9LY Penicuik Midlothian | Scotland | British | 71043680001 | |||||||||
| LANEFELT, Stefan Johan | Director | Floor Unit 16 Manor Court Business Park YO11 3TU Scarborough 1st United Kingdom | Sweden | Swedish | 158909670001 | |||||||||
| LELEU, Thierry Hubert Francois | Director | Unit 16 Manor Court Business Park YO11 3TU Scarborough 1st Floor United Kingdom | United Kingdom | French | 178701910001 | |||||||||
| MCCABE, Gary John | Director | Cleuch Avenue EH23 4RP North Middleton 6 Midlothian | Scotland | British | 139525550001 | |||||||||
| MCCABE, Gary John | Director | Deutschherrnufer 45 Frankfurt Am Main 60594 Germany | British | 133465930001 | ||||||||||
| MCCARTHY, Martyn James | Director | Floor Unit 16 Manor Court Business Park YO11 3TU Scarborough 1st United Kingdom | United Kingdom | Australian | 126149680033 | |||||||||
| MCDONALD, Derek | Director | 8 Glen Sannox Grove Craigmarloch G68 0GH Cumbernauld | Scotland | British | 190466700001 | |||||||||
| MORE, Gordon Lennie Truman | Director | Paseo De Peru 51 Cuidalcampo 28707 Madrid Spain | British | 111414890001 | ||||||||||
| PETTIT, Andrew John | Director | Balderton Street W1K 6TL London 20 | England | British | 62947400004 | |||||||||
| SEWELL, Timothy William | Director | Minerva House 29 East Parade LS1 5PS Leeds 5th Floor England | United Kingdom | British | 154627410001 | |||||||||
| SHIELS, Paul | Director | 60311 Frankfurt Am Main Frankfurt Goetheplatz 4 Germany | Germany | British | 136088930001 | |||||||||
| SIME, Fraser Mckenzie | Director | Wilton Road EH16 5NN Edinburgh 29 Midlothian | United Kingdom | British | 200848420001 | |||||||||
| CROMWELL DIRECTOR LIMITED | Director corporativo | Minerva House 29 East Parade LS1 5PS Leeds 5th Floor England |
| 102622300003 | ||||||||||
| DALGLEN DIRECTORS LIMITED | Director designado corporativo | Dalmore House 310 St Vincent Street G2 5QR Glasgow Strathclyde | 900015260001 |
¿Quiénes son las personas con control significativo de EUROPEAN COMMERCIAL REAL ESTATE LIMITED?
| Nombre | Notificado el | Dirección | Cesado | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cromwell Capital Ventures Uk Limited | 06 abr 2016 | Minerva House 29 East Parade LS1 5PS Leeds 5th Floor England | Sí | ||||||||||
| |||||||||||||
Naturaleza del control
| |||||||||||||
| Ga Minor Lp Investor Limited | 06 abr 2016 | Minerva House 29 East Parade LS1 5PS Leeds 5th Floor England | No | ||||||||||
| |||||||||||||
Naturaleza del control
| |||||||||||||
¿Tiene EUROPEAN COMMERCIAL REAL ESTATE LIMITED algún caso de insolvencia?
| Número de expediente | Fechas | Tipo | Profesionales | Otro | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
| Liquidación voluntaria de socios |
|
|
Fuente de datos
- Companies House del Reino Unido
El registro oficial de empresas en el Reino Unido, que proporciona acceso público a información sobre empresas, como nombres, direcciones, administradores y registros financieros. - Licencia: CC0