EUROPEAN COMMERCIAL REAL ESTATE LIMITED

EUROPEAN COMMERCIAL REAL ESTATE LIMITED

  • Visión general
  • Resumen
  • Propósito
  • Dirección
  • Nombres anteriores
  • Cuentas
  • Declaración de confirmación
  • Presentaciones
  • Directivos
  • Personas con control significativo
  • Gravámenes
  • Insolvencia
  • Fuente de datos
  • Visión general

    Nombre de la empresaEUROPEAN COMMERCIAL REAL ESTATE LIMITED
    Estado de la empresaLiquidación
    Forma jurídicaSociedad de responsabilidad limitada
    Número de empresa SC291351
    JurisdicciónEscocia
    Fecha de constitución

    Resumen

    Tiene PSCs súper segurosNo
    Tiene gravámenes
    Tiene historial de insolvencia
    La sede social está en disputaNo

    ¿Cuál es el propósito de EUROPEAN COMMERCIAL REAL ESTATE LIMITED?

    • Actividades de otras sociedades holding n.c.o.p. (64209) / Actividades financieras y de seguros

    ¿Dónde se encuentra EUROPEAN COMMERCIAL REAL ESTATE LIMITED?

    Dirección de la sede social
    Cromwell Property Group Spaces, Lochrin Square, 1 Lochrin Square
    92-98 Fountainbridge
    EH3 9QA Edinburgh
    United Kingdom
    Dirección de la sede social no entregableNo

    ¿Cuáles fueron los nombres anteriores de EUROPEAN COMMERCIAL REAL ESTATE LIMITED?

    Nombres anteriores de la empresa
    Nombre de la empresaDesdeHasta
    KENMORE EUROPE LIMITED27 oct 200527 oct 2005
    DALGLEN (NO. 1006) LIMITED06 oct 200506 oct 2005

    ¿Cuáles son las últimas cuentas de EUROPEAN COMMERCIAL REAL ESTATE LIMITED?

    Vencido
    Próximas cuentas
    Próximo período contable finaliza el31 dic 2022
    Próximas cuentas vencen el30 sept 2023
    Últimas cuentas
    Últimas cuentas cerradas hasta31 dic 2021

    ¿Cuál es el estado de la última declaración de confirmación para EUROPEAN COMMERCIAL REAL ESTATE LIMITED?

    Vencido
    Última declaración de confirmación cerrada hasta07 ene 2024
    Próxima declaración de confirmación vence21 ene 2024
    Última declaración de confirmación
    Próxima declaración de confirmación cerrada hasta07 ene 2023
    Vencido

    ¿Cuáles son las últimas presentaciones para EUROPEAN COMMERCIAL REAL ESTATE LIMITED?

    Presentaciones
    FechaDescripciónDocumentoTipo

    Cese del nombramiento de Cromwell Corporate Secretarial Limited como secretario el 24 dic 2024

    1 páginasTM02

    Cese del nombramiento de Cromwell Director Limited como director el 24 dic 2024

    1 páginasTM01

    Cese del nombramiento de Timothy William Sewell como director el 24 dic 2024

    1 páginasTM01

    Modification des détails de Ga Minor Lp Investor Limited en tant que personne disposant d'un contrôle significatif le 09 mar 2023

    2 páginasPSC05

    Cessation de Cromwell Capital Ventures Uk Limited en tant que personne disposant d'un contrôle significatif le 21 ago 2024

    1 páginasPSC07

    Resoluciones

    Resolutions
    1 páginasRESOLUTIONS
    Acuerdos
    CategoríaFechaDescripciónTipo
    liquidation

    Acuerdo especial para la liquidación el 13 jun 2023

    LRESSP

    Cambio de datos del director Mr Timothy William Sewell el 10 may 2023

    2 páginasCH01

    Cambio de datos del director Cromwell Director Limited el 10 may 2023

    1 páginasCH02

    Modification des détails de Ga Minor Lp Investor Limited en tant que personne disposant d'un contrôle significatif le 10 may 2023

    2 páginasPSC05

    Modification des détails de Cromwell Capital Ventures Uk Limited en tant que personne disposant d'un contrôle significatif le 10 may 2023

    2 páginasPSC05

    Estado de capital tras una asignación de acciones el 09 mar 2023

    • Capital: EUR 213,147,710
    4 páginasSH01

    Estado de capital tras una asignación de acciones el 09 mar 2023

    • Capital: EUR 105,238,755
    4 páginasSH01

    Resoluciones

    Resolutions
    2 páginasRESOLUTIONS
    Acuerdos
    CategoríaFechaDescripciónTipo
    capital

    Resoluciones

    Authorised share capital be increased, that this resolution constitutes the prior written consent to issue shares 28/02/2023
    RES13
    capital

    Resolución de eliminación de derechos de suscripción preferente

    RES11
    incorporation

    Resolución de adopción de los Artículos de Asociación

    RES01
    capital

    Resolución de asignación de valores

    RES10

    Memorándum y Estatutos

    27 páginasMA

    Declaración de confirmación presentada el 07 ene 2023 sin actualizaciones

    3 páginasCS01

    Cuentas de exención total completas preparadas hasta el 31 dic 2021

    16 páginasAA

    Cancelación total de la carga 1

    1 páginasMR04

    Cancelación total de la carga 2

    1 páginasMR04

    Cancelación total de la carga 3

    1 páginasMR04

    Cancelación total de la carga 4

    1 páginasMR04

    Cancelación total de la carga 6

    1 páginasMR04

    Cancelación total de la carga 9

    1 páginasMR04

    Cancelación total de la carga 8

    1 páginasMR04

    Cancelación total de la carga 5

    1 páginasMR04

    Cancelación total de la carga 7

    1 páginasMR04

    ¿Quiénes son los directivos de EUROPEAN COMMERCIAL REAL ESTATE LIMITED?

    Directivos
    NombreNombrado elRenunció elRolDirecciónIdentificación de la empresaPaís de residenciaNacionalidadFecha de nacimientoOcupaciónNúmero
    BROWN, John Kenneth
    44 Beech Avenue
    Newton Mearns
    G77 5QP Glasgow
    Lanarkshire
    Secretario
    44 Beech Avenue
    Newton Mearns
    G77 5QP Glasgow
    Lanarkshire
    British111592160001
    MCCALL, Peter Michael
    19 Bonaly Terrace
    EH13 0EL Edinburgh
    Midlothian
    Secretario
    19 Bonaly Terrace
    EH13 0EL Edinburgh
    Midlothian
    British119269620001
    CROMWELL CORPORATE SECRETARIAL LIMITED
    Spaces, Lochrin Square, 1 Lochrin Square
    92-98 Fountainbridge
    EH3 9QA Edinburgh
    Cromwell Property Group
    United Kingdom
    Secretario corporativo
    Spaces, Lochrin Square, 1 Lochrin Square
    92-98 Fountainbridge
    EH3 9QA Edinburgh
    Cromwell Property Group
    United Kingdom
    Tipo de identificaciónSociedad limitada del Reino Unido
    Número de registroSC219311
    133355520004
    DALGLEN SECRETARIES LIMITED
    Dalmore House
    310 St Vincent Street
    G2 5QR Glasgow
    Strathclyde
    Secretario designado corporativo
    Dalmore House
    310 St Vincent Street
    G2 5QR Glasgow
    Strathclyde
    900015270001
    BRADLEY, Pauline Anne
    Spruce Tree House
    By Gleneagles
    PH4 1RG Auchterarder
    Perthshire
    Director
    Spruce Tree House
    By Gleneagles
    PH4 1RG Auchterarder
    Perthshire
    British122926460001
    BROOK, Robert William Middleton
    Ashchurch Park Villas
    W12 9SP London
    9
    Director
    Ashchurch Park Villas
    W12 9SP London
    9
    United KingdomBritish59050120004
    CARRINGTON, Mark James
    Floor
    Unit 16 Manor Court Business Park
    YO11 3TU Scarborough
    1st
    United Kingdom
    Director
    Floor
    Unit 16 Manor Court Business Park
    YO11 3TU Scarborough
    1st
    United Kingdom
    United KingdomBritish162638140001
    CORSTORPHINE, Iain Anderson
    8 Willow Tree Place
    EH14 5AZ Balerno
    Midlothian
    Director
    8 Willow Tree Place
    EH14 5AZ Balerno
    Midlothian
    British105798020001
    COTTERELL, Robert James
    Unit 16
    Manor Court Business Park
    YO11 3TU Scarborough
    1st Floor
    United Kingdom
    Director
    Unit 16
    Manor Court Business Park
    YO11 3TU Scarborough
    1st Floor
    United Kingdom
    United KingdomBritish172401090002
    DARLING, Andrew David
    4 Grange Knowe
    EH49 7HX Linlithgow
    West Lothian
    Director
    4 Grange Knowe
    EH49 7HX Linlithgow
    West Lothian
    British73218540001
    GERVASI, Pierre Rene
    16 Rue Suzanne
    95600 Eaubonne
    95600
    France
    Director
    16 Rue Suzanne
    95600 Eaubonne
    95600
    France
    French109596850001
    KENNEDY, Johann
    46 Cammo Gardens
    EH4 8EG Edinburgh
    Midlothian
    Director
    46 Cammo Gardens
    EH4 8EG Edinburgh
    Midlothian
    United KingdomBritish119260990001
    KENNEDY, John Anthony Bingham
    Newhall
    Carlops
    EH26 9LY Penicuik
    Midlothian
    Director
    Newhall
    Carlops
    EH26 9LY Penicuik
    Midlothian
    ScotlandBritish71043680001
    LANEFELT, Stefan Johan
    Floor
    Unit 16 Manor Court Business Park
    YO11 3TU Scarborough
    1st
    United Kingdom
    Director
    Floor
    Unit 16 Manor Court Business Park
    YO11 3TU Scarborough
    1st
    United Kingdom
    SwedenSwedish158909670001
    LELEU, Thierry Hubert Francois
    Unit 16
    Manor Court Business Park
    YO11 3TU Scarborough
    1st Floor
    United Kingdom
    Director
    Unit 16
    Manor Court Business Park
    YO11 3TU Scarborough
    1st Floor
    United Kingdom
    United KingdomFrench178701910001
    MCCABE, Gary John
    Cleuch Avenue
    EH23 4RP North Middleton
    6
    Midlothian
    Director
    Cleuch Avenue
    EH23 4RP North Middleton
    6
    Midlothian
    ScotlandBritish139525550001
    MCCABE, Gary John
    Deutschherrnufer 45
    Frankfurt Am Main
    60594
    Germany
    Director
    Deutschherrnufer 45
    Frankfurt Am Main
    60594
    Germany
    British133465930001
    MCCARTHY, Martyn James
    Floor
    Unit 16 Manor Court Business Park
    YO11 3TU Scarborough
    1st
    United Kingdom
    Director
    Floor
    Unit 16 Manor Court Business Park
    YO11 3TU Scarborough
    1st
    United Kingdom
    United KingdomAustralian126149680033
    MCDONALD, Derek
    8 Glen Sannox Grove
    Craigmarloch
    G68 0GH Cumbernauld
    Director
    8 Glen Sannox Grove
    Craigmarloch
    G68 0GH Cumbernauld
    ScotlandBritish190466700001
    MORE, Gordon Lennie Truman
    Paseo De Peru 51 Cuidalcampo
    28707 Madrid
    Spain
    Director
    Paseo De Peru 51 Cuidalcampo
    28707 Madrid
    Spain
    British111414890001
    PETTIT, Andrew John
    Balderton Street
    W1K 6TL London
    20
    Director
    Balderton Street
    W1K 6TL London
    20
    EnglandBritish62947400004
    SEWELL, Timothy William
    Minerva House
    29 East Parade
    LS1 5PS Leeds
    5th Floor
    England
    Director
    Minerva House
    29 East Parade
    LS1 5PS Leeds
    5th Floor
    England
    United KingdomBritish154627410001
    SHIELS, Paul
    60311 Frankfurt Am Main
    Frankfurt
    Goetheplatz 4
    Germany
    Director
    60311 Frankfurt Am Main
    Frankfurt
    Goetheplatz 4
    Germany
    GermanyBritish136088930001
    SIME, Fraser Mckenzie
    Wilton Road
    EH16 5NN Edinburgh
    29
    Midlothian
    Director
    Wilton Road
    EH16 5NN Edinburgh
    29
    Midlothian
    United KingdomBritish200848420001
    CROMWELL DIRECTOR LIMITED
    Minerva House
    29 East Parade
    LS1 5PS Leeds
    5th Floor
    England
    Director corporativo
    Minerva House
    29 East Parade
    LS1 5PS Leeds
    5th Floor
    England
    Tipo de identificaciónSociedad limitada del Reino Unido
    Número de registro5307786
    102622300003
    DALGLEN DIRECTORS LIMITED
    Dalmore House
    310 St Vincent Street
    G2 5QR Glasgow
    Strathclyde
    Director designado corporativo
    Dalmore House
    310 St Vincent Street
    G2 5QR Glasgow
    Strathclyde
    900015260001

    ¿Quiénes son las personas con control significativo de EUROPEAN COMMERCIAL REAL ESTATE LIMITED?

    Personas con control significativo
    NombreNotificado elDirecciónCesado
    Cromwell Capital Ventures Uk Limited
    Minerva House
    29 East Parade
    LS1 5PS Leeds
    5th Floor
    England
    06 abr 2016
    Minerva House
    29 East Parade
    LS1 5PS Leeds
    5th Floor
    England
    Forma jurídicaLimited By Shares
    País de registroUnited Kingdom
    Autoridad legalCompanies Act 2006
    Lugar de registroEngland And Wales
    Número de registro4329031
    Naturaleza del control
    • La persona posee, directa o indirectamente, más del 25% pero no más del 50% de las acciones de la compañía.
    • La persona posee, directa o indirectamente, más del 25% pero no más del 50% de los derechos de voto en la empresa.
    Ga Minor Lp Investor Limited
    Minerva House
    29 East Parade
    LS1 5PS Leeds
    5th Floor
    England
    06 abr 2016
    Minerva House
    29 East Parade
    LS1 5PS Leeds
    5th Floor
    England
    No
    Forma jurídicaLimited By Shares
    País de registroUnited Kingdom
    Autoridad legalCompanies Act 2006
    Lugar de registroEngland And Wales
    Número de registro8151647
    Naturaleza del control
    • La persona posee, directa o indirectamente, más del 25% pero no más del 50% de las acciones de la compañía.
    • La persona posee, directa o indirectamente, más del 25% pero no más del 50% de los derechos de voto en la empresa.

    ¿Tiene EUROPEAN COMMERCIAL REAL ESTATE LIMITED alguna carga?

    Gravámenes
    ClasificaciónFechasEstadoDetalles
    Share pledge agreement
    Creado el 06 nov 2008
    Entregado el 12 nov 2008
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All sums due or to become due
    Breve descripción
    First-ranking pledge over the pledged assets.
    Personas con derecho
    • Bank of Scotland PLC
    Transacciones
    • 12 nov 2008Registro de un cargo (410)
    • 26 ago 2022Satisfacción de una carga (MR04)
    Share pledge
    Creado el 06 ago 2007
    Entregado el 24 ago 2007
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All sums due or to become due
    Breve descripción
    The pledgors irrevocably and unconditionally grant a continuing first ranking pledge and security interest in favour of the pledgee over the pledged assets for the payment and discharge of all the secured obligations and the pledgee accepts the pledge. The pledge shall also cover any future extension of the secured obligations.
    Personas con derecho
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transacciones
    • 24 ago 2007Registro de un cargo (410)
    • 26 ago 2022Satisfacción de una carga (MR04)
    Share pledge
    Creado el 14 jun 2007
    Entregado el 28 jun 2007
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All sums due or to become due
    Breve descripción
    The pledgors irrevocably and unconditionally grant a continuing first-ranking pledge and security interest in favour of the pledgee over the pledged assets for the payment and discharge of all the secured obligations and the pledgee accepts the pledge. The pledge shall also cover any future extension of the secured obligations.
    Personas con derecho
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transacciones
    • 28 jun 2007Registro de un cargo (410)
    • 26 ago 2022Satisfacción de una carga (MR04)
    Share pledge agreement
    Creado el 03 abr 2007
    Entregado el 16 abr 2007
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All sums due or to become due
    Breve descripción
    The shares and related rights.
    Personas con derecho
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transacciones
    • 16 abr 2007Registro de un cargo (410)
    • 26 ago 2022Satisfacción de una carga (MR04)
    Bond & floating charge
    Creado el 16 mar 2007
    Entregado el 22 mar 2007
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All sums due or to become due
    Breve descripción
    Undertaking and all property and assets present and future of the company including uncalled capital.
    Contiene una garantía flotante:
    Personas con derecho
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transacciones
    • 22 mar 2007Registro de un cargo (410)
    • 26 ago 2022Satisfacción de una carga (MR04)
    Amendment agreement to the pledge agreement
    Creado el 20 dic 2006
    Entregado el 08 ene 2007
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All sums due or to become due
    Breve descripción
    The pledged assets.
    Personas con derecho
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transacciones
    • 08 ene 2007Registro de un cargo (410)
    • 26 ago 2022Satisfacción de una carga (MR04)
    Share pledge agreement
    Creado el 12 jul 2006
    Entregado el 01 ago 2006
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All sums due or to become due
    Breve descripción
    The pledgor irrevocably and unconditionally grants a continuing first-ranking pledge and security interest in favour of the pledge over the pledged assets for the payment and discharge of all the secured obligations and the pledgee accepts the pledge - see form 410.
    Personas con derecho
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transacciones
    • 01 ago 2006Registro de un cargo (410)
    • 26 ago 2022Satisfacción de una carga (MR04)
    Share pledge agreement
    Creado el 04 nov 2005
    Entregado el 14 nov 2005
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All sums due or to become due
    Breve descripción
    The shares and related assets.
    Personas con derecho
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland as Security Agent
    Transacciones
    • 14 nov 2005Registro de un cargo (410)
    • 26 ago 2022Satisfacción de una carga (MR04)
    Floating charge
    Creado el 04 nov 2005
    Entregado el 08 nov 2005
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All sums due or to become due
    Breve descripción
    Undertaking and all property and assets present and future of the company including uncalled capital.
    Contiene una garantía flotante:
    Personas con derecho
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transacciones
    • 08 nov 2005Registro de un cargo (410)
    • 26 ago 2022Satisfacción de una carga (MR04)

    ¿Tiene EUROPEAN COMMERCIAL REAL ESTATE LIMITED algún caso de insolvencia?

    Número de expedienteFechasTipoProfesionalesOtro
    1
    FechaTipo
    13 jun 2023Inicio de la liquidación
    Liquidación voluntaria de socios
    NombreRolDirecciónNombrado elCesado el
    Notasscottish-insolvency-info

    Fuente de datos

    • Companies House del Reino Unido
      El registro oficial de empresas en el Reino Unido, que proporciona acceso público a información sobre empresas, como nombres, direcciones, administradores y registros financieros.
    • Licencia: CC0