STIRLING GATEWAY HC LIMITED
Visión general
| Nombre de la empresa | STIRLING GATEWAY HC LIMITED |
|---|---|
| Estado de la empresa | Activa |
| Forma jurídica | Sociedad de responsabilidad limitada |
| Número de empresa | SC293273 |
| Jurisdicción | Escocia |
| Fecha de constitución |
Resumen
| Tiene PSCs súper seguros | No |
|---|---|
| Tiene gravámenes | No |
| Tiene historial de insolvencia | No |
| La sede social está en disputa | No |
¿Cuál es el propósito de STIRLING GATEWAY HC LIMITED?
- Otras actividades de apoyo a los negocios n.c.p. (82990) / Actividades administrativas y de apoyo
¿Dónde se encuentra STIRLING GATEWAY HC LIMITED?
| Dirección de la sede social | C/O Infrastructure Managers Limited 2nd Floor Drum Saltire Court 20 Castle Terrace EH1 2EN Edinburgh United Kingdom |
|---|---|
| Dirección de la sede social no entregable | No |
¿Cuáles fueron los nombres anteriores de STIRLING GATEWAY HC LIMITED?
| Nombre de la empresa | Desde | Hasta |
|---|---|---|
| MM&S (5046) LIMITED | 17 nov 2005 | 17 nov 2005 |
¿Cuáles son las últimas cuentas de STIRLING GATEWAY HC LIMITED?
| Vencido | No |
|---|---|
| Próximas cuentas | |
| Próximo período contable finaliza el | 31 mar 2026 |
| Próximas cuentas vencen el | 31 dic 2026 |
| Últimas cuentas | |
| Últimas cuentas cerradas hasta | 31 mar 2025 |
¿Cuál es el estado de la última declaración de confirmación para STIRLING GATEWAY HC LIMITED?
| Última declaración de confirmación cerrada hasta | 19 nov 2026 |
|---|---|
| Próxima declaración de confirmación vence | 03 dic 2026 |
| Última declaración de confirmación | |
| Próxima declaración de confirmación cerrada hasta | 19 nov 2025 |
| Vencido | No |
¿Cuáles son las últimas presentaciones para STIRLING GATEWAY HC LIMITED?
| Fecha | Descripción | Documento | Tipo | |
|---|---|---|---|---|
Cambio de datos del director Mr Kevin Alistair Cunningham el 07 ene 2026 | 2 páginas | CH01 | ||
Declaración de confirmación presentada el 19 nov 2025 sin actualizaciones | 3 páginas | CS01 | ||
Nombramiento de Mr Kevin Alistair Cunningham como director el 03 nov 2025 | 2 páginas | AP01 | ||
Cuentas completas preparadas hasta el 31 mar 2025 | 20 páginas | AA | ||
Cese del nombramiento de Glenn Sinclair Pearce como director el 07 ago 2025 | 1 páginas | TM01 | ||
Modification des détails de Pfi Infrastructure Finance Limited en tant que personne disposant d'un contrôle significatif le 17 feb 2025 | 2 páginas | PSC05 | ||
Nombramiento de Mrs Claire Agnes Mcinally como director el 06 feb 2025 | 2 páginas | AP01 | ||
Cese del nombramiento de Alison Groat como director el 06 feb 2025 | 1 páginas | TM01 | ||
Cambio de datos del secretario Infrastructure Managers Limited el 17 feb 2025 | 1 páginas | CH04 | ||
Cambio de datos del director Mr Stewart William Small el 25 nov 2024 | 2 páginas | CH01 | ||
Declaración de confirmación presentada el 19 nov 2024 sin actualizaciones | 3 páginas | CS01 | ||
Cese del nombramiento de Kirsty O'brien como director el 13 nov 2024 | 1 páginas | TM01 | ||
Nombramiento de Mr Glenn Sinclair Pearce como director el 13 nov 2024 | 2 páginas | AP01 | ||
Cuentas completas preparadas hasta el 31 mar 2024 | 22 páginas | AA | ||
Nombramiento de Mr Josh Callum Bond como director el 08 may 2024 | 2 páginas | AP01 | ||
Cese del nombramiento de John Ivor Cavill como director el 08 may 2024 | 1 páginas | TM01 | ||
Cambio de datos del director Mr John Ivor Cavill el 04 ene 2024 | 2 páginas | CH01 | ||
Cambio de datos del director Mr Carl Harvey Dix el 04 ene 2024 | 2 páginas | CH01 | ||
Domicilio social registrado cambiado de 1 George Square Glasgow G2 1AL Scotland a C/O Infrastructure Managers Limited 2nd Floor Drum Saltire Court 20 Castle Terrace Edinburgh EH1 2EN el 16 ene 2024 | 1 páginas | AD01 | ||
Nombramiento de Infrastructure Managers Limited como secretario el 04 ene 2024 | 2 páginas | AP04 | ||
Cese del nombramiento de Dentons Secretaries Limited como secretario el 04 ene 2024 | 1 páginas | TM02 | ||
Nombramiento de Alison Groat como director el 01 dic 2023 | 2 páginas | AP01 | ||
Cese del nombramiento de David Niall Smith como director el 01 dic 2023 | 1 páginas | TM01 | ||
Declaración de confirmación presentada el 17 nov 2023 sin actualizaciones | 3 páginas | CS01 | ||
Cuentas completas preparadas hasta el 31 mar 2023 | 22 páginas | AA | ||
¿Quiénes son los directivos de STIRLING GATEWAY HC LIMITED?
| Nombre | Nombrado el | Renunció el | Rol | Dirección | Identificación de la empresa | País de residencia | Nacionalidad | Fecha de nacimiento | Ocupación | Número | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INFRASTRUCTURE MANAGERS LIMITED | Secretario corporativo | 6 Kean Street WC2B 4AS London 8th Floor United Kingdom |
| 128530180002 | ||||||||||||||
| BOND, Josh Callum | Director | 2nd Floor Drum Suite, Saltire Court 20 Castle Terrace EH1 2EN Edinburgh Infrastructure Managers Limited United Kingdom | United Kingdom | British | 257016670001 | |||||||||||||
| CUNNINGHAM, Kevin Alistair | Director | Saltire Court 20 Castle Terrace EH1 2EN Edinburgh C/O Infrastructure Managers Limited 2nd Floor Drum United Kingdom | United Kingdom | Scottish | 271263600001 | |||||||||||||
| DIX, Carl Harvey | Director | 2nd Floor Drum Suite, Saltire Court 20 Castle Terrace EH1 2EN Edinburgh C/O Infrastructure Managers Limited United Kingdom | United Kingdom | British | 305019190001 | |||||||||||||
| MCINALLY, Claire Agnes | Director | Pirnhall Business Park FK7 8HW Stirling Forth House United Kingdom | United Kingdom | British | 167317960001 | |||||||||||||
| SMALL, Stewart William | Director | Cobalt Square 83-85 Hagley Road B16 8QG Birmingham 9th Floor United Kingdom | United Kingdom | British | 302497750001 | |||||||||||||
| SPILLER, David Robert | Director | 1 Craiglockhart Drive North EH14 1HS Edinburgh Midlothian | United Kingdom | British | 97470220001 | |||||||||||||
| DENTONS SECRETARIES LIMITED | Secretario corporativo | EC4M 7WS London One Fleet Place England England |
| 98515470015 | ||||||||||||||
| MACLAY MURRAY & SPENS LLP | Secretario designado corporativo | George Square G2 1AL Glasgow 1 United Kingdom |
| 900003400001 | ||||||||||||||
| ALLISON, Glenn Fraser Whyte | Director | Linden Beeches 442 North Deeside Road AB15 9ET Cults Aberdeenshire | United Kingdom | British | 63687770002 | |||||||||||||
| BRADLEY, Victoria | Director | Quartermile One 15 Lauriston Place EH3 9EP Edinburgh | England | British | 149161230001 | |||||||||||||
| BREMNER, Alexander George | Director | Inch Avenue Aberdour KY3 0TF Burntisland 3 Fife | Scotland | British | 152806580001 | |||||||||||||
| CAVILL, John Ivor | Director | 2nd Floor Drum Suite, Saltire Court 20 Castle Terrace EH1 2EN Edinburgh C/O Infrastructure Managers Limited United Kingdom | United Kingdom | British | 152521640009 | |||||||||||||
| ELLIOT, John Christian | Director | 1 Hope Terrace EH9 2AP Edinburgh Midlothian | United Kingdom | British | 184790001 | |||||||||||||
| FLETCHER, Dylan | Director | Croftlea 50 Kenilworth Road Bridge Of Allan FK9 4RS Stirling Stirlingshire | Scotland | British | 82097010004 | |||||||||||||
| GILMOUR, David Fulton | Director | 15 Lauriston Place EH3 9EP Edinburgh Quartermile One United Kingdom | United Kingdom | British | 158508150001 | |||||||||||||
| GROAT, Alison | Director | Pirnhall Business Park FK7 8HW Stirling Forth House Scotland | Scotland | British | 316594510001 | |||||||||||||
| JACK, Ronald Gilfillan | Director | Pirnhall Business Park FK7 8ES Stirling Ogilvie House Scotland Scotland | Scotland | British | 76530270002 | |||||||||||||
| JACK, Ronald Gilfillan | Director | Preston House Gardens EH49 6PZ Linlithgow 3 Scotland United Kingdom | Scotland | British | 76530270002 | |||||||||||||
| KING, Allan Duncan | Director | The Birkins Muirton PH3 1ND Auchterarder Perthshire | Scotland | British | 80359400001 | |||||||||||||
| LOVE, Jan Karen, Doctor | Director | 1/7 Tytler Gardens EH8 8HQ Edinburgh Midlothian | British | 110578520001 | ||||||||||||||
| O'BRIEN, Kirsty | Director | Level 3 200 Aldersgate Street EC1A 4HD London Equitix Limited United Kingdom | Scotland | British | 191923490001 | |||||||||||||
| OAG, Stuart Charles | Director | Woodlands Crescent Cults AB15 9DH Aberdeen 7 Aberdeenshire | United Kingdom | British | 129503880001 | |||||||||||||
| OGILVIE, Duncan Henderson, Mr. | Director | Quartermile One 15 Lauriston Place EH3 9EP Edinburgh | Scotland | British | 179008070001 | |||||||||||||
| OGILVIE, Duncan Henderson | Director | 17 Park Place FK8 9JR Stirling Stirlingshire | Scotland | British | 1351000003 | |||||||||||||
| PEARCE, Glenn Sinclair | Director | 200 Aldersgate Street EC1A 4HD London 3rd Floor South Building United Kingdom | Scotland | British | 176131560002 | |||||||||||||
| RITCHIE, Alan Campbell | Director | 57 Kettilstoun Mains EH49 6SH Linlithgow West Lothian | United Kingdom | British | 241898940001 | |||||||||||||
| SMITH, David Niall | Director | Pirnhall Business Park FK7 8ES Stirling Forth House Stirlingshire United Kingdom | United Kingdom | British | 197175530001 | |||||||||||||
| THOMPSON, Richard James | Director | 32 London Bridge Street SE1 9SG London The Shard England | United Kingdom | British | 172839090001 | |||||||||||||
| TOLSON, Steven Harry | Director | 15 Lauriston Place EH3 9EP Edinburgh Quartermile One | Scotland | British | 123605020001 | |||||||||||||
| VERMEER, Daniel Marinus Maria | Director | Charterhouse Square EC1M 6EH London 10-11 United Kingdom | United Kingdom | Dutch | 237314730001 | |||||||||||||
| WALLS, Andrew Peter Lindsay | Director | Southville 6 Mcnabb Street FK14 7DJ Dollar Clackmannanshire | Scotland | British | 113604380001 | |||||||||||||
| WRINN, John | Director | George Square G2 1AL Glasgow 1 Scotland | Scotland | British | 230178140001 | |||||||||||||
| BIIF CORPORATE SERVICES LIMITED | Director corporativo | 100 Wood Street EC2V 7EX London Fifth Floor United Kingdom |
| 160001400001 | ||||||||||||||
| VINDEX LIMITED | Director designado corporativo | 151 St Vincent Street G2 5NJ Glasgow | 900003390001 |
¿Quiénes son las personas con control significativo de STIRLING GATEWAY HC LIMITED?
| Nombre | Notificado el | Dirección | Cesado | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pfi Infrastructure Finance Limited | 06 abr 2016 | 6 Kean Street WC2B 4AS London 8th Floor United Kingdom | No | ||||||||||
| |||||||||||||
Naturaleza del control
| |||||||||||||
Fuente de datos
- Companies House del Reino Unido
El registro oficial de empresas en el Reino Unido, que proporciona acceso público a información sobre empresas, como nombres, direcciones, administradores y registros financieros. - Licencia: CC0