ELGIN HEALTH (CLACKMANNANSHIRE) LIMITED
Visión general
| Nombre de la empresa | ELGIN HEALTH (CLACKMANNANSHIRE) LIMITED |
|---|---|
| Estado de la empresa | Activa |
| Forma jurídica | Sociedad de responsabilidad limitada |
| Número de empresa | SC312130 |
| Jurisdicción | Escocia |
| Fecha de constitución |
Resumen
| Tiene PSCs súper seguros | No |
|---|---|
| Tiene gravámenes | No |
| Tiene historial de insolvencia | No |
| La sede social está en disputa | No |
¿Cuál es el propósito de ELGIN HEALTH (CLACKMANNANSHIRE) LIMITED?
- Otras actividades de apoyo a los negocios n.c.p. (82990) / Actividades administrativas y de apoyo
¿Dónde se encuentra ELGIN HEALTH (CLACKMANNANSHIRE) LIMITED?
| Dirección de la sede social | C/O Resolis Limited Exchange Tower, 11th Floor 19 Canning Street EH3 8EG Edinburgh Scotland |
|---|---|
| Dirección de la sede social no entregable | No |
¿Cuáles fueron los nombres anteriores de ELGIN HEALTH (CLACKMANNANSHIRE) LIMITED?
| Nombre de la empresa | Desde | Hasta |
|---|---|---|
| ROBERTSON HEALTH (CLACKMANNANSHIRE) LIMITED | 19 mar 2007 | 19 mar 2007 |
| MM&S (5175) LIMITED | 17 nov 2006 | 17 nov 2006 |
¿Cuáles son las últimas cuentas de ELGIN HEALTH (CLACKMANNANSHIRE) LIMITED?
| Vencido | No |
|---|---|
| Próximas cuentas | |
| Próximo período contable finaliza el | 31 mar 2026 |
| Próximas cuentas vencen el | 31 dic 2026 |
| Últimas cuentas | |
| Últimas cuentas cerradas hasta | 31 mar 2025 |
¿Cuál es el estado de la última declaración de confirmación para ELGIN HEALTH (CLACKMANNANSHIRE) LIMITED?
| Última declaración de confirmación cerrada hasta | 03 ene 2027 |
|---|---|
| Próxima declaración de confirmación vence | 17 ene 2027 |
| Última declaración de confirmación | |
| Próxima declaración de confirmación cerrada hasta | 03 ene 2026 |
| Vencido | No |
¿Cuáles son las últimas presentaciones para ELGIN HEALTH (CLACKMANNANSHIRE) LIMITED?
| Fecha | Descripción | Documento | Tipo | |
|---|---|---|---|---|
Declaración de confirmación presentada el 03 ene 2026 sin actualizaciones | 3 páginas | CS01 | ||
Cuentas completas preparadas hasta el 31 mar 2025 | 21 páginas | AA | ||
Declaración de confirmación presentada el 03 ene 2025 sin actualizaciones | 3 páginas | CS01 | ||
Cuentas completas preparadas hasta el 31 mar 2024 | 21 páginas | AA | ||
Nombramiento de Mr Peter Kenneth Johnstone como director el 19 dic 2023 | 2 páginas | AP01 | ||
Cese del nombramiento de John Mcdonagh como director el 19 dic 2023 | 1 páginas | TM01 | ||
Declaración de confirmación presentada el 20 dic 2023 sin actualizaciones | 3 páginas | CS01 | ||
Modification des détails de Elgin Health (Clackmannanshire) Holdings Limited en tant que personne disposant d'un contrôle significatif le 20 nov 2023 | 2 páginas | PSC05 | ||
Cessation de The Co-Operative Bank P.L.C. en tant que personne disposant d'un contrôle significatif le 20 nov 2023 | 1 páginas | PSC07 | ||
Cuentas completas preparadas hasta el 31 mar 2023 | 23 páginas | AA | ||
Cuentas para una empresa pequeña preparadas hasta el 31 mar 2022 | 25 páginas | AA | ||
Cese del nombramiento de Peter Kenneth Johnstone como director el 09 feb 2023 | 1 páginas | TM01 | ||
Nombramiento de Mr John Mcdonagh como director el 01 mar 2023 | 2 páginas | AP01 | ||
Nombramiento de Mr John Stephen Gordon como director el 01 mar 2023 | 2 páginas | AP01 | ||
Nombramiento de Mr. Paul Robert Hepburn como director el 16 ene 2023 | 2 páginas | AP01 | ||
Declaración de confirmación presentada el 13 dic 2022 sin actualizaciones | 3 páginas | CS01 | ||
Cese del nombramiento de Gary Martin Steven como director el 28 sept 2022 | 1 páginas | TM01 | ||
Modification des détails de Elgin Health (Clackmannanshire) Holdings Limited en tant que personne disposant d'un contrôle significatif le 01 abr 2022 | 2 páginas | PSC05 | ||
Registro de la carga SC3121300004, creada el 01 abr 2022 | 26 páginas | MR01 | ||
Domicilio social registrado cambiado de C/O Infrastructure Managers Limited 2nd Floor 11 Thistle Street Edinburgh EH2 1DF United Kingdom a C/O Resolis Limited Exchange Tower, 11th Floor 19 Canning Street Edinburgh EH3 8EG el 08 abr 2022 | 1 páginas | AD01 | ||
Cese del nombramiento de Infrastructure Managers Limited como secretario el 31 mar 2022 | 1 páginas | TM02 | ||
Nombramiento de Resolis Limited como secretario el 01 abr 2022 | 2 páginas | AP04 | ||
Cuentas para una empresa pequeña preparadas hasta el 31 mar 2021 | 28 páginas | AA | ||
Declaración de confirmación presentada el 04 dic 2021 sin actualizaciones | 3 páginas | CS01 | ||
Nombramiento de Mr Peter Kenneth Johnstone como director el 01 sept 2021 | 2 páginas | AP01 | ||
¿Quiénes son los directivos de ELGIN HEALTH (CLACKMANNANSHIRE) LIMITED?
| Nombre | Nombrado el | Renunció el | Rol | Dirección | Identificación de la empresa | País de residencia | Nacionalidad | Fecha de nacimiento | Ocupación | Número | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RESOLIS LIMITED | Secretario corporativo | 19 Canning Street EH3 8EG Edinburgh Exchange Tower, 11th Floor Scotland |
| 285489620001 | ||||||||||
| GORDON, John Stephen | Director | Caledonian Exchange 19a Canning Street EH3 8EG Edinburgh Dalmore Capital United Kingdom | Scotland | British | 203724200001 | |||||||||
| HEPBURN, Paul Robert, Mr. | Director | Exchange Tower, 11th Floor 19 Canning Street EH3 8EG Edinburgh C/O Resolis Limited Scotland | United Kingdom | British | 119364680001 | |||||||||
| JOHNSTONE, Peter Kenneth | Director | Caledonian Exchange 19a Canning Street EH3 8EG Edinburgh Dalmore Capital United Kingdom | United Kingdom | British | 53299620003 | |||||||||
| BAND, James | Secretario | Castle Business Park FK9 4TZ Stirling Robertson House Stirlingshire Uk | 197376440001 | |||||||||||
| JOHNSTONE, Peter Kenneth | Secretario | 10 Perimeter Road Pinefield Industrial Estate IV30 6AE Elgin Moray | British | 53299620002 | ||||||||||
| INFRASTRUCTURE MANAGERS LIMITED | Secretario corporativo | 11 Thistle Street EH2 1DF Edinburgh 2nd Floor Midlothian United Kingdom |
| 128530180002 | ||||||||||
| MACLAY MURRAY & SPENS LLP | Secretario designado corporativo | St. Vincent Street G2 5NJ Glasgow 151 | 900003400001 | |||||||||||
| BURGE, Richard William Francis | Director | Melville Street EH3 7JF Edinburgh 35 United Kingdom | Scotland | British | 114479400001 | |||||||||
| CHRISTIE, Rory William | Director | Thistle Street EH2 1DF Edinburgh 11 Scotland Scotland | United Kingdom | British | 151812860001 | |||||||||
| FORDYCE, Alan Peter | Director | 10 Perimeter Road Pinefield Industrial Estate IV30 6AE Elgin Moray | Scotland | British | 97815240002 | |||||||||
| GORDON, John Stephen | Director | Melville Street EH3 7JF Edinburgh 35 United Kingdom | Scotland | British | 203724200001 | |||||||||
| JOHNSTONE, Peter Kenneth | Director | Caledonian Exchange 19a Canning Street EH3 8EG Edinburgh Dalmore Capital United Kingdom | United Kingdom | British | 53299620003 | |||||||||
| MCDONAGH, John | Director | Watling House - 5th Floor, 33 Cannon Street EC4M 5SB London Dalmore Capital England | England | British | 192240500001 | |||||||||
| MCDONAGH, John | Director | Aldersgate Street EC1A 4HD London 200 United Kingdom | United Kingdom | British | 182087330001 | |||||||||
| MCEWAN, Alastair John Angus | Director | Melville Street EH3 7JF Edinburgh 35 City Of Edinburgh Scotland | Scotland | British | 171409910002 | |||||||||
| RICHARDSON, Christopher Richard | Director | Thistle Street EH2 1DF Edinburgh 11 Scotland | United Kingdom | British | 258465700001 | |||||||||
| ROBERTSON, William George | Director | 10 Perimeter Road Pinefield Industrial Estate IV30 6AE Elgin Moray | Scotland | British | 88810130001 | |||||||||
| RYAN, Michael Joseph | Director | Aldersgate Street EC1A 4HD London 200 United Kingdom | United Kingdom | Irish | 77999320003 | |||||||||
| STEVEN, Gary Martin | Director | 19a Canning Street EH3 8EG Edinburgh Caledonian Exchange United Kingdom | United Kingdom | British | 209101460001 | |||||||||
| VINDEX LIMITED | Director corporativo | 151 St Vincent Street G2 5NJ Glasgow | 64555080001 | |||||||||||
| VINDEX SERVICES LIMITED | Director corporativo | 151 St Vincent Street G2 5NJ Glasgow | 64555070001 |
¿Quiénes son las personas con control significativo de ELGIN HEALTH (CLACKMANNANSHIRE) LIMITED?
| Nombre | Notificado el | Dirección | Cesado | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| The Co-Operative Bank P.L.C. | 06 abr 2016 | 1 Balloon Street M60 4EP Manchester P.O. Box 101 United Kingdom | Sí | ||||||||||
| |||||||||||||
Naturaleza del control
| |||||||||||||
| Elgin Health (Clackmannanshire) Holdings Limited | 06 abr 2016 | 11th Floor 19 Canning Street EH3 8EG Edinburgh C/O Resolis Limited Exchange Tower Scotland | No | ||||||||||
| |||||||||||||
Naturaleza del control
| |||||||||||||
Fuente de datos
- Companies House del Reino Unido
El registro oficial de empresas en el Reino Unido, que proporciona acceso público a información sobre empresas, como nombres, direcciones, administradores y registros financieros. - Licencia: CC0