WHITESIDE HILL WINDFARM (SCOTLAND) LIMITED
Visión general
| Nombre de la empresa | WHITESIDE HILL WINDFARM (SCOTLAND) LIMITED |
|---|---|
| Estado de la empresa | Activa |
| Forma jurídica | Sociedad de responsabilidad limitada |
| Número de empresa | SC312729 |
| Jurisdicción | Escocia |
| Fecha de constitución |
Resumen
| Tiene PSCs súper seguros | No |
|---|---|
| Tiene gravámenes | No |
| Tiene historial de insolvencia | No |
| La sede social está en disputa | No |
¿Cuál es el propósito de WHITESIDE HILL WINDFARM (SCOTLAND) LIMITED?
- Producción de electricidad (35110) / Suministro de electricidad, gas, vapor y aire acondicionado
¿Dónde se encuentra WHITESIDE HILL WINDFARM (SCOTLAND) LIMITED?
| Dirección de la sede social | 13 Queens Road AB15 4YL Aberdeen |
|---|---|
| Dirección de la sede social no entregable | No |
¿Cuáles fueron los nombres anteriores de WHITESIDE HILL WINDFARM (SCOTLAND) LIMITED?
| Nombre de la empresa | Desde | Hasta |
|---|---|---|
| HMS (678) LIMITED | 29 nov 2006 | 29 nov 2006 |
¿Cuáles son las últimas cuentas de WHITESIDE HILL WINDFARM (SCOTLAND) LIMITED?
| Vencido | No |
|---|---|
| Próximas cuentas | |
| Próximo período contable finaliza el | 31 dic 2025 |
| Próximas cuentas vencen el | 30 sept 2026 |
| Últimas cuentas | |
| Últimas cuentas cerradas hasta | 31 dic 2024 |
¿Cuál es el estado de la última declaración de confirmación para WHITESIDE HILL WINDFARM (SCOTLAND) LIMITED?
| Última declaración de confirmación cerrada hasta | 29 nov 2026 |
|---|---|
| Próxima declaración de confirmación vence | 13 dic 2026 |
| Última declaración de confirmación | |
| Próxima declaración de confirmación cerrada hasta | 29 nov 2025 |
| Vencido | No |
¿Cuáles son las últimas presentaciones para WHITESIDE HILL WINDFARM (SCOTLAND) LIMITED?
| Fecha | Descripción | Documento | Tipo | |
|---|---|---|---|---|
Declaración de confirmación presentada el 29 nov 2025 sin actualizaciones | 3 páginas | CS01 | ||
Cuentas completas preparadas hasta el 31 dic 2024 | 32 páginas | AA | ||
Declaración de confirmación presentada el 29 nov 2024 sin actualizaciones | 3 páginas | CS01 | ||
Cuentas completas preparadas hasta el 31 dic 2023 | 30 páginas | AA | ||
Declaración de confirmación presentada el 29 nov 2023 sin actualizaciones | 3 páginas | CS01 | ||
Cese del nombramiento de Nur Atikah Paimin como director el 06 nov 2023 | 1 páginas | TM01 | ||
Cese del nombramiento de Shamsul Azham Bin Mohd Isa como director el 06 nov 2023 | 1 páginas | TM01 | ||
Nombramiento de Azean Abu Samad como director el 06 nov 2023 | 2 páginas | AP01 | ||
Nombramiento de Mrs Sharon Bridgland-Gough como director el 06 nov 2023 | 2 páginas | AP01 | ||
Cuentas para una empresa pequeña preparadas hasta el 31 dic 2022 | 25 páginas | AA | ||
Cambio de datos del director Nur Atikah Paimin el 01 abr 2023 | 2 páginas | CH01 | ||
Cambio de datos del director Shamsul Azham Bin Mohd Isa el 01 abr 2023 | 2 páginas | CH01 | ||
Cambio de datos del director Shamsul Azham Bin Mohd Isa el 01 abr 2023 | 2 páginas | CH01 | ||
Declaración de confirmación presentada el 29 nov 2022 sin actualizaciones | 3 páginas | CS01 | ||
Cuentas para una empresa pequeña preparadas hasta el 31 dic 2021 | 27 páginas | AA | ||
Cessation de Clean Energy and Infrastructure Uk Wind Limited en tant que personne disposant d'un contrôle significatif le 01 abr 2022 | 1 páginas | PSC07 | ||
Notification de Norman 1985 Limited en tant que personne disposant d'un contrôle significatif le 01 abr 2022 | 2 páginas | PSC02 | ||
Cessation de Clean Energy and Infrastructure Uk Limited en tant que personne disposant d'un contrôle significatif le 01 abr 2022 | 1 páginas | PSC07 | ||
Notification de Clean Energy and Infrastructure Uk Wind Limited en tant que personne disposant d'un contrôle significatif le 01 abr 2022 | 2 páginas | PSC02 | ||
Notification de Clean Energy and Infrastructure Uk Limited en tant que personne disposant d'un contrôle significatif le 01 abr 2022 | 2 páginas | PSC02 | ||
Cessation de Thomas Kubr en tant que personne disposant d'un contrôle significatif le 01 abr 2022 | 1 páginas | PSC07 | ||
Cessation de Capital Dynamics Limited en tant que personne disposant d'un contrôle significatif le 01 abr 2022 | 1 páginas | PSC07 | ||
Nombramiento de Shamsul Azham Bin Mohd Isa como director el 01 abr 2022 | 2 páginas | AP01 | ||
Nombramiento de Nur Atikah Paimin como director el 01 abr 2022 | 2 páginas | AP01 | ||
Cese del nombramiento de Simon Richard Eaves como director el 01 abr 2022 | 1 páginas | TM01 | ||
¿Quiénes son los directivos de WHITESIDE HILL WINDFARM (SCOTLAND) LIMITED?
| Nombre | Nombrado el | Renunció el | Rol | Dirección | Identificación de la empresa | País de residencia | Nacionalidad | Fecha de nacimiento | Ocupación | Número |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BRIDGLAND-GOUGH, Sharon Rebecca | Director | 143-149 Fenchurch Street EC3M 6BL London 1st Floor, Sackville House England | England | British | 258958720002 | |||||
| SAMAD, Azean Abu | Director | 143-149 Fenchurch Street EC3M 6BL London 1st Floor, Sackville House United Kingdom | England | Malaysian | 315481340001 | |||||
| DONNELLY, Lawrence John Vincent | Secretario | Dunkeld Road PH1 3AQ Perth Inveralmond House 200 Perthshire | British | 129227760001 | ||||||
| FAIRBAIRN, Sally | Secretario | 200 Dunkeld Road PH1 3AQ Perth Inveralmond House Scotland | 193204250001 | |||||||
| FOY, Simon John | Secretario | West Street SK9 7EG Alderley Edge 10 Cheshire England | 198255980001 | |||||||
| OLDROYD, Elizabeth Alexandra | Secretario | Slutchers Lane WA1 1QL Warrington 1030 Centre Park England | 203989030001 | |||||||
| HMS SECRETARIES LIMITED | Secretario designado corporativo | The Ca'D'Oro 45 Gordon Street G1 3PE Glasgow | 900004320001 | |||||||
| ALEXANDER, Fraser Mcgregor | Director | 200 Dunkeld Road PH1 3AQ Perth Inveralmond House | United Kingdom | British | 65278040002 | |||||
| BAKER, Alan | Director | 16 Harbourside Kip Village PA16 0BF Inverkip Renfrewshire | Scotland | Scottish | 103351610001 | |||||
| BERTAGNA, Dario | Director | Queens Road AB15 4YL Aberdeen 13 | United Kingdom | Italian | 230234270001 | |||||
| BRECKENRIDGE, John William | Director | Queens Road AB15 4YL Aberdeen 13 | United States | American | 202811700001 | |||||
| COWIE, Steven Alexander | Director | 34 Divert Road PA19 1DT Gourock Renfrewshire | Scotland | British | 109655420001 | |||||
| DEAN, Christopher James | Director | West Street SK9 7EG Alderley Edge 10 Cheshire England | United Kingdom | British | 175925470001 | |||||
| DOWLING, Paul Cyril | Director | Weston Carrick Brook, Eadestown Naas County Kildare Ireland | Ireland | Irish | 111811130002 | |||||
| DOWN, Helen Ruth | Director | Queens Road AB15 4YL Aberdeen 13 | England | British | 233527350001 | |||||
| DWYER, Nicola | Director | Ravenscourt Office Park Sandyford Dublin 18. Airtricity House Ireland | Ireland | Irish | 160281420001 | |||||
| EAVES, Simon Richard | Director | Slutchers Lane WA1 1QL Warrington 1030 Centre Park England | England | Welsh | 200997040001 | |||||
| FISH, Andrew Stuart | Director | Welton HU15 1NB Brough Welton Grange East Riding Of Yorkshire United Kingdom | United Kingdom | British | 99181180003 | |||||
| FLYNN, Donal Francis | Director | 3 Whitebeam Avenue Clonskeagh IRISH Dublin 14 Ireland | Ireland | Irish | 126967800001 | |||||
| FOY, Simon John | Director | West Street SK9 7EG Alderley Edge 10 Cheshire England | United Kingdom | British | 196525430001 | |||||
| FRIEL, Gerald Joseph | Director | Queens Road AB15 4YL Aberdeen 13 | United States | American | 207789620001 | |||||
| GAINS, Keith Stephen | Director | Sackville Street W1S 3DN London 21 England | Wales | British | 161678470001 | |||||
| GARDNER, David | Director | 200 Dunkeld Road PH1 3AQ Perth Inveralmond House Scotland | United Kingdom | British | 126262860001 | |||||
| GIBLIN, Caoimhe Mary | Director | South County Business Park Leopardstown 18 Dublin Red Oak South Ireland | Ireland | Irish | 153538670001 | |||||
| GOLANSKA-RYAN, Justyna Roza | Director | Queens Road AB15 4YL Aberdeen 13 | United Kingdom | Irish | 205926820001 | |||||
| HEYES, Simon Murray | Director | Turretbank Road PH7 4LN Crieff 8 Perthshire | United Kingdom | British | 189332050001 | |||||
| HUGHES, Paul Kevin | Director | Queens Road AB15 4YL Aberdeen 13 | United Kingdom | British | 272466000001 | |||||
| ISA, Shamsul Azham Bin Mohd | Director | 143-149 Fenchurch Street EC3M 6BL London 1st Floor, Sackville House England | Malaysia | Malaysian | 295260590001 | |||||
| MCADAM, Martin | Director | 35 Glen Lawn Drive The Park IRISH Cabinteely Dublin Ireland | Irish | 94415780001 | ||||||
| MURPHY, Senan | Director | 2 Cranford Terenure Road West IRISH Dublin 6w Ireland | Irish | 95157200001 | ||||||
| NICOL, Colin Clarke | Director | Waterloo Street G2 6AY Glasgow 1 United Kingdom | United Kingdom | British | 117786710001 | |||||
| NOBLE, Stuart | Director | Queens Road AB15 4YL Aberdeen 13 Scotland | United Kingdom | British | 104364800001 | |||||
| PAIMIN, Nur Atikah | Director | 143-149 Fenchurch Street EC3M 6BL London 1st Floor, Sackville House England | United Kingdom | Malaysian | 278878070001 | |||||
| SMITH, James Isaac | Director | 200 Dunkeld Road PH1 3AQ Perth Inveralmond House Scotland | United Kingdom | British | 130143620002 | |||||
| USHER, Kirsty Louise | Director | Queens Road AB15 4YL Aberdeen 13 | Scotland | Scottish | 215697310001 |
¿Quiénes son las personas con control significativo de WHITESIDE HILL WINDFARM (SCOTLAND) LIMITED?
| Nombre | Notificado el | Dirección | Cesado | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Clean Energy And Infrastructure Uk Wind Limited | 01 abr 2022 | Centre Park WA1 1RL Warrington Ground Floor, Ibis House Ibis Court England | Sí | ||||||||||
| |||||||||||||
Naturaleza del control
| |||||||||||||
| Clean Energy And Infrastructure Uk Limited | 01 abr 2022 | Centre Park WA1 1RL Warrington Ground Floor, Ibis House Ibis Court England | Sí | ||||||||||
| |||||||||||||
Naturaleza del control
| |||||||||||||
| Norman 1985 Limited | 01 abr 2022 | Centre Park WA1 1RL Warrington Ground Floor, Ibis House Ibis Court England | No | ||||||||||
| |||||||||||||
Naturaleza del control
| |||||||||||||
| Mr Thomas Kubr | 01 may 2019 | Bahnhofstrasse Zug 22 6301 Switzerland | Sí | ||||||||||
Nacionalidad: Swiss País de residencia: England | |||||||||||||
Naturaleza del control
| |||||||||||||
| Capital Dynamics Limited | 06 abr 2016 | Colmore Row B3 2BJ Birmingham 9th Floor, 9 England | Sí | ||||||||||
| |||||||||||||
Naturaleza del control
| |||||||||||||
| Efs Uk Holdings Limited | 06 abr 2016 | Talgarth Road W6 8BJ London The Ark, 201 England | Sí | ||||||||||
| |||||||||||||
Naturaleza del control
| |||||||||||||
| Mr Mark Edwin Healey | 06 abr 2016 | West Street SK9 7EG Alderley Edge 10 Cheshire England | Sí | ||||||||||
Nacionalidad: British País de residencia: England | |||||||||||||
Naturaleza del control
| |||||||||||||
Fuente de datos
- Companies House del Reino Unido
El registro oficial de empresas en el Reino Unido, que proporciona acceso público a información sobre empresas, como nombres, direcciones, administradores y registros financieros. - Licencia: CC0