SUPPLIER DEVELOPMENT PROGRAMME
Visión general
| Nombre de la empresa | SUPPLIER DEVELOPMENT PROGRAMME |
|---|---|
| Estado de la empresa | Activa |
| Forma jurídica | Sociedad de responsabilidad limitada por garantía sin capital social, exención del uso de 'Limited' |
| Número de empresa | SC342650 |
| Jurisdicción | Escocia |
| Fecha de constitución |
Resumen
| Tiene PSCs súper seguros | No |
|---|---|
| Tiene gravámenes | No |
| Tiene historial de insolvencia | No |
| La sede social está en disputa | No |
¿Cuál es el propósito de SUPPLIER DEVELOPMENT PROGRAMME?
- Otras actividades de apoyo a los negocios n.c.p. (82990) / Actividades administrativas y de apoyo
¿Dónde se encuentra SUPPLIER DEVELOPMENT PROGRAMME?
| Dirección de la sede social | C/O Wright Johnston & Mackenzie Llp St Vincent Plaza 319 St Vincent Street G2 5RZ Glasgow Scotland |
|---|---|
| Dirección de la sede social no entregable | No |
¿Cuáles son las últimas cuentas de SUPPLIER DEVELOPMENT PROGRAMME?
| Vencido | No |
|---|---|
| Próximas cuentas | |
| Próximo período contable finaliza el | 31 mar 2026 |
| Próximas cuentas vencen el | 31 dic 2026 |
| Últimas cuentas | |
| Últimas cuentas cerradas hasta | 31 mar 2025 |
¿Cuál es el estado de la última declaración de confirmación para SUPPLIER DEVELOPMENT PROGRAMME?
| Última declaración de confirmación cerrada hasta | 23 may 2026 |
|---|---|
| Próxima declaración de confirmación vence | 06 jun 2026 |
| Última declaración de confirmación | |
| Próxima declaración de confirmación cerrada hasta | 23 may 2025 |
| Vencido | No |
¿Cuáles son las últimas presentaciones para SUPPLIER DEVELOPMENT PROGRAMME?
| Fecha | Descripción | Documento | Tipo | |
|---|---|---|---|---|
Cuentas para una empresa pequeña preparadas hasta el 31 mar 2025 | 8 páginas | AA | ||
Declaración de confirmación presentada el 23 may 2025 sin actualizaciones | 3 páginas | CS01 | ||
Nombramiento de Mr David Aitken como director el 20 may 2025 | 2 páginas | AP01 | ||
Cese del nombramiento de Stuart William Jamieson como director el 10 abr 2025 | 1 páginas | TM01 | ||
Cuentas para una empresa pequeña preparadas hasta el 31 mar 2024 | 7 páginas | AA | ||
Nombramiento de Mo Razzaq como director el 04 sept 2024 | 2 páginas | AP01 | ||
Cese del nombramiento de Mark Mcgeever como director el 09 jul 2024 | 1 páginas | TM01 | ||
Declaración de confirmación presentada el 23 may 2024 sin actualizaciones | 3 páginas | CS01 | ||
Nombramiento de Jane Morrison como director el 26 mar 2024 | 2 páginas | AP01 | ||
Cese del nombramiento de Jacqueline Hill como director el 05 abr 2024 | 1 páginas | TM01 | ||
Nombramiento de David William Inglis como director el 21 jun 2023 | 2 páginas | AP01 | ||
Nombramiento de Chris Cullen como director el 30 jun 2023 | 2 páginas | AP01 | ||
Cuentas para una empresa pequeña preparadas hasta el 31 mar 2023 | 15 páginas | AA | ||
Cese del nombramiento de Stephen Albert Thompson como director el 21 jun 2023 | 1 páginas | TM01 | ||
Cese del nombramiento de Peter Henderson como director el 30 jun 2023 | 1 páginas | TM01 | ||
Declaración de confirmación presentada el 23 may 2023 sin actualizaciones | 3 páginas | CS01 | ||
Cambio de datos del director Ms Paula Margaret Deegan el 30 mar 2023 | 2 páginas | CH01 | ||
Cambio de datos del director Ms Heather Andrea Brannan-Mcvey el 30 mar 2023 | 2 páginas | CH01 | ||
Cambio de datos del secretario Wjm Secretaries Limited el 30 mar 2023 | 1 páginas | CH04 | ||
Cese del nombramiento de Peter David William Reid como director el 22 feb 2023 | 1 páginas | TM01 | ||
Nombramiento de Mr Stephen Albert Thompson como director el 06 dic 2022 | 2 p áginas | AP01 | ||
Cese del nombramiento de Andrew Stuart Wood como director el 01 dic 2022 | 1 páginas | TM01 | ||
Cuentas para una empresa pequeña preparadas hasta el 31 mar 2022 | 14 páginas | AA | ||
Nombramiento de Mark Mcgeever como director el 23 ago 2022 | 2 páginas | AP01 | ||
Nombramiento de Stephen Canning como director el 23 ago 2022 | 2 páginas | AP01 | ||
¿Quiénes son los directivos de SUPPLIER DEVELOPMENT PROGRAMME?
| Nombre | Nombrado el | Renunció el | Rol | Dirección | Identificación de la empresa | País de residencia | Nacionalidad | Fecha de nacimiento | Ocupación | Número | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WJM SECRETARIES LIMITED | Secretario corporativo | St. Vincent Street G2 5RZ Glasgow St Vincent Plaza, 319 Scotland |
| 79915470001 | ||||||||||
| AITKEN, David | Director | Municipal Buildings PA15 1LY Greenock Inverclyde Council Scotland | Scotland | British | 335989510001 | |||||||||
| BRANNAN-MCVEY, Heather Andrea | Director | St Vincent Plaza 319 St Vincent Street G2 5RZ Glasgow C/O Wright Johnston & Mackenzie Llp Scotland | Scotland | British | 174363230002 | |||||||||
| BUCHANNAN, Anthony | Director | St Vincent Plaza 319 St Vincent Street G2 5RZ Glasgow C/O Wright Johnston & Mackenzie Llp Scotland | United Kingdom | British | 137726920002 | |||||||||
| CANNING, Stephen | Director | London Road KA3 7BU Kilmarnock East Ayrshire Council Headquarters East Ayrshire Scotland | Scotland | British | 301530420001 | |||||||||
| CONTI, Fiona Margaret | Director | Commercial & Procurement Shared Service Glenurquhart Road IV3 5NX Inverness Highland Council, Council Hq Scotland | Scotland | British | 288699460001 | |||||||||
| CULLEN, Chris | Director | Wellington Square KA7 1DR Ayr County Buildings Scotland | Scotland | Irish | 315941590001 | |||||||||
| DEEGAN, Paula Margaret | Director | St Vincent Plaza 319 St Vincent Street G2 5RZ Glasgow C/O Wright Johnston & Mackenzie Llp Scotland | Scotland | British | 251071430001 | |||||||||
| INGLIS, David William | Director | English Street DG1 2DD Dumfries Council Hq Scotland | Scotland | British | 316459390001 | |||||||||
| MORRISON, Jane | Director | 231 George Street G1 1RX Glasgow Exchange House Scotland | Scotland | Scottish | 323909510001 | |||||||||
| RAZZAQ, Mo | Director | Almada Street ML3 0AA Hamilton Council Offices South Lanarkshire Scotland | Scotland | British | 326983540001 | |||||||||
| STEVENSON, Pamela | Director | North Street KY7 5LT Glenrothes Fife House Scotland | Scotland | British | 270365490001 | |||||||||
| THOMAS, Rachael | Director | Corporate Services Dundee House, 50 North Lindsay Street DD1 1NZ Dundee Dundee City Council Scotland | Scotland | Scottish | 290846730001 | |||||||||
| ANDERSON, Alexander | Director | St Vincent Street G2 5RZ Glasgow 302 Scotland | United Kingdom | British | 122976360001 | |||||||||
| ANDREW, Robert | Director | St Vincent Street G2 5RZ Glasgow 302 Scotland | Scotland | British | 107297770001 | |||||||||
| BEATTIE, Diane Elaine | Director | High Street IV30 1BX Elgin Moray Council, Council Buildings Morayshire Scotland | Scotland | British | 208268620001 | |||||||||
| BELL, Scott Douglas | Director | Victoria Quay EH6 6QQ Edinburgh Scottish Government, 3b North Scotland | Scotland | Scottish | 104983170001 | |||||||||
| BROWN, Alan | Director | c/o Wright Johnston & Mackenzie Llp St. Vincent Street G2 5RZ Glasgow 302 Scotland | United Kingdom | Scottish | 122613210001 | |||||||||
| BUCHANAN, James Mcmillan | Director | Plann Road Knockentiber KA2 0EN Kilmarnock 13 Ayrshire Scotland | Scotland | British | 123226760001 | |||||||||
| CHALMERS, Maureen Anne | Director | Headquarters Almada St ML3 0AA Hamilton South Lanarkshire Council Scotland | Scotland | Scottish | 288699440001 | |||||||||
| DAVIDSON, Veronica Mary, Councillor | Director | St Vincent Street G2 5RZ Glasgow 302 Scotland | Scotland | British | 93603750002 | |||||||||
| DUFF, Douglas Stirling | Director | c/o Wright Johnston & Mackenzie Llp St. Vincent Street G2 5RZ Glasgow 302 | Scotland | British | 134411710001 | |||||||||
| GLEN, Thomas | Director | The Triangle Kirkintilloch Road G42 2TR Bishopbroggs East Dunbartonshire Council | Scotland | British | 140550660001 | |||||||||
| HENDERSON, Peter | Director | Wellington Square KA7 1DR Ayr County Buildings Scotland | Scotland | Scottish | 239260530001 | |||||||||
| HILL, Jacqueline | Director | 40 John Street G2 1DU Glasgow Glasgow City Council Scotland | Scotland | British | 69922660001 | |||||||||
| IRVINE, Grace Neilson | Director | St Vincent Street G2 5RZ Glasgow 302 Scotland | United Kingdom | British | 146289120001 | |||||||||
| JAMIESON, Stuart William | Director | St Vincent Plaza 319 St Vincent Street G2 5RZ Glasgow C/O Wright Johnston & Mackenzie Llp Scotland | Scotland | British | 56043940001 | |||||||||
| JENKINS, Gordon Murray Farquhar | Director | Stewarton KA3 5HF East Ayrshire 25 Ailsa View Scotland | Scotland | Scottish | 239260380001 | |||||||||
| JORDAN, Eliot James | Director | 154 Montrose Crescent ML3 6LB Hamilton Montrose House South Lanarkshire United Kingdom | United Kingdom | British | 169341790001 | |||||||||
| KEATING, Stephen | Director | c/o Plannning And Economic Development Services Montrose House 154 Montrose Crescent ML3 6LB Hamilton South Lanarkshire Council Lanarkshire Scotland | Scotland | British | 206435930001 | |||||||||
| KELLY, John | Director | c/o Wright Johnston & Mackenzie Llp St. Vincent Street G2 5RZ Glasgow 302 | Scotland | British | 172073060001 | |||||||||
| KERR, Mollie Jane | Director | c/o Wright Johnston & Mackenzie Llp St. Vincent Street G2 5RZ Glasgow 302 | Scotland | Scottish | 199662270001 | |||||||||
| KHAN, Kaiser | Director | St Vincent Street G2 5RZ Glasgow 302 Scotland | United Kingdom | British | 207383070001 | |||||||||
| LAWSON, Karen Ann | Director | c/o Wright Johnston & Mackenzie Llp St. Vincent Street G2 5RZ Glasgow 302 | Scotland | Scottish | 199662260001 | |||||||||
| MCGEEVER, Mark | Director | Almada Street ML3 0AA Hamilton South Lanarkshire Council Scotland | Scotland | British | 301534300001 |
¿Cuáles son las últimas declaraciones sobre personas con control significativo para SUPPLIER DEVELOPMENT PROGRAMME?
| Notificado el | Cesado el | Declaración |
|---|---|---|
| 09 may 2017 | La empresa sabe o tiene motivos razonables para creer que no existe ninguna persona registrable o entidad jurídica relevante registrable en relación con la empresa. |
Fuente de datos
- Companies House del Reino Unido
El registro oficial de empresas en el Reino Unido, que proporciona acceso público a información sobre empresas, como nombres, direcciones, administradores y registros financieros. - Licencia: CC0