E4I HOLDINGS LIMITED
Visión general
| Nombre de la empresa | E4I HOLDINGS LIMITED |
|---|---|
| Estado de la empresa | Activa |
| Forma jurídica | Sociedad de responsabilidad limitada |
| Número de empresa | SC342702 |
| Jurisdicción | Escocia |
| Fecha de constitución |
Resumen
| Tiene PSCs súper seguros | No |
|---|---|
| Tiene gravámenes | No |
| Tiene historial de insolvencia | No |
| La sede social está en disputa | No |
¿Cuál es el propósito de E4I HOLDINGS LIMITED?
- Construcción de edificios comerciales (41201) / Construcción
¿Dónde se encuentra E4I HOLDINGS LIMITED?
| Dirección de la sede social | Avondale House Suites 1b-1e, Phoenix Crescent Strathclyde Business Park ML4 3NJ Bellshill North Lanarkshire Scotland |
|---|---|
| Dirección de la sede social no entregable | No |
¿Cuáles son las últimas cuentas de E4I HOLDINGS LIMITED?
| Vencido | No |
|---|---|
| Próximas cuentas | |
| Próximo período contable finaliza el | 31 dic 2025 |
| Próximas cuentas vencen el | 30 sept 2026 |
| Últimas cuentas | |
| Últimas cuentas cerradas hasta | 31 dic 2024 |
¿Cuál es el estado de la última declaración de confirmación para E4I HOLDINGS LIMITED?
| Última declaración de confirmación cerrada hasta | 15 may 2026 |
|---|---|
| Próxima declaración de confirmación vence | 29 may 2026 |
| Última declaración de confirmación | |
| Próxima declaración de confirmación cerrada hasta | 15 may 2025 |
| Vencido | No |
¿Cuáles son las últimas presentaciones para E4I HOLDINGS LIMITED?
| Fecha | Descripción | Documento | Tipo | |
|---|---|---|---|---|
Nombramiento de Mr Kevin Alistair Cunningham como director el 20 nov 2025 | 2 páginas | AP01 | ||
Nombramiento de Equitix Management Services Limited como secretario el 01 nov 2025 | 2 páginas | AP04 | ||
Cese del nombramiento de Alexander William Gallon como secretario el 01 nov 2025 | 1 páginas | TM02 | ||
Cese del nombramiento de Lauren Brown como secretario el 11 ago 2025 | 1 páginas | TM02 | ||
Nombramiento de Mr Alexander William Gallon como secretario el 11 ago 2025 | 2 páginas | AP03 | ||
Cese del nombramiento de Glenn Sinclair Pearce como director el 01 jul 2025 | 1 páginas | TM01 | ||
Cuentas para una empresa pequeña preparadas hasta el 31 dic 2024 | 15 páginas | AA | ||
Declaración de confirmación presentada el 15 may 2025 sin actualizaciones | 3 páginas | CS01 | ||
Nombramiento de Mr Craig Alexander Thomson como director el 19 feb 2025 | 2 páginas | AP01 | ||
Nombramiento de Ms Claire Agnes Mcinally como director el 19 feb 2025 | 2 páginas | AP01 | ||
Cese del nombramiento de Alison Groat como director el 19 feb 2025 | 1 páginas | TM01 | ||
Cese del nombramiento de Dylan Fletcher como director el 19 feb 2025 | 1 páginas | TM01 | ||
Cambio de datos del director Mr Stewart William Small el 25 nov 2024 | 2 páginas | CH01 | ||
Cese del nombramiento de Kirsty O'brien como director el 01 oct 2024 | 1 páginas | TM01 | ||
Nombramiento de Mr Glenn Sinclair Pearce como director el 01 oct 2024 | 2 páginas | AP01 | ||
Cuentas para una empresa pequeña preparadas hasta el 31 dic 2023 | 15 páginas | AA | ||
Declaración de confirmación presentada el 15 may 2024 sin actualizaciones | 3 páginas | CS01 | ||
Nombramiento de Lauren Brown como secretario el 28 feb 2024 | 2 páginas | AP03 | ||
Cese del nombramiento de Daniela Radulescu como secretario el 28 feb 2024 | 1 páginas | TM02 | ||
Domicilio social registrado cambiado de Avondale House, Suites 1L - 1O Phoenix Crescent Strathclyde Business Park Bellshill ML4 3NJ Scotland a Avondale House Suites 1B-1E, Phoenix Crescent Strathclyde Business Park Bellshill North Lanarkshire ML4 3NJ el 23 may 2024 | 1 páginas | AD01 | ||
Cese del nombramiento de David Niall Smith como director el 22 nov 2023 | 1 páginas | TM01 | ||
Nombramiento de Ms Alison Groat como director el 22 nov 2023 | 2 páginas | AP01 | ||
Cuentas para una empresa pequeña preparadas hasta el 31 dic 2022 | 15 páginas | AA | ||
Declaración de confirmación presentada el 15 may 2023 sin actualizaciones | 3 páginas | CS01 | ||
Exercice comptable précédent raccourci du 31 mar 2023 au 31 dic 2022 | 1 páginas | AA01 | ||
¿Quiénes son los directivos de E4I HOLDINGS LIMITED?
| Nombre | Nombrado el | Renunció el | Rol | Dirección | Identificación de la empresa | País de residencia | Nacionalidad | Fecha de nacimiento | Ocupación | Número | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EQUITIX MANAGEMENT SERVICES LIMITED | Secretario corporativo | 200 Aldersgate Street EC1A 4HD London 3rd Floor (South) United Kingdom |
| 342191500001 | ||||||||||
| CUNNINGHAM, Kevin Alistair | Director | Suites 1b-1e, Phoenix Crescent Strathclyde Business Park ML4 3NJ Bellshill Avondale House North Lanarkshire Scotland | United Kingdom | Scottish | 271263600001 | |||||||||
| MCINALLY, Claire Agnes | Director | FK7 8HW Stirling Forth House Pirnhall Business Park Scotland | United Kingdom | British | 167317960001 | |||||||||
| SMALL, Stewart William | Director | Cobalt Square 83-85 Hagley Road B16 8QG Birmingham 9th Floor United Kingdom | United Kingdom | British | 302497750001 | |||||||||
| THOMSON, Craig Alexander | Director | FK7 8HW Stirling Forth House Pirnhall Business Park Scotland | United Kingdom | British | 170356700001 | |||||||||
| BROWN, Lauren | Secretario | 200 Aldersgate Street EC1A 4HD London Third Floor, South Building United Kingdom | 323375500001 | |||||||||||
| CHRISTIE, Roderick | Secretario | 91-93 Charterhouse Street EC1M 6HR London Boundary House Uk | British | 166249810001 | ||||||||||
| GALLON, Alexander William | Secretario | Suites 1b-1e, Phoenix Crescent Strathclyde Business Park ML4 3NJ Bellshill Avondale House North Lanarkshire Scotland | 339009750001 | |||||||||||
| JONES, Sion Laurence | Secretario | Charterhouse Square EC1M 6EH London 10-11 United Kingdom | 180505080001 | |||||||||||
| RADULESCU, Daniela | Secretario | Suites 1b-1e, Phoenix Crescent Strathclyde Business Park ML4 3NJ Bellshill Avondale House North Lanarkshire Scotland | 269875190001 | |||||||||||
| SMYTH, Pamela June | Secretario | 2 Lochside View Edinburgh Park EH12 9DH Edinburgh Miller House | British | 65057960002 | ||||||||||
| THORPE COSTA, Sophia | Secretario | 10 - 11 Charterhouse Square EC1M 6EH London Welken House England | 202567160001 | |||||||||||
| ANDERSON, Derek Orr | Director | 9 The Spinneys KY11 9SL Dalgety Bay Fife | Scotland | British | 161345590001 | |||||||||
| BAXTER, Mark | Director | Lochside View Edinburgh Park EH12 9DH Edinburgh 2 Midlothian | United Kingdom | British | 121315740001 | |||||||||
| BIRCH, Alan Edward | Director | 7 Silsbury Grove Standish WN6 0EY Wigan Lancashire | United Kingdom | British | 90700330001 | |||||||||
| CHRISTIE, Roderick William | Director | 91-93 Charterhouse Street EC1M 6HR London Boundary House Uk | United Kingdom | British | 162361480001 | |||||||||
| CROUCH, Jennifer Louise | Director | Charterhouse Square EC1M 6EH London 10-11 England | England | British | 199682550001 | |||||||||
| D'ALONZO, Fabio | Director | Charterhouse Square EC1M 6EH London 10-11 United Kingdom | United Kingdom | Italian | 151189940001 | |||||||||
| DALGLEISH, Bruce Warren | Director | Post Box House Abinger Road RH5 6HD Coldharbour Surrey | United Kingdom | British | 106281140002 | |||||||||
| DOUGLASS, Charlotte Sophie Ellen | Director | Phoenix Crescent Strathclyde Business Park ML4 3NJ Bellshill Avondale House, Suites 1l - 1o Scotland | England | British | 218330250001 | |||||||||
| DUCK, Andrew Neil | Director | Phoenix Crescent Strathclyde Business Park ML4 3NJ Bellshill Avondale House, Suites 1l - 1o Scotland | United Kingdom | British | 257809290001 | |||||||||
| FLETCHER, Dylan | Director | Croftlea 50 Kenilworth Road Bridge Of Allan FK9 4RS Stirling Stirlingshire | Scotland | British | 82097010004 | |||||||||
| GILL, Kenneth John | Director | 74 Pembroke Road Clifton BS8 3EG Bristol Avon | England | British | 66760430002 | |||||||||
| GROAT, Alison | Director | FK7 8HW Stirling Forth House Pirnhall Business Park Scotland | Scotland | British | 316594510001 | |||||||||
| JACK, Ronald Gilfillan | Director | c/o Sweett Group Apex House 95 Haymarket Terrace Edinburgh 95 Eh12 5lq Scotland | Scotland | British | 76530270002 | |||||||||
| JONES, Sion Laurence | Director | Charterhouse Square EC1M 6EH London 10-11 United Kingdom | United Kingdom | English | 137554960001 | |||||||||
| MCLELLAN, Kenneth Andrew | Director | Disraeli Way East Kilbride G74 5PU Glasgow 1 United Kingdom | United Kingdom | British | 110322970003 | |||||||||
| MCVEY, Philip | Director | Lochside View Edinburgh Park EH12 9DH Edinburgh 2 Midlothian | United Kingdom | British | 99001530002 | |||||||||
| O'BRIEN, Kirsty | Director | Suites 1b-1e, Phoenix Crescent Strathclyde Business Park ML4 3NJ Bellshill Avondale House North Lanarkshire Scotland | Scotland | British | 191923490001 | |||||||||
| PEARCE, Glenn Sinclair | Director | Suites 1b-1e, Phoenix Crescent Strathclyde Business Park ML4 3NJ Bellshill Avondale House North Lanarkshire Scotland | Scotland | British | 176131560002 | |||||||||
| RICKWOOD, Stephen Peter Ogilvy | Director | 22 Carrington Court 104 Green Dragon Lane N21 2LY London | England | British | 96586020002 | |||||||||
| RITCHIE, Alan Campbell | Director | 2 Lochside View Edinburgh Park EH12 9DH Edinburgh Miller House | United Kingdom | British | 241898940001 | |||||||||
| SCOTT, Alan Philip | Director | Harlaw Bank Balerno EH14 7HR Edinburgh 2 | Scotland | British | 182952430001 | |||||||||
| SMITH, David Niall | Director | Pirnhall Business Park FK7 8HW Stirling Forth House Scotland | United Kingdom | British | 197175530001 |
¿Quiénes son las personas con control significativo de E4I HOLDINGS LIMITED?
| Nombre | Notificado el | Dirección | Cesado | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Equitix Education 2 Limited | 05 ago 2016 | 200 Aldersgate Street EC1A 4HD London 3rd Floor, South Building England | No | ||||
| |||||||
Naturaleza del control
| |||||||
Fuente de datos
- Companies House del Reino Unido
El registro oficial de empresas en el Reino Unido, que proporciona acceso público a información sobre empresas, como nombres, direcciones, administradores y registros financieros. - Licencia: CC0