CONSORT HEALTHCARE (FIFE) INTERMEDIATE LIMITED
Visión general
| Nombre de la empresa | CONSORT HEALTHCARE (FIFE) INTERMEDIATE LIMITED |
|---|---|
| Estado de la empresa | Activa |
| Forma jurídica | Sociedad de responsabilidad limitada |
| Número de empresa | SC348867 |
| Jurisdicción | Escocia |
| Fecha de constitución |
Resumen
| Tiene PSCs súper seguros | No |
|---|---|
| Tiene gravámenes | No |
| Tiene historial de insolvencia | No |
| La sede social está en disputa | No |
¿Cuál es el propósito de CONSORT HEALTHCARE (FIFE) INTERMEDIATE LIMITED?
- Otras actividades de apoyo a los negocios n.c.p. (82990) / Actividades administrativas y de apoyo
¿Dónde se encuentra CONSORT HEALTHCARE (FIFE) INTERMEDIATE LIMITED?
| Dirección de la sede social | Exchange Tower 19 Canning Street EH3 8EH Edinburgh United Kingdom |
|---|---|
| Dirección de la sede social no entregable | No |
¿Cuáles son las últimas cuentas de CONSORT HEALTHCARE (FIFE) INTERMEDIATE LIMITED?
| Vencido | No |
|---|---|
| Próximas cuentas | |
| Próximo período contable finaliza el | 31 mar 2026 |
| Próximas cuentas vencen el | 31 dic 2026 |
| Últimas cuentas | |
| Últimas cuentas cerradas hasta | 31 mar 2025 |
¿Cuál es el estado de la última declaración de confirmación para CONSORT HEALTHCARE (FIFE) INTERMEDIATE LIMITED?
| Última declaración de confirmación cerrada hasta | 29 sept 2026 |
|---|---|
| Próxima declaración de confirmación vence | 13 oct 2026 |
| Última declaración de confirmación | |
| Próxima declaración de confirmación cerrada hasta | 29 sept 2025 |
| Vencido | No |
¿Cuáles son las últimas presentaciones para CONSORT HEALTHCARE (FIFE) INTERMEDIATE LIMITED?
| Fecha | Descripción | Documento | Tipo | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cese del nombramiento de Richard John Marshall como director el 01 oct 2025 | 1 páginas | TM01 | ||||||||||
Declaración de confirmación presentada el 29 sept 2025 sin actualizaciones | 3 páginas | CS01 | ||||||||||
Cuentas completas preparadas hasta el 31 mar 2025 | 20 páginas | AA | ||||||||||
Cuentas completas preparadas hasta el 31 mar 2024 | 20 páginas | AA | ||||||||||
Declaración de confirmación presentada el 30 sept 2024 sin actualizaciones | 3 páginas | CS01 | ||||||||||
Cancelación total de la carga 2 | 4 páginas | MR04 | ||||||||||
Cancelación total de la carga 1 | 4 páginas | MR04 | ||||||||||
Resoluciones Resolutions | 3 páginas | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
Registro de la carga SC3488670004, creada el 01 dic 2023 | 46 páginas | MR01 | ||||||||||
Registro de la carga SC3488670003, creada el 01 dic 2023 | 16 páginas | MR01 | ||||||||||
Cuentas completas preparadas hasta el 31 mar 2023 | 20 páginas | AA | ||||||||||
Declaración de confirmación presentada el 27 sept 2023 sin actualizaciones | 3 páginas | CS01 | ||||||||||
Nombramiento de Mr Richard John Marshall como director el 06 ene 2023 | 2 páginas | AP01 | ||||||||||
Cuentas completas preparadas hasta el 31 mar 2022 | 19 páginas | AA | ||||||||||
Declaración de confirmación presentada el 27 sept 2022 sin actualizaciones | 3 páginas | CS01 | ||||||||||
Domicilio social registrado cambiado de 1 Atlantic Quay 1 Robertson Street Glasgow Scotland G2 8JB Scotland a Exchange Tower 19 Canning Street Edinburgh EH3 8EH el 24 jun 2022 | 1 páginas | AD01 | ||||||||||
Cuentas completas preparadas hasta el 31 mar 2021 | 20 páginas | AA | ||||||||||
Declaración de confirmación presentada el 17 sept 2021 sin actualizaciones | 3 páginas | CS01 | ||||||||||
Exercice comptable précédent prolongé du 31 dic 2020 au 31 mar 2021 | 1 páginas | AA01 | ||||||||||
Cese del nombramiento de Desmond Mark French como director el 02 feb 2021 | 1 páginas | TM01 | ||||||||||
Nombramiento de Mr Desmond Mark French como director el 11 sept 2020 | 2 páginas | AP01 | ||||||||||
Declaración de confirmación presentada el 19 sept 2020 con actualizaciones | 4 páginas | CS01 | ||||||||||
Cuentas completas preparadas hasta el 31 dic 2019 | 20 páginas | AA | ||||||||||
Domicilio social registrado cambiado de Victoria Hospital (Gate 7), Hayfield Road Kirkcaldy KY2 5AH Scotland a 1 Atlantic Quay 1 Robertson Street Glasgow Scotland G2 8JB el 13 mar 2020 | 1 páginas | AD01 | ||||||||||
Cese del nombramiento de Darren Barclay como secretario el 01 mar 2020 | 1 páginas | TM02 | ||||||||||
¿Quiénes son los directivos de CONSORT HEALTHCARE (FIFE) INTERMEDIATE LIMITED?
| Nombre | Nombrado el | Renunció el | Rol | Dirección | Identificación de la empresa | País de residencia | Nacionalidad | Fecha de nacimiento | Ocupación | Número | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SEMPERIAN SECRETARIAT SERVICES LIMITED | Secretario corporativo | 1 Gresham Street EC2V 7BX London 4th Floor United Kingdom |
| 107624260005 | ||||||||||
| RAE, Neil, Mr. | Director | Gresham Street EC2V 7BX London 1 England | United Kingdom | British | 119437600003 | |||||||||
| RITCHIE, Alan Campbell | Director | Gresham Street EC2V 7BX London 4th Floor, 1 England | United Kingdom | British | 250928280001 | |||||||||
| ABERNETHY, Jennifer | Secretario | Parklands Avenue Eurocentral ML1 4WQ Holytown Maxim 7, Maxim Office Park United Kingdom | 224245890001 | |||||||||||
| BARCLAY, Darren | Secretario | Hunting Gate SG4 0TJ Hitchin 2 England | 250670560001 | |||||||||||
| BLISS, Daniel James | Secretario | Exchange Crescent Conference Square EH3 8UL Edinburgh 1 | 184711290001 | |||||||||||
| JENNAWAY, Simon | Secretario | Fountainbridge EH3 9AG Edinburgh 133 | British | 74352620001 | ||||||||||
| MARSHALL, Nigel John | Secretario | Fountainbridge EH3 9AG Edinburgh 133 | British | 175917940001 | ||||||||||
| SHUTT, Sarah | Secretario | Euston Road Regent's Place NW1 3AX London 350 United Kingdom | 236372360001 | |||||||||||
| WHITBREAD, Nuala | Secretario | Euston Rd NW1 3AX London 350 United Kingdom | 238695870002 | |||||||||||
| APPUHAMY, Ion Francis | Director | 72 Staunton Road KT2 5TL Kingston Upon Thames Surrey | United Kingdom | British | 110636430001 | |||||||||
| BLANCHARD, David Graham | Director | Mitchell Street EH6 7BD Edinburgh Summit House, 4-5 Scotland | United Kingdom | British | 131548650002 | |||||||||
| BUCKLEY, George Lawrence | Director | Euston Road Regent's Place NW1 3AX London 350 United Kingdom | England | English | 184710840001 | |||||||||
| COOPER, Phillip John | Director | Fountainbridge EH3 9AG Edinburgh 133 | United Kingdom | British | 116775310001 | |||||||||
| DEACON, Andrew | Director | Charles Ii Street SW1Y 4QU London 12 United Kingdom | United Kingdom | English | 199565850001 | |||||||||
| ENTRACT, Jonathan Mark | Director | 21 Weybridge Park KT13 8SQ Weybridge Surrey | England | British | 86046470002 | |||||||||
| FRENCH, Desmond Mark | Director | Atlantic Quay 1 Robertson Street G2 8JB Glasgow 1 Scotland Scotland | United Kingdom | Irish | 264714210001 | |||||||||
| GORDON, John Stephen | Director | Fountainbridge EH3 9AG Edinburgh 133 | United Kingdom | British | 149538970001 | |||||||||
| HOLDEN, Mark Geoffrey David | Director | Eden Park Road SK8 6RG Cheadle Hulme 7 Cheshire | England | British | 170508700001 | |||||||||
| LELEW, Nigel | Director | Euston Road NW1 3AX London 350 United Kingdom | England | British | 147087250001 | |||||||||
| LEWIS, David John | Director | Floor 350 Euston Road Regent's Place NW1 3AX London 6th United Kingdom | England | British | 136129100001 | |||||||||
| MARSHALL, Richard John | Director | Broad Quay House Prince Street BS1 4DJ Bristol Third Floor United Kingdom | England | British | 280292390001 | |||||||||
| NEWTON, Robert James | Director | Charles Ii Street SW1Y 4QU London 12 United Kingdom | United Kingdom | British | 295465260001 | |||||||||
| QUAIFE, Geoffrey Alan | Director | Exchange Crescent Conference Square EH3 8UL Edinburgh 1 | United Kingdom | British | 123048390001 | |||||||||
| QUAIFE, Geoffrey Alan | Director | Fountainbridge EH3 9AG Edinburgh 133 | United Kingdom | British | 123048390001 | |||||||||
| ROSS, Michael Melville Brown | Director | Fountainbridge EH3 9AG Edinburgh 133 | Uk | British | 114386250001 | |||||||||
| SPENCER, Christopher Loraine | Director | 143 Shooters Hill Road Blackheath SE3 8UQ London | United Kingdom | British | 111123420001 | |||||||||
| THOMPSON, Linda Jayne | Director | Fountainbridge EH3 9AG Edinburgh 133 | United Kingdom | British | 149417060001 | |||||||||
| WEGENER, Elena Giorgiana | Director | Charles Ii Street London SW1Y 4QU London 12 England England | England | British | 183219270001 | |||||||||
| TM COMPANY SERVICES LIMITED | Director corporativo | Fountainbridge EH3 9AG Edinburgh Edinburgh Quay, 133 | 37914570001 |
¿Quiénes son las personas con control significativo de CONSORT HEALTHCARE (FIFE) INTERMEDIATE LIMITED?
| Nombre | Notificado el | Dirección | Cesado | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Semperian Ppp Investment Partners No.2 Limited | 18 sept 2018 | Gresham Street EC2V 7BX London 4th Floor, 1 England | No | ||||||||||
| |||||||||||||
Naturaleza del control
| |||||||||||||
| Infrared Infrastructure Yield Holdings Limited | 06 abr 2016 | Charles Ii Street SW1Y 4QU London 12 England | Sí | ||||||||||
| |||||||||||||
Naturaleza del control
| |||||||||||||
| Consort Healthcare Infrastructure Investments Limited | 06 abr 2016 | Euston Road Regents Place NW1 3AX London 350 England | Sí | ||||||||||
| |||||||||||||
Naturaleza del control
| |||||||||||||
Fuente de datos
- Companies House del Reino Unido
El registro oficial de empresas en el Reino Unido, que proporciona acceso público a información sobre empresas, como nombres, direcciones, administradores y registros financieros. - Licencia: CC0