COMMUNITY LAND SCOTLAND

COMMUNITY LAND SCOTLAND

  • Visión general
  • Resumen
  • Propósito
  • Dirección
  • Cuentas
  • Declaración de confirmación
  • Presentaciones
  • Directivos
  • Declaraciones de personas con control significativo
  • Fuente de datos
  • Visión general

    Nombre de la empresaCOMMUNITY LAND SCOTLAND
    Estado de la empresaActiva
    Forma jurídicaSociedad de responsabilidad limitada por garantía sin capital social, exención del uso de 'Limited'
    Número de empresa SC385572
    JurisdicciónEscocia
    Fecha de constitución

    Resumen

    Tiene PSCs súper segurosNo
    Tiene gravámenesNo
    Tiene historial de insolvenciaNo
    La sede social está en disputaNo

    ¿Cuál es el propósito de COMMUNITY LAND SCOTLAND?

    • Actividades de otras organizaciones de miembros n.c.p. (94990) / Otras actividades de servicios

    ¿Dónde se encuentra COMMUNITY LAND SCOTLAND?

    Dirección de la sede social
    C/O Ainsley Smith & Co
    Argyll Square
    PA34 4AT Oban
    Scotland
    Dirección de la sede social no entregableNo

    ¿Cuáles son las últimas cuentas de COMMUNITY LAND SCOTLAND?

    VencidoNo
    Próximas cuentas
    Próximo período contable finaliza el31 mar 2026
    Próximas cuentas vencen el31 dic 2026
    Últimas cuentas
    Últimas cuentas cerradas hasta31 mar 2025

    ¿Cuál es el estado de la última declaración de confirmación para COMMUNITY LAND SCOTLAND?

    Última declaración de confirmación cerrada hasta08 oct 2026
    Próxima declaración de confirmación vence22 oct 2026
    Última declaración de confirmación
    Próxima declaración de confirmación cerrada hasta08 oct 2025
    VencidoNo

    ¿Cuáles son las últimas presentaciones para COMMUNITY LAND SCOTLAND?

    Presentaciones
    FechaDescripciónDocumentoTipo

    Cese del nombramiento de Ailsa Jane Raeburn como director el 10 dic 2025

    1 páginasTM01

    Nombramiento de Ms Sally Sue Reynolds como secretario el 12 dic 2025

    2 páginasAP03

    Cese del nombramiento de Linsay Chalmers como secretario el 12 dic 2025

    1 páginasTM02

    Cuentas de exención total completas preparadas hasta el 31 mar 2025

    19 páginasAA

    Nombramiento de Mr Michael Staples como director el 30 oct 2025

    2 páginasAP01

    Nombramiento de Ms Angela Judith Williams como director el 08 oct 2025

    2 páginasAP01

    Declaración de confirmación presentada el 08 oct 2025 sin actualizaciones

    3 páginasCS01

    Memorándum y Estatutos

    23 páginasMA

    Resoluciones

    Resolutions
    1 páginasRESOLUTIONS
    Acuerdos
    CategoríaFechaDescripciónTipo
    incorporation

    Resolución de modificación de los Artículos de Asociación

    RES01

    Nombramiento de Mr Martin Avila como director el 12 mar 2025

    2 páginasAP01

    Cese del nombramiento de Bridget Ann Ashrowan como director el 12 mar 2025

    1 páginasTM01

    Cese del nombramiento de Michael Staples como director el 23 ene 2025

    1 páginasTM01

    Cuentas de exención total completas preparadas hasta el 31 mar 2024

    18 páginasAA

    Declaración de confirmación presentada el 08 oct 2024 sin actualizaciones

    3 páginasCS01

    La dirección de inspección del registro se ha cambiado a Pearce Institute Govan Road Glasgow G51 3UU

    1 páginasAD02

    Nombramiento de Ms Rachel Helen Skene como director el 10 may 2024

    2 páginasAP01

    Cambio de datos del director Ms Megan Alison Chalmers el 16 may 2024

    2 páginasCH01

    Nombramiento de Ms Megan Alison Chalmers como director el 10 may 2024

    2 páginasAP01

    Cuentas de exención total completas preparadas hasta el 31 mar 2023

    19 páginasAA

    Cese del nombramiento de David Ewan Cameron como director el 11 oct 2023

    1 páginasTM01

    Declaración de confirmación presentada el 10 oct 2023 sin actualizaciones

    3 páginasCS01

    Cese del nombramiento de Magnus William Hamill Davidson como director el 21 sept 2023

    1 páginasTM01

    Cese del nombramiento de Martin Avila como director el 02 jun 2023

    1 páginasTM01

    Nombramiento de Ms Grace Mary Murray como director el 02 jun 2023

    2 páginasAP01

    Cese del nombramiento de Lincoln Douglas Richford como director el 02 jun 2023

    1 páginasTM01

    ¿Quiénes son los directivos de COMMUNITY LAND SCOTLAND?

    Directivos
    NombreNombrado elRenunció elRolDirecciónIdentificación de la empresaPaís de residenciaNacionalidadFecha de nacimientoOcupaciónNúmero
    REYNOLDS, Sally Sue
    Govan Road
    G51 3UU Glasgow
    Pearce Institute
    Scotland
    Secretario
    Govan Road
    G51 3UU Glasgow
    Pearce Institute
    Scotland
    343416850001
    AVILA, Martin
    Westergreens Avenue
    Kirkintilloch
    G66 4AQ Glasgow
    2
    Scotland
    Director
    Westergreens Avenue
    Kirkintilloch
    G66 4AQ Glasgow
    2
    Scotland
    ScotlandBritish265512630001
    MACINNES, Megan Alison
    Toscaig
    IV54 8LY Applecross
    Weaver's Cottage
    Scotland
    Director
    Toscaig
    IV54 8LY Applecross
    Weaver's Cottage
    Scotland
    ScotlandBritish323103900002
    MURRAY, Grace Mary
    2 Haypark Woods
    Stow
    Galashiels
    2
    United Kingdom
    Director
    2 Haypark Woods
    Stow
    Galashiels
    2
    United Kingdom
    ScotlandBritish252611040001
    RENNIE, Agnes
    Argyll Square
    PA34 4AT Oban
    C/O Ainsley Smith & Co
    Scotland
    Director
    Argyll Square
    PA34 4AT Oban
    C/O Ainsley Smith & Co
    Scotland
    ScotlandScottish190819170001
    SKENE, Rachel Helen
    Argyll Square
    PA34 4AT Oban
    C/O Ainsley Smith & Co
    Scotland
    Director
    Argyll Square
    PA34 4AT Oban
    C/O Ainsley Smith & Co
    Scotland
    ScotlandScottish323105420001
    STAPLES, Michael
    Argyll Square
    PA34 4AT Oban
    C/O Ainsley Smith & Co
    Scotland
    Director
    Argyll Square
    PA34 4AT Oban
    C/O Ainsley Smith & Co
    Scotland
    United KingdomBritish248115600001
    TODD, John Alexander
    Argyll Square
    PA34 4AT Oban
    C/O Ainsley Smith & Co
    Scotland
    Director
    Argyll Square
    PA34 4AT Oban
    C/O Ainsley Smith & Co
    Scotland
    ScotlandScottish303194660001
    WATT, John Alexander
    Argyll Square
    PA34 4AT Oban
    C/O Ainsley Smith & Co
    Scotland
    Director
    Argyll Square
    PA34 4AT Oban
    C/O Ainsley Smith & Co
    Scotland
    ScotlandBritish65560440001
    WILLIAMS, Angela Judith
    Argyll Square
    PA34 4AT Oban
    C/O Ainsley Smith & Co
    Scotland
    Director
    Argyll Square
    PA34 4AT Oban
    C/O Ainsley Smith & Co
    Scotland
    ScotlandBritish306209460001
    WIMPRESS, Kate
    Argyll Square
    PA34 4AT Oban
    21
    Scotland
    Director
    Argyll Square
    PA34 4AT Oban
    21
    Scotland
    ScotlandNorthern Irish300339520001
    CHALMERS, Linsay
    Argyll Square
    PA34 4AT Oban
    C/O Ainsley Smith & Co
    Scotland
    Secretario
    Argyll Square
    PA34 4AT Oban
    C/O Ainsley Smith & Co
    Scotland
    208794640001
    HUTCHISON, John Charles
    Scott Road
    HS3 3DL Tarbert
    Hill Cottage
    Isle Of Harris
    Secretario
    Scott Road
    HS3 3DL Tarbert
    Hill Cottage
    Isle Of Harris
    178929000001
    MACLEOD, Lorne Buchanan
    Crannaig-A-Mhinister
    PA34 4LU Oban
    Orasaig
    Argyll
    Uk
    Secretario
    Crannaig-A-Mhinister
    PA34 4LU Oban
    Orasaig
    Argyll
    Uk
    British155401840001
    ASHROWAN, Bridget Ann, Ms.
    Argyll Square
    PA34 4AT Oban
    C/O Ainsley Smith & Co
    Scotland
    Director
    Argyll Square
    PA34 4AT Oban
    C/O Ainsley Smith & Co
    Scotland
    ScotlandBritish179087720001
    AVILA, Martin
    Westergreens Avenue
    Kirkintilloch
    G66 4AQ Glasgow
    2 Westergreens Avenue, Kirkintilloch
    Scotland
    Director
    Westergreens Avenue
    Kirkintilloch
    G66 4AQ Glasgow
    2 Westergreens Avenue, Kirkintilloch
    Scotland
    ScotlandBritish265512630001
    CAMERON, David Ewan
    Argyll Square
    PA34 4AT Oban
    C/O Ainsley Smith & Co
    Scotland
    Director
    Argyll Square
    PA34 4AT Oban
    C/O Ainsley Smith & Co
    Scotland
    ScotlandBritish662470001
    DAVIDSON, Magnus William Hamill
    Strathmore Court
    KW14 7PS Thurso
    6 Strathmore Court, Thurso
    Scotland
    Director
    Strathmore Court
    KW14 7PS Thurso
    6 Strathmore Court, Thurso
    Scotland
    ScotlandBritish279172850001
    GIBSON, Morven Ettive
    Argyll Square
    PA34 4AT Oban
    C/O Ainsley Smith & Co
    Scotland
    Director
    Argyll Square
    PA34 4AT Oban
    C/O Ainsley Smith & Co
    Scotland
    ScotlandBritish148318070001
    HEPBURN, Ian Alexander
    Argyll Square
    PA34 4AZ Oban
    Ra Clements
    Scotland
    Director
    Argyll Square
    PA34 4AZ Oban
    Ra Clements
    Scotland
    ScotlandBritish154695370001
    HUNTER, James Robert, Professor
    Scott Road
    HS3 3DL Tarbert
    Hill Cottage
    Isle Of Harris
    Director
    Scott Road
    HS3 3DL Tarbert
    Hill Cottage
    Isle Of Harris
    ScotlandScottish149681900001
    HUTCHISON, John Charles
    Badabrie
    PH33 7LX Fort William
    Taigh Na Coille
    Invernessshire
    Scotland
    Director
    Badabrie
    PH33 7LX Fort William
    Taigh Na Coille
    Invernessshire
    Scotland
    ScotlandScottish122567540001
    MACIVER, Iain Maclennan
    Cromwell Street
    HS1 2DD Stornoway
    Leverhulme House
    Western Isles
    Director
    Cromwell Street
    HS1 2DD Stornoway
    Leverhulme House
    Western Isles
    ScotlandBritish154697060001
    MACLEOD, Lorne Buchanan
    Ganavan Road
    PA34 5TU Oban
    The Wheelhouse
    Argyll
    Scotland
    Director
    Ganavan Road
    PA34 5TU Oban
    The Wheelhouse
    Argyll
    Scotland
    ScotlandBritish80719590004
    MACLEOD, Lorne Buchanan
    Scott Road
    HS3 3DL Tarbert
    Hill Cottage
    Isle Of Harris
    Director
    Scott Road
    HS3 3DL Tarbert
    Hill Cottage
    Isle Of Harris
    ScotlandBritish80719590003
    MCSPORRAN, Margaret Agnes
    Scott Road
    HS3 3DL Tarbert
    Hill Cottage
    Isle Of Harris
    Director
    Scott Road
    HS3 3DL Tarbert
    Hill Cottage
    Isle Of Harris
    Great BritainScots168506860001
    NICOLSON, Margaret
    Scott Road
    HS3 3DL Tarbert
    Hill Cottage
    Isle Of Harris
    Director
    Scott Road
    HS3 3DL Tarbert
    Hill Cottage
    Isle Of Harris
    United KingdomScottish186128020001
    RAEBURN, Ailsa Jane
    Argyll Square
    PA34 4AT Oban
    C/O Ainsley Smith & Co
    Scotland
    Director
    Argyll Square
    PA34 4AT Oban
    C/O Ainsley Smith & Co
    Scotland
    ScotlandBritish225910350001
    RAEBURN, Ailsa Jane
    Achnamara
    PA31 8PT Lochgilphead
    Castle Sween Cottage
    Scotland
    Director
    Achnamara
    PA31 8PT Lochgilphead
    Castle Sween Cottage
    Scotland
    ScotlandBritish225910350001
    RICHFORD, Lincoln Douglas
    Argyll Square
    PA34 4AT Oban
    C/O Ainsley Smith & Co
    Scotland
    Director
    Argyll Square
    PA34 4AT Oban
    C/O Ainsley Smith & Co
    Scotland
    ScotlandBritish220225530001
    ROBERTSON, Angus Morrison
    Scott Road
    HS3 3DL Tarbert
    Hill Cottage
    Isle Of Harris
    Director
    Scott Road
    HS3 3DL Tarbert
    Hill Cottage
    Isle Of Harris
    ScotlandUk176922130001
    STAPLES, Michael
    Dunreggan
    Moniaive
    DG3 4HQ Thornhill
    Amberley
    Dumfries And Galloway
    United Kingdom
    Director
    Dunreggan
    Moniaive
    DG3 4HQ Thornhill
    Amberley
    Dumfries And Galloway
    United Kingdom
    United KingdomBritish248115600001
    WAWRZYCZEK, Joanna
    Suisnish Place
    Broadford
    IV49 9BZ Isle Of Skye
    4 Suisnish Place, Broadford
    Scotland
    Director
    Suisnish Place
    Broadford
    IV49 9BZ Isle Of Skye
    4 Suisnish Place, Broadford
    Scotland
    ScotlandPolish260528830001
    WILLIAMS, Angela Judith
    Scott Road
    HS3 3DL Tarbert
    Hill Cottage
    Isle Of Harris
    Director
    Scott Road
    HS3 3DL Tarbert
    Hill Cottage
    Isle Of Harris
    ScotlandBritish208820960001
    WILLIAMS, Angela Judith
    Scott Road
    HS3 3DL Tarbert
    Hill Cottage
    Isle Of Harris
    Director
    Scott Road
    HS3 3DL Tarbert
    Hill Cottage
    Isle Of Harris
    United KingdomUnited Kingdom154198680001

    ¿Cuáles son las últimas declaraciones sobre personas con control significativo para COMMUNITY LAND SCOTLAND?

    Declaraciones de personas con control significativo
    Notificado elCesado elDeclaración
    17 sept 2016La empresa sabe o tiene motivos razonables para creer que no existe ninguna persona registrable o entidad jurídica relevante registrable en relación con la empresa.

    Fuente de datos

    • Companies House del Reino Unido
      El registro oficial de empresas en el Reino Unido, que proporciona acceso público a información sobre empresas, como nombres, direcciones, administradores y registros financieros.
    • Licencia: CC0