SURESERVE ENERGY SERVICES UK LIMITED

SURESERVE ENERGY SERVICES UK LIMITED

  • Visión general
  • Resumen
  • Propósito
  • Dirección
  • Nombres anteriores
  • Cuentas
  • Declaración de confirmación
  • Presentaciones
  • Directivos
  • Personas con control significativo
  • Fuente de datos
  • Visión general

    Nombre de la empresaSURESERVE ENERGY SERVICES UK LIMITED
    Estado de la empresaActiva
    Forma jurídicaSociedad de responsabilidad limitada
    Número de empresa SC390210
    JurisdicciónEscocia
    Fecha de constitución

    Resumen

    Tiene PSCs súper segurosNo
    Tiene gravámenesNo
    Tiene historial de insolvenciaNo
    La sede social está en disputaNo

    ¿Cuál es el propósito de SURESERVE ENERGY SERVICES UK LIMITED?

    • Otras actividades de servicios n.c.p. (96090) / Otras actividades de servicios

    ¿Dónde se encuentra SURESERVE ENERGY SERVICES UK LIMITED?

    Dirección de la sede social
    3 Inchcorse Place
    Whitehill Industrial Estate
    EH48 2EE Bathgate
    Scotland
    Dirección de la sede social no entregableNo

    ¿Cuáles fueron los nombres anteriores de SURESERVE ENERGY SERVICES UK LIMITED?

    Nombres anteriores de la empresa
    Nombre de la empresaDesdeHasta
    EVERWARM LTD16 may 201116 may 2011
    INSULATION DIRECT SERVICES LIMITED10 dic 201010 dic 2010

    ¿Cuáles son las últimas cuentas de SURESERVE ENERGY SERVICES UK LIMITED?

    VencidoNo
    Próximas cuentas
    Próximo período contable finaliza el30 sept 2025
    Próximas cuentas vencen el30 jun 2026
    Últimas cuentas
    Últimas cuentas cerradas hasta30 sept 2024

    ¿Cuál es el estado de la última declaración de confirmación para SURESERVE ENERGY SERVICES UK LIMITED?

    Última declaración de confirmación cerrada hasta10 nov 2026
    Próxima declaración de confirmación vence24 nov 2026
    Última declaración de confirmación
    Próxima declaración de confirmación cerrada hasta10 nov 2025
    VencidoNo

    ¿Cuáles son las últimas presentaciones para SURESERVE ENERGY SERVICES UK LIMITED?

    Presentaciones
    FechaDescripciónDocumentoTipo

    Cese del nombramiento de John Spencer Sheridan como director el 20 ene 2026

    1 páginasTM01

    Declaración de confirmación presentada el 10 nov 2025 con actualizaciones

    5 páginasCS01

    Registro de la carga SC3902100012, creada el 17 sept 2025

    21 páginasMR01

    Estado de capital tras una asignación de acciones el 21 may 2025

    • Capital: GBP 10,001
    3 páginasSH01

    Cancelación total de la carga SC3902100011

    4 páginasMR04

    Cancelación total de la carga SC3902100010

    4 páginasMR04

    Resoluciones

    Resolutions
    2 páginasRESOLUTIONS
    Acuerdos
    CategoríaFechaDescripciónTipo
    capital

    Resolución de asignación de valores

    RES10

    Cambio de datos del director Mr. Robert Stirling el 21 may 2025

    2 páginasCH01

    Estado de capital el 23 may 2025

    • Capital: GBP 10,001
    3 páginasSH19

    legacy

    1 páginasSH20

    legacy

    1 páginasCAP-SS

    Resoluciones

    Resolutions
    2 páginasRESOLUTIONS
    Acuerdos
    CategoríaFechaDescripciónTipo
    capital

    Resolución de reducción del capital social emitido

    RES06
    capital

    Resoluciones

    Reduction of share premium account from £18,249,482.67 to £nil 21/05/2025
    RES13

    Cuentas completas preparadas hasta el 30 sept 2024

    27 páginasAA

    Modification des détails de Sureserve Energy Services Limited en tant que personne disposant d'un contrôle significatif le 07 feb 2025

    2 páginasPSC05

    Declaración de confirmación presentada el 10 dic 2024 sin actualizaciones

    3 páginasCS01

    Certificado de cambio de nombre

    Company name changed everwarm LTD\certificate issued on 06/12/24
    3 páginasCERTNM
    Presentaciones asociadas
    CategoríaFechaDescripciónTipo
    change-of-name06 dic 2024

    Aviso de cambio de nombre

    CONNOT

    Resoluciones

    Resolutions
    1 páginasRESOLUTIONS
    Acuerdos
    CategoríaFechaDescripciónTipo
    change-of-name

    Resolución de cambio de nombre de la empresa el 19 nov 2024

    RES15

    Resoluciones

    Resolutions
    1 páginasRESOLUTIONS
    Acuerdos
    CategoríaFechaDescripciónTipo
    change-of-name

    Resolución de cambio de nombre de la empresa el 19 nov 2024

    RES15

    Modification des détails de Sureserve Energy Services Limited en tant que personne disposant d'un contrôle significatif le 08 abr 2024

    2 páginasPSC05

    Nombramiento de Mr Paul John Edwards como director el 16 may 2024

    2 páginasAP01

    Nombramiento de Mr Spencer John Sheridan como director el 16 may 2024

    2 páginasAP01

    Cuentas completas preparadas hasta el 30 sept 2023

    28 páginasAA

    Nombramiento de Mr Geoffrey Ronald Mayhill como secretario el 01 may 2024

    2 páginasAP03

    Cese del nombramiento de John William Charles Charlton como secretario el 01 may 2024

    1 páginasTM02

    Memorándum y Estatutos

    11 páginasMA

    ¿Quiénes son los directivos de SURESERVE ENERGY SERVICES UK LIMITED?

    Directivos
    NombreNombrado elRenunció elRolDirecciónIdentificación de la empresaPaís de residenciaNacionalidadFecha de nacimientoOcupaciónNúmero
    MAYHILL, Geoffrey Ronald
    Inchcorse Place
    Whitehill Industrial Estate
    EH48 2EE Bathgate
    3
    Scotland
    Secretario
    Inchcorse Place
    Whitehill Industrial Estate
    EH48 2EE Bathgate
    3
    Scotland
    322727820001
    EDWARDS, John Paul
    Inchcorse Place
    Whitehill Industrial Estate
    EH48 2EE Bathgate
    3
    Scotland
    Director
    Inchcorse Place
    Whitehill Industrial Estate
    EH48 2EE Bathgate
    3
    Scotland
    EnglandBritish61489610001
    LEVINSOHN, Graham Austen
    Inchcorse Place
    Whitehill Industrial Estate
    EH48 2EE Bathgate
    3
    Scotland
    Director
    Inchcorse Place
    Whitehill Industrial Estate
    EH48 2EE Bathgate
    3
    Scotland
    EnglandBritish254321290002
    STIRLING, Robert, Mr.
    Inchcorse Place
    Whitehill Industrial Estate
    EH48 2EE Bathgate
    3
    Scotland
    Director
    Inchcorse Place
    Whitehill Industrial Estate
    EH48 2EE Bathgate
    3
    Scotland
    ScotlandBritish161206330002
    BROIDER, Philip David
    King George Close
    RM7 7LS Romford
    1
    Essex
    Great Britain
    Secretario
    King George Close
    RM7 7LS Romford
    1
    Essex
    Great Britain
    187066010001
    CHARLTON, John William Charles
    Inchcorse Place
    Whitehill Industrial Estate
    EH48 2EE Bathgate
    3
    Scotland
    Secretario
    Inchcorse Place
    Whitehill Industrial Estate
    EH48 2EE Bathgate
    3
    Scotland
    230682790001
    HOWELL, Simon John
    Melville Street
    EH3 7PE Edinburgh
    3-5 Melville Street
    Scotland
    Secretario
    Melville Street
    EH3 7PE Edinburgh
    3-5 Melville Street
    Scotland
    188413580001
    MCMAHON, Micheal
    Rutland Square
    EH1 2BD Edinburgh
    14
    Midlothian
    Scotland
    Secretario
    Rutland Square
    EH1 2BD Edinburgh
    14
    Midlothian
    Scotland
    British157066970001
    TRAINER, Peter
    Lauriston Street
    EH3 9DQ Edinburgh
    27
    Scotland
    Secretario
    Lauriston Street
    EH3 9DQ Edinburgh
    27
    Scotland
    British135727620001
    BIRRANE, Sean Thomas
    Melville Street
    EH3 7PE Edinburgh
    3-5 Melville Street
    Scotland
    Director
    Melville Street
    EH3 7PE Edinburgh
    3-5 Melville Street
    Scotland
    EnglandBritish101296120004
    BLACK, Stuart John
    King George Close
    RM7 7LS Romford
    1
    Essex
    Great Britain
    Director
    King George Close
    RM7 7LS Romford
    1
    Essex
    Great Britain
    United KingdomBritish49053310001
    CHARLTON, John William Charles
    Inchcorse Place
    Whitehill Industrial Estate
    EH48 2EE Bathgate
    3
    Scotland
    Director
    Inchcorse Place
    Whitehill Industrial Estate
    EH48 2EE Bathgate
    3
    Scotland
    EnglandBritish119598150002
    COX, Alan Robert
    King George Close
    RM7 7LS Romford
    1
    England
    Director
    King George Close
    RM7 7LS Romford
    1
    England
    EnglandBritish119020860001
    GRAHAM, Lydia
    Melville Street
    EH3 7PE Edinburgh
    3-5 Melville Street
    Scotland
    Director
    Melville Street
    EH3 7PE Edinburgh
    3-5 Melville Street
    Scotland
    United KingdomBritish1386390002
    MCINTOSH, Susan
    Lauriston Street
    EH3 9DQ Edinburgh
    27
    Scotland
    Director
    Lauriston Street
    EH3 9DQ Edinburgh
    27
    Scotland
    ScotlandBritish44652340001
    MCMAHON, Michael, Mr.
    Melville Street
    EH3 7PE Edinburgh
    3-5 Melville Street
    Scotland
    Director
    Melville Street
    EH3 7PE Edinburgh
    3-5 Melville Street
    Scotland
    ScotlandBritish159906060001
    RAWLINGS, Steven Edward
    King George Close
    RM7 7LS Romford
    1
    Essex
    Great Britain
    Director
    King George Close
    RM7 7LS Romford
    1
    Essex
    Great Britain
    Great BritainBritish182864270001
    SAUNDERS, Kennedy Forrester
    Melville Street
    EH3 7PE Edinburgh
    3-5 Melville Street
    Scotland
    Director
    Melville Street
    EH3 7PE Edinburgh
    3-5 Melville Street
    Scotland
    ScotlandBritish959650004
    SHERIDAN, John Spencer
    Inchcorse Place
    Whitehill Industrial Estate
    EH48 2EE Bathgate
    3
    Scotland
    Director
    Inchcorse Place
    Whitehill Industrial Estate
    EH48 2EE Bathgate
    3
    Scotland
    EnglandBritish238643210001
    SIMPSON, Jeremy John Cobbett
    Melville Street
    EH3 7PE Edinburgh
    3-5 Melville Street
    Scotland
    Director
    Melville Street
    EH3 7PE Edinburgh
    3-5 Melville Street
    Scotland
    EnglandBritish189596740001
    SMITH, Peter David Mawby
    Inchcorse Place
    Whitehill Industrial Estate
    EH48 2EE Bathgate
    3
    Scotland
    Director
    Inchcorse Place
    Whitehill Industrial Estate
    EH48 2EE Bathgate
    3
    Scotland
    EnglandBritish159286600001
    TRAINER, Peter
    Lauriston Street
    EH3 9DQ Edinburgh
    27
    Scotland
    Director
    Lauriston Street
    EH3 9DQ Edinburgh
    27
    Scotland
    ScotlandBritish135727620001
    VOHRA, Sam
    Inchcorse Place
    Whitehill Industrial Estate
    EH48 2EE Bathgate
    3
    Scotland
    Director
    Inchcorse Place
    Whitehill Industrial Estate
    EH48 2EE Bathgate
    3
    Scotland
    EnglandBritish312387440001
    VOHRA, Sameet
    Inchcorse Place
    Whitehill Industrial Estate
    EH48 2EE Bathgate
    3
    Scotland
    Director
    Inchcorse Place
    Whitehill Industrial Estate
    EH48 2EE Bathgate
    3
    Scotland
    EnglandBritish126382440002

    ¿Quiénes son las personas con control significativo de SURESERVE ENERGY SERVICES UK LIMITED?

    Personas con control significativo
    NombreNotificado elDirecciónCesado
    Sureserve Energy Holdings Limited
    13 Southampton Place
    WC1A 2JA London
    Norfolk House
    England
    30 jun 2016
    13 Southampton Place
    WC1A 2JA London
    Norfolk House
    England
    No
    Forma jurídicaPrivate Limited Company
    País de registroEngland
    Autoridad legalCompanies Act 2006
    Lugar de registroEngland And Wales
    Número de registro09790912
    Naturaleza del control
    • La persona posee, directa o indirectamente, más del 75% de las acciones de la compañía.
    • La persona posee, directa o indirectamente, más del 75% de los derechos de voto en la empresa.
    • La persona tiene el derecho, directa o indirectamente, de nombrar o destituir a la mayoría de la junta directiva de la empresa.

    Fuente de datos

    • Companies House del Reino Unido
      El registro oficial de empresas en el Reino Unido, que proporciona acceso público a información sobre empresas, como nombres, direcciones, administradores y registros financieros.
    • Licencia: CC0