IN THIS TOGETHER

  • Visión general
  • Resumen
  • Propósito
  • Dirección
  • Nombres anteriores
  • Cuentas
  • Presentaciones
  • Directivos
  • Declaraciones de personas con control significativo
  • Fuente de datos
  • Visión general

    Nombre de la empresaIN THIS TOGETHER
    Estado de la empresaDisuelta
    Forma jurídicaSociedad de responsabilidad limitada por garantía sin capital social, exención del uso de 'Limited'
    Número de empresa SC394375
    JurisdicciónEscocia
    Fecha de constitución
    Fecha de cese

    Resumen

    Tiene PSCs súper segurosNo
    Tiene gravámenesNo
    Tiene historial de insolvenciaNo
    La sede social está en disputaNo

    ¿Cuál es el propósito de IN THIS TOGETHER?

    • Otras actividades de servicios n.c.p. (96090) / Otras actividades de servicios

    ¿Dónde se encuentra IN THIS TOGETHER?

    Dirección de la sede social
    In This Together Cafe In This Together
    86 Church Street
    IV1 1EP Inverness
    Scotland
    Dirección de la sede social no entregableNo

    ¿Cuáles fueron los nombres anteriores de IN THIS TOGETHER?

    Nombres anteriores de la empresa
    Nombre de la empresaDesdeHasta
    IN THIS TOGETHER LTD24 may 201924 may 2019
    SIGNPOST INC04 oct 201104 oct 2011
    VOLUNTEERING MATTERS28 feb 201128 feb 2011

    ¿Cuáles son las últimas cuentas de IN THIS TOGETHER?

    Últimas cuentas
    Últimas cuentas cerradas hasta31 mar 2019

    ¿Cuáles son las últimas presentaciones para IN THIS TOGETHER?

    Presentaciones
    FechaDescripciónDocumentoTipo

    Boletín oficial final disuelto por cancelación voluntaria

    1 páginasGAZ2(A)

    La acción de exclusión voluntaria ha sido suspendida

    1 páginasSOAS(A)

    Primer aviso en el boletín oficial para la cancelación voluntaria

    1 páginasGAZ1(A)

    Solicitud de exclusión de la empresa del registro

    1 páginasDS01

    Domicilio social registrado cambiado de 86 Church Street 86 Church Street Inverness Inverness IV1 1EP Scotland a In This Together Cafe in This Together 86 Church Street Inverness IV1 1EP el 17 jun 2020

    1 páginasAD01

    Domicilio social registrado cambiado de 5/7 Tomnahurich Street Inverness IV3 5DA a 86 Church Street 86 Church Street Inverness Inverness IV1 1EP el 17 jun 2020

    1 páginasAD01

    Declaración de confirmación presentada el 29 feb 2020 sin actualizaciones

    3 páginasCS01

    Cuentas de exención total completas preparadas hasta el 31 mar 2019

    23 páginasAA

    Certificado de cambio de nombre

    Company name changed in this together LTD\certificate issued on 20/06/19
    3 páginasCERTNM
    Presentaciones asociadas
    CategoríaFechaDescripciónTipo
    change-of-name20 jun 2019

    Exención de cambio de nombre del uso de "limitada" o "cyfyngedig"

    NE01

    Resoluciones

    Resolutions
    3 páginasRESOLUTIONS
    Presentaciones asociadas
    CategoríaFechaDescripciónTipo
    change-of-name24 may 2019

    Cambio de nombre por resolución

    NM01
    Acuerdos
    CategoríaFechaDescripciónTipo
    change-of-name

    Resolución de cambio de nombre de la empresa el 14 feb 2019

    RES15

    Declaración de confirmación presentada el 28 feb 2019 sin actualizaciones

    3 páginasCS01

    Nombramiento de Mr Stephen James Graham como director el 15 ene 2019

    2 páginasAP01

    Cuentas de exención total completas preparadas hasta el 31 mar 2018

    22 páginasAA

    Cese del nombramiento de Penelope Anne Gray como director el 07 nov 2018

    1 páginasTM01

    Cese del nombramiento de Sarah Shaw como director el 07 nov 2018

    1 páginasTM01

    Cese del nombramiento de Sandra Watson como director el 04 jun 2018

    1 páginasTM01

    Declaración de confirmación presentada el 28 feb 2018 sin actualizaciones

    3 páginasCS01

    Nombramiento de Ms Amanda Smith como director el 10 nov 2017

    2 páginasAP01

    Nombramiento de Mr Peter Kane como director el 10 nov 2017

    2 páginasAP01

    Cese del nombramiento de Martin Tolhurst como director el 23 nov 2017

    1 páginasTM01

    Cuentas de exención total completas preparadas hasta el 31 mar 2017

    22 páginasAA

    Cese del nombramiento de David Ronald Evans como director el 17 may 2017

    1 páginasTM01

    Declaración de confirmación presentada el 28 feb 2017 con actualizaciones

    4 páginasCS01

    Cuentas de exención total completas preparadas hasta el 31 mar 2016

    18 páginasAA

    Nombramiento de Mr Martin Tolhurst como director el 10 ago 2016

    2 páginasAP01

    ¿Quiénes son los directivos de IN THIS TOGETHER?

    Directivos
    NombreNombrado elRenunció elRolDirecciónIdentificación de la empresaPaís de residenciaNacionalidadFecha de nacimientoOcupaciónNúmero
    GRAHAM, Stephen James
    Briargrove Gardens
    Inshes
    IV2 5AH Inverness
    15
    Scotland
    Director
    Briargrove Gardens
    Inshes
    IV2 5AH Inverness
    15
    Scotland
    ScotlandBritish122354500001
    KANE, Peter John Fitzgerald
    In This Together
    86 Church Street
    IV1 1EP Inverness
    In This Together Cafe
    Scotland
    Director
    In This Together
    86 Church Street
    IV1 1EP Inverness
    In This Together Cafe
    Scotland
    ScotlandBritish206457140001
    SMITH, Amanda
    In This Together
    86 Church Street
    IV1 1EP Inverness
    In This Together Cafe
    Scotland
    Director
    In This Together
    86 Church Street
    IV1 1EP Inverness
    In This Together Cafe
    Scotland
    ScotlandBritish244870500001
    BARNETT, Douglas Michael
    Delnies
    IV12 5NT Nairn
    Drumdelnies
    Scotland
    Uk
    Secretario
    Delnies
    IV12 5NT Nairn
    Drumdelnies
    Scotland
    Uk
    158100800001
    GRIGOR, Isobel
    Station Square
    Academy Street
    IV1 1LE Inverness
    Highland Rail House
    Secretario
    Station Square
    Academy Street
    IV1 1LE Inverness
    Highland Rail House
    162195640001
    ADDISON, Iain William
    Millburn Road
    IV2 3PX Inverness
    The Gateway, 1a
    Inverness
    Scotland
    Director
    Millburn Road
    IV2 3PX Inverness
    The Gateway, 1a
    Inverness
    Scotland
    ScotlandBritish131075970001
    BARNETT, Douglas Michael
    Delnies
    IV12 5NT Nairn
    Drumdelnies
    Scotland
    Uk
    Director
    Delnies
    IV12 5NT Nairn
    Drumdelnies
    Scotland
    Uk
    United KingdomBritish41071890001
    DAVIDSON, Margaret Christine
    Station Square
    Academy Street
    IV1 1LE Inverness
    Highland Rail House
    Director
    Station Square
    Academy Street
    IV1 1LE Inverness
    Highland Rail House
    ScotlandEnglish92067960001
    DINGWALL, Pauline Anne
    Station Square
    Academy Street
    IV1 1LE Inverness
    Highland Rail House
    Director
    Station Square
    Academy Street
    IV1 1LE Inverness
    Highland Rail House
    ScotlandBritish128541960001
    EVANS, David Ronald
    Tomnahurich Street
    IV3 5DA Inverness
    5/7
    Director
    Tomnahurich Street
    IV3 5DA Inverness
    5/7
    United KingdomBritish204149590002
    FORD, John
    Tomnahurich Street
    IV3 5DA Inverness
    5/7
    Director
    Tomnahurich Street
    IV3 5DA Inverness
    5/7
    ScotlandBritish206217610001
    GRAY, Penelope Anne
    Swordale Road
    Evanton
    IV16 9UZ Dingwall
    Inshoch House
    Ross-Shire
    Scotland
    Director
    Swordale Road
    Evanton
    IV16 9UZ Dingwall
    Inshoch House
    Ross-Shire
    Scotland
    ScotlandBritish88221950001
    GRIGOR, Isobel Kay, Dr
    Station Square
    Academy Street
    IV1 1LE Inverness
    Highland Rail House
    Director
    Station Square
    Academy Street
    IV1 1LE Inverness
    Highland Rail House
    Uk (Scotland)Uk (Scottish)71547470001
    GRIGOR, Isobel Kay, Dr
    Redfield
    North Kessock
    IV1 3XD Inverness
    Creagan
    Uk
    Director
    Redfield
    North Kessock
    IV1 3XD Inverness
    Creagan
    Uk
    Uk (Scotland)Uk (Scottish)71547470001
    INGLIS, Tom
    Tomnahurich Street
    IV3 5DA Inverness
    5/7
    Scotland
    Director
    Tomnahurich Street
    IV3 5DA Inverness
    5/7
    Scotland
    ScotlandBritish182386390001
    JONES, Lesley Gillian
    Tomnahurich Street
    IV3 5DA Inverness
    5/7
    Scotland
    Director
    Tomnahurich Street
    IV3 5DA Inverness
    5/7
    Scotland
    ScotlandBritish120380500001
    LEAVER, Andrew Colin
    1a Millburn Road
    IV2 3PX Inverness
    The Gateway
    Scotland
    Director
    1a Millburn Road
    IV2 3PX Inverness
    The Gateway
    Scotland
    ScotlandBritish131519620001
    MACDONALD, Shirley
    Station Square
    IV1 1LA Inverness
    Highland Rail House
    Scotland
    Director
    Station Square
    IV1 1LA Inverness
    Highland Rail House
    Scotland
    ScotlandBritish182386150001
    MCBRIDE, Philip
    Station Square
    Academy Street
    IV1 1LE Inverness
    Highland Rail House
    Director
    Station Square
    Academy Street
    IV1 1LE Inverness
    Highland Rail House
    United KingdomScottish30125130001
    MCDONALD, Gillian
    1a Millburn Road
    IV2 3PX Inverness
    The Gateway
    Scotland
    Director
    1a Millburn Road
    IV2 3PX Inverness
    The Gateway
    Scotland
    United KingdomBritish119424920001
    MCLENNAN, Okain John
    1a Millburn Road
    IV2 3PX Inverness
    The Gateway
    Scotland
    United Kingdom
    Director
    1a Millburn Road
    IV2 3PX Inverness
    The Gateway
    Scotland
    United Kingdom
    ScotlandBritish111413710001
    MCMORRAN, Tracy
    Station Square
    Academy Street
    IV1 1LE Inverness
    Highland Rail House
    Director
    Station Square
    Academy Street
    IV1 1LE Inverness
    Highland Rail House
    ScotlandBritish166861200001
    NOTT, Bernice
    Tomnahurich Street
    IV3 5DA Inverness
    5/7
    Scotland
    Director
    Tomnahurich Street
    IV3 5DA Inverness
    5/7
    Scotland
    United KingdomBritish166860320001
    NOTT, Violet Brownlie
    Tomnahurich Street
    IV3 5DA Inverness
    5/7
    Scotland
    Director
    Tomnahurich Street
    IV3 5DA Inverness
    5/7
    Scotland
    ScotlandBritish28403700003
    SHAW, Sarah
    Wade Road
    IV2 3DG Inverness
    10
    United Kingdom
    Director
    Wade Road
    IV2 3DG Inverness
    10
    United Kingdom
    United KingdomBritish212264100001
    SWINTON, Johnson Masterton
    1a Millburn Road
    IV2 3PX Inverness
    The Gateway
    Scotland
    Director
    1a Millburn Road
    IV2 3PX Inverness
    The Gateway
    Scotland
    Scotland. UkBritish137260030001
    TOLHURST, Martin
    Thurlow Road
    IV12 4HJ Nairn
    The Little House
    United Kingdom
    Director
    Thurlow Road
    IV12 4HJ Nairn
    The Little House
    United Kingdom
    United KingdomBritish212264460001
    WATSON, Sandra
    Old Bar View
    IV12 5BY Nairn
    6
    Scotland
    Director
    Old Bar View
    IV12 5BY Nairn
    6
    Scotland
    ScotlandBritish206223000001

    ¿Cuáles son las últimas declaraciones sobre personas con control significativo para IN THIS TOGETHER?

    Declaraciones de personas con control significativo
    Notificado elCesado elDeclaración
    28 feb 2017La empresa sabe o tiene motivos razonables para creer que no existe ninguna persona registrable o entidad jurídica relevante registrable en relación con la empresa.

    Fuente de datos

    • Companies House del Reino Unido
      El registro oficial de empresas en el Reino Unido, que proporciona acceso público a información sobre empresas, como nombres, direcciones, administradores y registros financieros.
    • Licencia: CC0