FREEFLOW TECHNOLOGIES LIMITED

FREEFLOW TECHNOLOGIES LIMITED

  • Visión general
  • Resumen
  • Propósito
  • Dirección
  • Nombres anteriores
  • Cuentas
  • Declaración de confirmación
  • Presentaciones
  • Directivos
  • Personas con control significativo
  • Declaraciones de personas con control significativo
  • Gravámenes
  • Insolvencia
  • Fuente de datos
  • Visión general

    Nombre de la empresaFREEFLOW TECHNOLOGIES LIMITED
    Estado de la empresaLiquidación
    Forma jurídicaSociedad de responsabilidad limitada
    Número de empresa SC420118
    JurisdicciónEscocia
    Fecha de constitución

    Resumen

    Tiene PSCs súper segurosNo
    Tiene gravámenes
    Tiene historial de insolvencia
    La sede social está en disputaNo

    ¿Cuál es el propósito de FREEFLOW TECHNOLOGIES LIMITED?

    • fabricación de bicicletas y coches para inválidos (30920) / Industrias manufactureras

    ¿Dónde se encuentra FREEFLOW TECHNOLOGIES LIMITED?

    Dirección de la sede social
    Titanium 1 King's Inch Place
    PA4 8WF Renfrew
    Dirección de la sede social no entregableNo

    ¿Cuáles fueron los nombres anteriores de FREEFLOW TECHNOLOGIES LIMITED?

    Nombres anteriores de la empresa
    Nombre de la empresaDesdeHasta
    PACIFIC SHELF 1699 LIMITED22 mar 201222 mar 2012

    ¿Cuáles son las últimas cuentas de FREEFLOW TECHNOLOGIES LIMITED?

    Vencido
    Próximas cuentas
    Próximo período contable finaliza el31 mar 2024
    Próximas cuentas vencen el31 dic 2024
    Últimas cuentas
    Últimas cuentas cerradas hasta31 mar 2023

    ¿Cuál es el estado de la última declaración de confirmación para FREEFLOW TECHNOLOGIES LIMITED?

    Vencido
    Última declaración de confirmación cerrada hasta22 mar 2024
    Próxima declaración de confirmación vence05 abr 2024
    Última declaración de confirmación
    Próxima declaración de confirmación cerrada hasta22 mar 2023
    Vencido

    ¿Cuáles son las últimas presentaciones para FREEFLOW TECHNOLOGIES LIMITED?

    Presentaciones
    FechaDescripciónDocumentoTipo

    Cese del nombramiento de David Hemming como director el 31 mar 2024

    1 páginasTM01

    Cese del nombramiento de James Maxwell Mcgowan como director el 31 mar 2024

    1 páginasTM01

    Nombramiento de Mr James Maxwell Mcgowan como director el 01 mar 2024

    2 páginasAP01

    Cese del nombramiento de Christopher John Wiles como director el 31 mar 2024

    1 páginasTM01

    Cese del nombramiento de Steve Mcmahon como director el 31 mar 2024

    1 páginasTM01

    Orden judicial en una liquidación (y adjunto de la orden judicial)

    4 páginasWU01(Scot)

    Domicilio social registrado cambiado de Third Floor 1 West Regent Street Glasgow G2 1RW Scotland a Titanium 1 King's Inch Place Renfrew PA4 8WF el 06 mar 2024

    3 páginasAD01

    Nombramiento de un liquidador provisional en un proceso de liquidación por el tribunal (& Anexo: Orden judicial)

    4 páginasWU02(Scot)

    Cese del nombramiento de William David Martin Milton como director el 31 dic 2023

    1 páginasTM01

    Cancelación total de la carga SC4201180001

    1 páginasMR04

    Cese del nombramiento de Neil Simeon Edwards como director el 19 oct 2023

    1 páginasTM01

    Cuentas de exención total completas preparadas hasta el 31 mar 2023

    15 páginasAA

    Cese del nombramiento de Martin Mccourt como director el 30 jun 2023

    1 páginasTM01

    Memorándum y Estatutos

    31 páginasMA

    Resoluciones

    Resolutions
    1 páginasRESOLUTIONS
    Acuerdos
    CategoríaFechaDescripciónTipo
    capital

    Resolución de asignación de valores

    RES10
    capital

    Resolución de eliminación de derechos de suscripción preferente

    RES11
    incorporation

    Resolución de adopción de los Artículos de Asociación

    RES01

    Estado de capital tras una asignación de acciones el 16 jun 2023

    • Capital: GBP 5.095694
    3 páginasSH01

    Nombramiento de Mr Steve Mcmahon como director el 01 may 2023

    2 páginasAP01

    Declaración de confirmación presentada el 22 mar 2023 con actualizaciones

    13 páginasCS01

    Registro de la carga SC4201180001, creada el 20 mar 2023

    19 páginasMR01

    Domicilio social registrado cambiado de 1 Third Floor 1 West Regent Street Glasgow G2 1RW Scotland a Third Floor 1 West Regent Street Glasgow G2 1RW el 04 oct 2022

    1 páginasAD01

    Domicilio social registrado cambiado de 1 West Regent Street Third Floor 1 West Regent Street Glasgow G2 1RW Scotland a 1 Third Floor 1 West Regent Street Glasgow G2 1RW el 04 oct 2022

    1 páginasAD01

    Domicilio social registrado cambiado de 1 West Regent Street Glasgow G2 1RW a 1 West Regent Street Third Floor 1 West Regent Street Glasgow G2 1RW el 04 oct 2022

    1 páginasAD01

    Cuentas de exención total completas preparadas hasta el 31 mar 2022

    14 páginasAA

    Nombramiento de Mr William David Martin Milton como director el 01 jun 2022

    2 páginasAP01

    Estado de capital tras una asignación de acciones el 23 may 2022

    • Capital: GBP 4.663091
    3 páginasSH01

    ¿Quiénes son los directivos de FREEFLOW TECHNOLOGIES LIMITED?

    Directivos
    NombreNombrado elRenunció elRolDirecciónIdentificación de la empresaPaís de residenciaNacionalidadFecha de nacimientoOcupaciónNúmero
    MD SECRETARIES LIMITED
    Bothwell Street
    G2 7EQ Glasgow
    C/O Mcgrigors Llp. 141
    Secretario corporativo
    Bothwell Street
    G2 7EQ Glasgow
    C/O Mcgrigors Llp. 141
    Tipo de identificaciónEEE
    Número de registroSC104964
    117456920001
    PINSENT MASONS SECRETARIAL LIMITED
    Park Row
    LS1 5AB Leeds
    1
    Yorkshire
    United Kingdom
    Secretario corporativo
    Park Row
    LS1 5AB Leeds
    1
    Yorkshire
    United Kingdom
    Tipo de identificaciónEEE
    Número de registro02318923
    76579530001
    CONNON, Roger Gordon
    Rose Street
    AB10 1UD Aberdeen
    Johnstone House, 52-54
    Director
    Rose Street
    AB10 1UD Aberdeen
    Johnstone House, 52-54
    ScotlandBritish162158150001
    EDWARDS, Neil Simeon
    1 West Regent Street
    G2 1RW Glasgow
    Third Floor
    Scotland
    Director
    1 West Regent Street
    G2 1RW Glasgow
    Third Floor
    Scotland
    United KingdomBritish223843610001
    HAYWOOD, Thomas Edward
    West Regent Street
    G2 1RW Glasgow
    1
    Director
    West Regent Street
    G2 1RW Glasgow
    1
    EnglandBritish251471360001
    HEMMING, David
    King's Inch Place
    PA4 8WF Renfrew
    Titanium 1
    Director
    King's Inch Place
    PA4 8WF Renfrew
    Titanium 1
    EnglandBritish264344170001
    MACMARTIN, Neil
    Cathkin Brae Farm
    Rutherglen
    G73 5RG Glasgow
    Unit 5
    United Kingdom
    Director
    Cathkin Brae Farm
    Rutherglen
    G73 5RG Glasgow
    Unit 5
    United Kingdom
    United KingdomBritish122475890001
    MCCOURT, Martin
    1 West Regent Street
    G2 1RW Glasgow
    Third Floor
    Scotland
    Director
    1 West Regent Street
    G2 1RW Glasgow
    Third Floor
    Scotland
    United KingdomBritish98643020003
    MCEWING, David
    Rose Street
    AB10 1UD Aberdeen
    Johnstone House, 52-54
    Director
    Rose Street
    AB10 1UD Aberdeen
    Johnstone House, 52-54
    United KingdomBritish137839130001
    MCGOWAN, James Maxwell
    King's Inch Place
    PA4 8WF Renfrew
    Titanium 1
    Director
    King's Inch Place
    PA4 8WF Renfrew
    Titanium 1
    ScotlandBritish232629700001
    MCMAHON, Steve
    c/o Freeflow Technologies Limited
    Nasmyth Avenue
    East Kilbride
    G75 0QR Glasgow
    Nasmyth Building
    Scotland
    Director
    c/o Freeflow Technologies Limited
    Nasmyth Avenue
    East Kilbride
    G75 0QR Glasgow
    Nasmyth Building
    Scotland
    ScotlandBritish308913000001
    MILTON, William David Martin
    1 West Regent Street
    G2 1RW Glasgow
    Third Floor
    Scotland
    Director
    1 West Regent Street
    G2 1RW Glasgow
    Third Floor
    Scotland
    United KingdomBritish98577440002
    SHEPHERD, James
    West Regent Street
    G2 1RW Glasgow
    1
    Director
    West Regent Street
    G2 1RW Glasgow
    1
    United KingdomBritish219010270001
    WILES, Christopher John
    King's Inch Place
    PA4 8WF Renfrew
    Titanium 1
    Director
    King's Inch Place
    PA4 8WF Renfrew
    Titanium 1
    EnglandBritish264344990001

    ¿Quiénes son las personas con control significativo de FREEFLOW TECHNOLOGIES LIMITED?

    Personas con control significativo
    NombreNotificado elDirecciónCesado
    Chief Technology Officer Neil Macmartin
    Monroe Avenue
    East Kilbride
    G75 8WA Glasgow
    10
    Scotland
    06 abr 2016
    Monroe Avenue
    East Kilbride
    G75 8WA Glasgow
    10
    Scotland
    Nacionalidad: British
    País de residencia: Scotland
    Naturaleza del control
    • La persona posee, directa o indirectamente, más del 50% pero no más del 75% de las acciones de la compañía.
    • La persona posee, directa o indirectamente, más del 50% pero no más del 75% de los derechos de voto en la empresa.

    ¿Cuáles son las últimas declaraciones sobre personas con control significativo para FREEFLOW TECHNOLOGIES LIMITED?

    Declaraciones de personas con control significativo
    Notificado elCesado elDeclaración
    22 mar 2021La empresa sabe o tiene motivos razonables para creer que no existe ninguna persona registrable o entidad jurídica relevante registrable en relación con la empresa.

    ¿Tiene FREEFLOW TECHNOLOGIES LIMITED alguna carga?

    Gravámenes
    ClasificaciónFechasEstadoDetalles
    A registered charge
    Creado el 20 mar 2023
    Entregado el 20 mar 2023
    Satisfecho en su totalidad
    Breve descripción
    The client charges, by way of first legal mortgage all the land now owned by it.. “Land” is:. 1. freehold, leasehold or commonhold land;. 2. any estate or interest in, and any rights attaching or relating to, that land; and. 3. any buildings, fixtures and fittings (including trade fixtures and fittings) and other equipment attached to, situated on or forming part of that land.. The client charges, by way of first fixed charge, all of the rights which it now has and all of the rights which it obtains at any time in the future in intellectual property.. “Intellectual property” is:. 1. any intellectual property acquired after the date of this deed which is designated as intellectual property by the client and the lender on or about the time of its acquisition; and. 2. all other copyright (including rights in computer software), patents, trade marks, trade names, service marks, business names (including internet domain names), design rights, database rights, semi-conductor topography rights and all other intellectual property or similar proprietary rights (whether registered or not and including applications to register or rights to apply for registration) which, in each case, are of a type which are not disposed of in the ordinary course of trading.
    La garantía flotante cubre todo:
    Contiene una promesa negativa:
    Contiene una garantía flotante:
    Contiene una garantía fija:
    Personas con derecho
    • Sprk Capital Limited
    Transacciones
    • 20 mar 2023Registro de una carga (MR01)
    • 09 nov 2023Satisfacción de una carga (MR04)

    ¿Tiene FREEFLOW TECHNOLOGIES LIMITED algún caso de insolvencia?

    Número de expedienteFechasTipoProfesionalesOtro
    1
    FechaTipo
    26 mar 2024Fecha de la petición
    26 mar 2024Inicio de la liquidación
    Liquidación forzosa
    NombreRolDirecciónNombrado elCesado el
    Blair Milne
    Titanium 1 Kings Inch Place
    PA4 8WF Renfrew
    Renfrewshire
    Profesional
    Titanium 1 Kings Inch Place
    PA4 8WF Renfrew
    Renfrewshire
    James Fennessey
    Titanium 1 Kings Inch Place
    PA4 8WF Renfrew
    Glasgow
    Profesional
    Titanium 1 Kings Inch Place
    PA4 8WF Renfrew
    Glasgow
    Notasscottish-insolvency-info

    Fuente de datos

    • Companies House del Reino Unido
      El registro oficial de empresas en el Reino Unido, que proporciona acceso público a información sobre empresas, como nombres, direcciones, administradores y registros financieros.
    • Licencia: CC0