HUB WEST SCOTLAND HOLDCO (NO.4) LIMITED
Visión general
| Nombre de la empresa | HUB WEST SCOTLAND HOLDCO (NO.4) LIMITED |
|---|---|
| Estado de la empresa | Activa |
| Forma jurídica | Sociedad de responsabilidad limitada |
| Número de empresa | SC497611 |
| Jurisdicción | Escocia |
| Fecha de constitución |
Resumen
| Tiene PSCs súper seguros | No |
|---|---|
| Tiene gravámenes | No |
| Tiene historial de insolvencia | No |
| La sede social está en disputa | No |
¿Cuál es el propósito de HUB WEST SCOTLAND HOLDCO (NO.4) LIMITED?
- Desarrollo de proyectos de construcción (41100) / Construcción
¿Dónde se encuentra HUB WEST SCOTLAND HOLDCO (NO.4) LIMITED?
| Dirección de la sede social | C/O Foresight Group Clarence House 131-135 George Street EH2 4JS Edinburgh United Kingdom |
|---|---|
| Dirección de la sede social no entregable | No |
¿Cuáles fueron los nombres anteriores de HUB WEST SCOTLAND HOLDCO (NO.4) LIMITED?
| Nombre de la empresa | Desde | Hasta |
|---|---|---|
| HUB WEST SCOTLAND MIDCO (NO.4) LIMITED | 12 feb 2015 | 12 feb 2015 |
¿Cuáles son las últimas cuentas de HUB WEST SCOTLAND HOLDCO (NO.4) LIMITED?
| Vencido | No |
|---|---|
| Próximas cuentas | |
| Próximo período contable finaliza el | 31 mar 2026 |
| Próximas cuentas vencen el | 31 dic 2026 |
| Últimas cuentas | |
| Últimas cuentas cerradas hasta | 31 mar 2025 |
¿Cuál es el estado de la última declaración de confirmación para HUB WEST SCOTLAND HOLDCO (NO.4) LIMITED?
| Última declaración de confirmación cerrada hasta | 12 feb 2026 |
|---|---|
| Próxima declaración de confirmación vence | 26 feb 2026 |
| Última declaración de confirmación | |
| Próxima declaración de confirmación cerrada hasta | 12 feb 2025 |
| Vencido | No |
¿Cuáles son las últimas presentaciones para HUB WEST SCOTLAND HOLDCO (NO.4) LIMITED?
| Fecha | Descripción | Documento | Tipo | |
|---|---|---|---|---|
Cuentas para una empresa pequeña preparadas hasta el 31 mar 2025 | 13 páginas | AA | ||
Cambio de datos del director Mrs Michelle Hughes el 29 jul 2025 | 2 páginas | CH01 | ||
Nombramiento de Mr Stewart William Small como director el 01 abr 2025 | 2 páginas | AP01 | ||
Declaración de confirmación presentada el 12 feb 2025 sin actualizaciones | 3 páginas | CS01 | ||
Cuentas para una empresa pequeña preparadas hasta el 31 mar 2024 | 13 páginas | AA | ||
Nombramiento de Mrs Michelle Hughes como director el 23 sept 2024 | 2 páginas | AP01 | ||
Cese del nombramiento de Craig William Jardine como director el 21 ago 2024 | 1 páginas | TM01 | ||
Cese del nombramiento de Nial Watson Gemmell como director el 29 feb 2024 | 1 páginas | TM01 | ||
Nombramiento de Mrs Ruth Mairi Hann como director el 05 mar 2024 | 2 páginas | AP01 | ||
Nombramiento de Mr Alastair William Nicol como director el 01 mar 2024 | 2 páginas | AP01 | ||
Declaración de confirmación presentada el 12 feb 2024 con actualizaciones | 5 páginas | CS01 | ||
Cese del nombramiento de Gordon James Shirreff como director el 30 nov 2023 | 1 páginas | TM01 | ||
Cuentas para una empresa pequeña preparadas hasta el 31 mar 2023 | 15 páginas | AA | ||
Domicilio social registrado cambiado de The Lighthouse 2nd Floor 11 Mitchell Lane Glasgow G1 3NU United Kingdom a C/O Foresight Group Clarence House 131-135 George Street Edinburgh EH2 4JS el 25 jul 2023 | 1 páginas | AD01 | ||
Cese del nombramiento de Bina Tailor como director el 20 jun 2023 | 1 páginas | TM01 | ||
Notification de Blackmead Hub West Limited en tant que personne disposant d'un contrôle significatif le 20 jun 2023 | 2 páginas | PSC02 | ||
Nombramiento de Mr James Thomas Lloyd como director el 20 jun 2023 | 2 páginas | AP01 | ||
Cese del nombramiento de Richard John Dixon como director el 20 jun 2023 | 1 páginas | TM01 | ||
Cese del nombramiento de Clare Sheridan como secretario el 20 jun 2023 | 1 páginas | TM02 | ||
Cessation de Wellspring Partnership Limited en tant que personne disposant d'un contrôle significatif le 20 jun 2023 | 1 páginas | PSC07 | ||
Declaración de confirmación presentada el 12 feb 2023 sin actualizaciones | 3 páginas | CS01 | ||
Cambio de datos del director Mr Craig William Jardine el 06 jun 2022 | 2 páginas | CH01 | ||
Cambio de datos del director Mr Richard John Dixon el 26 abr 2022 | 2 páginas | CH01 | ||
Cuentas para una empresa pequeña preparadas hasta el 31 mar 2022 | 15 páginas | AA | ||
Nombramiento de Mr Craig William Jardine como director el 28 abr 2022 | 2 páginas | AP01 | ||
¿Quiénes son los directivos de HUB WEST SCOTLAND HOLDCO (NO.4) LIMITED?
| Nombre | Nombrado el | Renunció el | Rol | Dirección | Identificación de la empresa | País de residencia | Nacionalidad | Fecha de nacimiento | Ocupación | Número | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HANN, Ruth Mairi | Director | 91 Haymarket Terrace EH12 5HE Edinburgh Sft, Fourth Floor United Kingdom | Scotland | British | 289345220001 | |||||||||
| LLOYD, James Thomas | Director | Clarence House 131-135 George Street EH2 4JS Edinburgh C/O Foresight Group United Kingdom | United Kingdom | British | 279200720001 | |||||||||
| LYNN, Michelle | Director | Church Street G81 1QL Dumbarton 16 United Kingdom | United Kingdom | British | 327401240002 | |||||||||
| NICOL, Alastair William | Director | Fourth Floor, 91 Haymarket Terrace EH12 5HE Edinburgh The Scottish Futures Trust United Kingdom | United Kingdom | British | 183296710001 | |||||||||
| SMALL, Stewart William | Director | Aldersgate Street 3rd Floor, South Building EC1A 4HD London 200 United Kingdom | United Kingdom | British | 302497750001 | |||||||||
| SHERIDAN, Clare | Secretario | 14-17 Market Place W1W 8AJ London Kent House United Kingdom | 197566900001 | |||||||||||
| ASSET MANAGEMENT SOLUTIONS LTD | Secretario corporativo | Charles Street CF10 2GE Cardiff 46 United Kingdom |
| 194942610001 | ||||||||||
| BADHAM, Nigel Paul | Director | Old Jewry 6th Floor EC2R 8DN London 8 England And Wales United Kingdom | England | British | 194593210009 | |||||||||
| BADHAM, Nigel Paul | Director | 8 Elliot Place G3 8EP Glasgow Suite 7/3, Skypark 1, Scotland | England | British | 194593210009 | |||||||||
| CAMPBELL, Colin Malcolm | Director | Skypark 1 8 Elliot Place G3 8EP Glasgow Suite 7/3 United Kingdom | United Kingdom | British | 76823200003 | |||||||||
| CURRAN, Anthony | Director | Jb Russell House, Gartnavel Royal Hospital Campus 1055 Great Western Road G12 0XH Glasgow C/O Greater Glasgow Health Board United Kingdom | Uk | British | 204831270002 | |||||||||
| DIXON, Richard John | Director | 14-17 Market Place W1W 8AJ London Kent House United Kingdom | United Kingdom | British | 267912110017 | |||||||||
| DREW, Richard Stephen | Director | Adastral Park IP5 3RE Ipswich Columba House England England | United Kingdom | British | 111864530001 | |||||||||
| DRYBURGH, John William | Director | Berrington SY56HB Shrewsbury Berrington House Shropshire England | United Kingdom | British | 109305470002 | |||||||||
| ERLAM, Westley Alan | Director | Old Jewry 6th Floor EC2R 8DN London 8 England And Wales United Kingdom | United Kingdom | British | 279666060001 | |||||||||
| FARLEY, George Peter | Director | Furnival Street EC4A 1AB London 10 United Kingdom | United Kingdom | British | 123834510002 | |||||||||
| GEMMELL, Nial Watson | Director | 11-15 Thistle Street EH2 1DF Edinburgh Scottish Futures Trust Scotland Scotland | Scotland | British | 176999390001 | |||||||||
| GOURLAY, Alastair Graham | Director | Furnival Street EC4A 1AB London 10 United Kingdom | United Kingdom | British | 133856680001 | |||||||||
| HARROP, Benjamin James | Director | 6th Floor W1W 3ET London 8 Old Jewry | United Kingdom | British | 168494030003 | |||||||||
| HOPE, John Alexander | Director | 8 Elliot Place G3 8EP Glasgow Suite 7/3, Skypark 1, Scotland | United Kingdom | British | 71318590003 | |||||||||
| JARDINE, Craig William | Director | 16 Church Street G82 1QL Dumbarton West Dunbartonshire Council United Kingdom | United Kingdom | Scottish | 206377350001 | |||||||||
| JARDINE, Craig William | Director | Council Offices Garshake Road G82 3PU Dumbarton West Dunbartonshire Council Scotland | United Kingdom | Scottish | 206377350001 | |||||||||
| KING, James Leonard | Director | 8 Elliot Place G3 8EP Glasgow Suite 7/3, Skypark 1, Scotland | United Kingdom | British | 181479290001 | |||||||||
| LANE, David George | Director | St John Street EC1M 4EH London 100 United Kingdom | England | British | 160668630001 | |||||||||
| MACDONALD, Andrew Edward Douglas | Director | Old Jewry 6th Floor EC2R 8DN London 8 England And Wales United Kingdom | England | British | 154478030001 | |||||||||
| MATTHEWS, William Stewart | Director | Skypark 1 8 Elliot Place G3 8EP Glasgow Suite 7/3 United Kingdom | Scotland | British | 69372990001 | |||||||||
| MCCROSSAN, Margaret Brown Porteous | Director | 8 Elliot Place G3 8EP Glasgow Suite 7/3, Skypark 1, Scotland | United Kingdom | British | 179597170001 | |||||||||
| OTTI, Henry | Director | St John Street EC1M 4EH London 100 United Kingdom | England | British | 259088930001 | |||||||||
| POWELL, Andrew John | Director | Old Jewry 6th Floor EC2R 8DN London 8 England And Wales United Kingdom | England | British | 121982700003 | |||||||||
| RICHARDSON, Ben Peter | Director | 6th Floor 8 Old Jewry EC2R 8DN London 8 England | United Kingdom | British | 206173220001 | |||||||||
| SCENNA, Lisa | Director | Old Jewry 6th Floor EC2R 8DN London 8 England And Wales United Kingdom | United Kingdom | Australian | 126881800002 | |||||||||
| SHIRREFF, Gordon James | Director | 11-15 Thistle Street EH2 1DF Edinburgh Scottish Futures Trust Scotland Scotland | United Kingdom | British | 220299710001 | |||||||||
| TAILOR, Bina | Director | Kent House 14-17 Market Place W1W 8AJ London C/O Morgan Sindall Group Plc United Kingdom | United Kingdom | British | 276656960001 | |||||||||
| TITMUS, Adam John | Director | St John Street EC1M 4EH London 100 United Kingdom | United Kingdom | British | 249256530001 | |||||||||
| WEST, Stephen Campbell | Director | Council Offices Garshake Road G82 3PU Dumbarton West Dunbartonshire Council Scotland | Scotland | British | 190436720001 |
¿Quiénes son las personas con control significativo de HUB WEST SCOTLAND HOLDCO (NO.4) LIMITED?
| Nombre | Notificado el | Dirección | Cesado | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Blackmead Hub West Limited | 20 jun 2023 | The Shard 32 London Bridge Street SE1 9SG London C/O Foresight Group Llp United Kingdom United Kingdom | No | ||||||||||
| |||||||||||||
Naturaleza del control
| |||||||||||||
| Wellspring Partnership Limited | 06 abr 2016 | 1 Rutland Court EH3 8EY Edinburgh C/O Anderson Strathern United Kingdom | Sí | ||||||||||
| |||||||||||||
Naturaleza del control
| |||||||||||||
Fuente de datos
- Companies House del Reino Unido
El registro oficial de empresas en el Reino Unido, que proporciona acceso público a información sobre empresas, como nombres, direcciones, administradores y registros financieros. - Licencia: CC0