HUB SW DALBEATTIE DBFM CO LIMITED

HUB SW DALBEATTIE DBFM CO LIMITED

  • Visión general
  • Resumen
  • Propósito
  • Dirección
  • Nombres anteriores
  • Cuentas
  • Declaración de confirmación
  • Presentaciones
  • Directivos
  • Personas con control significativo
  • Fuente de datos
  • Visión general

    Nombre de la empresaHUB SW DALBEATTIE DBFM CO LIMITED
    Estado de la empresaActiva
    Forma jurídicaSociedad de responsabilidad limitada
    Número de empresa SC506019
    JurisdicciónEscocia
    Fecha de constitución

    Resumen

    Tiene PSCs súper segurosNo
    Tiene gravámenesNo
    Tiene historial de insolvenciaNo
    La sede social está en disputaNo

    ¿Cuál es el propósito de HUB SW DALBEATTIE DBFM CO LIMITED?

    • Arrendamiento financiero (64910) / Actividades financieras y de seguros

    ¿Dónde se encuentra HUB SW DALBEATTIE DBFM CO LIMITED?

    Dirección de la sede social
    Avondale House Suites 1b-1e, Phoenix Crescent
    Strathclyde Business Park
    ML4 3NJ Bellshill
    North Lanarkshire
    Scotland
    Dirección de la sede social no entregableNo

    ¿Cuáles fueron los nombres anteriores de HUB SW DALBEATTIE DBFM CO LIMITED?

    Nombres anteriores de la empresa
    Nombre de la empresaDesdeHasta
    HUB SW DALBEATTIE SUB HUB CO LIMITED15 may 201515 may 2015

    ¿Cuáles son las últimas cuentas de HUB SW DALBEATTIE DBFM CO LIMITED?

    VencidoNo
    Próximas cuentas
    Próximo período contable finaliza el31 dic 2025
    Próximas cuentas vencen el30 sept 2026
    Últimas cuentas
    Últimas cuentas cerradas hasta31 dic 2024

    ¿Cuál es el estado de la última declaración de confirmación para HUB SW DALBEATTIE DBFM CO LIMITED?

    Última declaración de confirmación cerrada hasta15 may 2026
    Próxima declaración de confirmación vence29 may 2026
    Última declaración de confirmación
    Próxima declaración de confirmación cerrada hasta15 may 2025
    VencidoNo

    ¿Cuáles son las últimas presentaciones para HUB SW DALBEATTIE DBFM CO LIMITED?

    Presentaciones
    FechaDescripciónDocumentoTipo

    replacement-filing-of-director-appointment-with-name

    3 páginasRP01AP01

    Cese del nombramiento de Colin John Freeman como director el 25 nov 2025

    1 páginasTM01

    Nombramiento de Mr Kevin Alistair Cunningham como director el 23 oct 2025

    2 páginasAP01

    Cese del nombramiento de Alexander William Gallon como secretario el 01 nov 2025

    1 páginasTM02

    Nombramiento de Equitix Management Services Limited como secretario el 01 nov 2025

    2 páginasAP04

    Nombramiento de Mr Alexander William Gallon como secretario el 06 ago 2025

    2 páginasAP03

    Cese del nombramiento de Daniela Radulescu como secretario el 06 ago 2025

    1 páginasTM02

    Cese del nombramiento de Glenn Sinclair Pearce como director el 01 jul 2025

    1 páginasTM01

    Cuentas para una empresa pequeña preparadas hasta el 31 dic 2024

    22 páginasAA

    Declaración de confirmación presentada el 15 may 2025 sin actualizaciones

    3 páginasCS01

    Cambio de datos del director Mr Stewart William Small el 25 nov 2024

    2 páginasCH01

    Nombramiento de Mr Glenn Sinclair Pearce como director el 01 oct 2024

    2 páginasAP01

    Nombramiento de Colin John Freeman como director el 18 jul 2024

    2 páginasAP01

    Cese del nombramiento de Craig Bernard Young como director el 01 jul 2024

    1 páginasTM01

    Cuentas para una empresa pequeña preparadas hasta el 31 dic 2023

    22 páginasAA

    Domicilio social registrado cambiado de Avondale House, Suites 1L - 1O Phoenix Crescent Strathclyde Business Park Bellshill North Lanarkshire ML4 3NJ Scotland a Avondale House Suites 1B-1E, Phoenix Crescent Strathclyde Business Park Bellshill North Lanarkshire ML4 3NJ el 06 jun 2024

    1 páginasAD01

    Declaración de confirmación presentada el 15 may 2024 sin actualizaciones

    3 páginasCS01

    Cese del nombramiento de Paul Mcculloch como director el 15 abr 2024

    1 páginasTM01

    Cese del nombramiento de Nial Watson Gemmell como director el 29 feb 2024

    1 páginasTM01

    Nombramiento de Ruth Mairi Hann como director el 29 feb 2024

    3 páginasAP01
    Anotaciones
    FechaAnotación
    18 dic 2025Replaced A replacement AP01 was registered on 18/12/2025.

    Cese del nombramiento de Michael Joseph Mcbrearty como director el 22 dic 2023

    1 páginasTM01

    Cuentas para una empresa pequeña preparadas hasta el 31 dic 2022

    21 páginasAA

    Declaración de confirmación presentada el 15 may 2023 sin actualizaciones

    3 páginasCS01

    Cese del nombramiento de Glenn Sinclair Pearce como director el 07 dic 2022

    1 páginasTM01

    Nombramiento de Mr Stewart William Small como director el 07 dic 2022

    2 páginasAP01

    ¿Quiénes son los directivos de HUB SW DALBEATTIE DBFM CO LIMITED?

    Directivos
    NombreNombrado elRenunció elRolDirecciónIdentificación de la empresaPaís de residenciaNacionalidadFecha de nacimientoOcupaciónNúmero
    EQUITIX MANAGEMENT SERVICES LIMITED
    200 Aldersgate Street
    EC1A 4HD London
    3rd Floor (South)
    United Kingdom
    Secretario corporativo
    200 Aldersgate Street
    EC1A 4HD London
    3rd Floor (South)
    United Kingdom
    Tipo de identificaciónSociedad limitada del Reino Unido
    Número de registro06904246
    342191500001
    AGOUN, Mohammed Ilies
    Suites 1b-1e, Phoenix Crescent
    Strathclyde Business Park
    ML4 3NJ Bellshill
    Avondale House
    North Lanarkshire
    Scotland
    Director
    Suites 1b-1e, Phoenix Crescent
    Strathclyde Business Park
    ML4 3NJ Bellshill
    Avondale House
    North Lanarkshire
    Scotland
    United KingdomBritish299696770001
    CUNNINGHAM, Kevin Alistair
    Suites 1b-1e, Phoenix Crescent
    Strathclyde Business Park
    ML4 3NJ Bellshill
    Avondale House
    North Lanarkshire
    Scotland
    Director
    Suites 1b-1e, Phoenix Crescent
    Strathclyde Business Park
    ML4 3NJ Bellshill
    Avondale House
    North Lanarkshire
    Scotland
    United KingdomScottish271263600001
    HANN, Ruth Mairi
    Suites 1b-1e, Phoenix Crescent
    Strathclyde Business Park
    ML4 3NJ Bellshill
    Avondale House
    North Lanarkshire
    Scotland
    Director
    Suites 1b-1e, Phoenix Crescent
    Strathclyde Business Park
    ML4 3NJ Bellshill
    Avondale House
    North Lanarkshire
    Scotland
    ScotlandBritish289345220001
    NICOL, Alastair William
    Thistle Street
    EH2 1DF Edinburgh
    11 - 15
    Scotland
    Director
    Thistle Street
    EH2 1DF Edinburgh
    11 - 15
    Scotland
    United KingdomBritish183296710001
    SMALL, Stewart William
    Cobalt Square
    83-85 Hagley Road
    B16 8QG Birmingham
    9th Floor
    United Kingdom
    Director
    Cobalt Square
    83-85 Hagley Road
    B16 8QG Birmingham
    9th Floor
    United Kingdom
    United KingdomBritish302497750001
    GALLON, Alexander William
    Suites 1b-1e, Phoenix Crescent
    Strathclyde Business Park
    ML4 3NJ Bellshill
    Avondale House
    North Lanarkshire
    Scotland
    Secretario
    Suites 1b-1e, Phoenix Crescent
    Strathclyde Business Park
    ML4 3NJ Bellshill
    Avondale House
    North Lanarkshire
    Scotland
    338856880001
    RADULESCU, Daniela
    Suites 1b-1e, Phoenix Crescent
    Strathclyde Business Park
    ML4 3NJ Bellshill
    Avondale House
    North Lanarkshire
    Scotland
    Secretario
    Suites 1b-1e, Phoenix Crescent
    Strathclyde Business Park
    ML4 3NJ Bellshill
    Avondale House
    North Lanarkshire
    Scotland
    250188520001
    THAKRAR, Amit Rishi Jaysukh
    Phoenix Crescent
    Strathclyde Business Park
    ML4 3NJ Bellshill
    Avondale House, Suites 1l - 1o
    North Lanarkshire
    Scotland
    Secretario
    Phoenix Crescent
    Strathclyde Business Park
    ML4 3NJ Bellshill
    Avondale House, Suites 1l - 1o
    North Lanarkshire
    Scotland
    199927520001
    BILL, Andrew Kerr
    Phoenix Crescent
    Strathclyde Business Park
    ML4 3NJ Bellshill
    Avondale House, Suites 1l - 1o
    North Lanarkshire
    Scotland
    Director
    Phoenix Crescent
    Strathclyde Business Park
    ML4 3NJ Bellshill
    Avondale House, Suites 1l - 1o
    North Lanarkshire
    Scotland
    Northern IrelandBritish135805560001
    FAIRBANK, Graham Bruce
    Tempsford Hall
    Sandy
    Tempsford Hall
    Bedfordshire
    United Kingdom
    Director
    Tempsford Hall
    Sandy
    Tempsford Hall
    Bedfordshire
    United Kingdom
    EnglandBritish153133930001
    FREEMAN, Colin John
    Suites 1b-1e, Phoenix Crescent
    Strathclyde Business Park
    ML4 3NJ Bellshill
    Avondale House
    North Lanarkshire
    Scotland
    Director
    Suites 1b-1e, Phoenix Crescent
    Strathclyde Business Park
    ML4 3NJ Bellshill
    Avondale House
    North Lanarkshire
    Scotland
    United KingdomBritish326812390001
    GEMMELL, Nial Watson
    Thistle Street
    EH2 1DF Edinburgh
    11-15
    Scotland
    Director
    Thistle Street
    EH2 1DF Edinburgh
    11-15
    Scotland
    ScotlandBritish176999390001
    HOPE, John Alexander
    Phoenix Crescent
    Strathclyde Business Park
    ML4 3NJ Bellshill
    Avondale House, Suites 1l - 1o
    North Lanarkshire
    Scotland
    Director
    Phoenix Crescent
    Strathclyde Business Park
    ML4 3NJ Bellshill
    Avondale House, Suites 1l - 1o
    North Lanarkshire
    Scotland
    United KingdomBritish71318590003
    LEWIS, Catherine Victoria
    Bankend Road
    High West
    DG1 4TG Crichton Hall
    Nhs Dumfries And Galloway
    Dumfries
    United Kingdom
    Director
    Bankend Road
    High West
    DG1 4TG Crichton Hall
    Nhs Dumfries And Galloway
    Dumfries
    United Kingdom
    United KingdomBritish191693250001
    LINDSAY, Derek Maxwell
    Barns Park
    KA7 2AH Ayr
    2
    Scotland
    Director
    Barns Park
    KA7 2AH Ayr
    2
    Scotland
    United KingdomScottish200206490001
    MACKINLAY, Gavin William
    Phoenix Crescent
    Strathclyde Business Park
    ML4 3NJ Bellshill
    Avondale House, Suites 1l - 1o
    North Lanarkshire
    Scotland
    Director
    Phoenix Crescent
    Strathclyde Business Park
    ML4 3NJ Bellshill
    Avondale House, Suites 1l - 1o
    North Lanarkshire
    Scotland
    EnglandBritish177047570001
    MCBREARTY, Michael Joseph
    Phoenix Crescent
    Strathclyde Business Park
    ML4 3NJ Bellshill
    Avondale House, Suites 1l - 1o
    North Lanarkshire
    Scotland
    Director
    Phoenix Crescent
    Strathclyde Business Park
    ML4 3NJ Bellshill
    Avondale House, Suites 1l - 1o
    North Lanarkshire
    Scotland
    ScotlandBritish189302040001
    MCCLELLAND, John Ferguson
    Strathclyde Business Park
    Kestrel View
    ML4 3PB Bellshill
    Suite 1a, Willow House
    Lanarkshire
    United Kingdom
    Director
    Strathclyde Business Park
    Kestrel View
    ML4 3PB Bellshill
    Suite 1a, Willow House
    Lanarkshire
    United Kingdom
    ScotlandBritish157048710001
    MCCULLOCH, Paul
    Cargen Tower
    Garroch Business Park
    DG2 8PN Garroch Loaning
    Corporate Services, Dumfries And Galloway Council
    Dumfries
    Scotland
    Director
    Cargen Tower
    Garroch Business Park
    DG2 8PN Garroch Loaning
    Corporate Services, Dumfries And Galloway Council
    Dumfries
    Scotland
    ScotlandBritish254134750001
    PARKER, Nicholas Giles Burley
    Phoenix Crescent
    Strathclyde Business Park
    ML4 3NJ Bellshill
    Avondale House, Suites 1l - 1o
    North Lanarkshire
    Scotland
    Director
    Phoenix Crescent
    Strathclyde Business Park
    ML4 3NJ Bellshill
    Avondale House, Suites 1l - 1o
    North Lanarkshire
    Scotland
    EnglandBritish134463970004
    PEARCE, Glenn Sinclair
    Suites 1b-1e, Phoenix Crescent
    Strathclyde Business Park
    ML4 3NJ Bellshill
    Avondale House
    North Lanarkshire
    Scotland
    Director
    Suites 1b-1e, Phoenix Crescent
    Strathclyde Business Park
    ML4 3NJ Bellshill
    Avondale House
    North Lanarkshire
    Scotland
    ScotlandBritish176131560002
    PEARCE, Glenn Sinclair
    Phoenix Crescent
    Strathclyde Business Park
    ML4 3NJ Bellshill
    Avondale House, Suites 1l - 1o
    North Lanarkshire
    Scotland
    Director
    Phoenix Crescent
    Strathclyde Business Park
    ML4 3NJ Bellshill
    Avondale House, Suites 1l - 1o
    North Lanarkshire
    Scotland
    ScotlandBritish176131560002
    RENTON, Claire
    Phoenix Crescent
    Strathclyde Business Park
    ML4 3NJ Bellshill
    Avondale House, Suites 1l - 1o
    North Lanarkshire
    Scotland
    Director
    Phoenix Crescent
    Strathclyde Business Park
    ML4 3NJ Bellshill
    Avondale House, Suites 1l - 1o
    North Lanarkshire
    Scotland
    ScotlandBritish209041240001
    ROSE, David
    Phoenix Crescent
    Strathclyde Business Park
    ML4 3NJ Bellshill
    Avondale House, Suites 1l - 1o
    North Lanarkshire
    Scotland
    Director
    Phoenix Crescent
    Strathclyde Business Park
    ML4 3NJ Bellshill
    Avondale House, Suites 1l - 1o
    North Lanarkshire
    Scotland
    United KingdomBritish139557410001
    THAKRAR, Amit Rishi Jaysukh
    Phoenix Crescent
    Strathclyde Business Park
    ML4 3NJ Bellshill
    Avondale House, Suites 1l - 1o
    North Lanarkshire
    Scotland
    Director
    Phoenix Crescent
    Strathclyde Business Park
    ML4 3NJ Bellshill
    Avondale House, Suites 1l - 1o
    North Lanarkshire
    Scotland
    United KingdomBritish292696530001
    YOUNG, Craig Bernard
    Suites 1b-1e, Phoenix Crescent
    Strathclyde Business Park
    ML4 3NJ Bellshill
    Avondale House
    North Lanarkshire
    Scotland
    Director
    Suites 1b-1e, Phoenix Crescent
    Strathclyde Business Park
    ML4 3NJ Bellshill
    Avondale House
    North Lanarkshire
    Scotland
    ScotlandBritish268946520001

    ¿Quiénes son las personas con control significativo de HUB SW DALBEATTIE DBFM CO LIMITED?

    Personas con control significativo
    NombreNotificado elDirecciónCesado
    Hub Sw Dalbeattie Holdco Limited
    Phoenix Crescent
    Strathclyde Business Park
    ML4 3NJ Bellshill
    Avondale House, Suites 1l - 1o
    Scotland
    15 may 2017
    Phoenix Crescent
    Strathclyde Business Park
    ML4 3NJ Bellshill
    Avondale House, Suites 1l - 1o
    Scotland
    No
    Forma jurídicaLimited Partnership
    Autoridad legalCompanies Act 2006
    Naturaleza del control
    • La persona posee, directa o indirectamente, más del 75% de las acciones de la compañía.

    Fuente de datos

    • Companies House del Reino Unido
      El registro oficial de empresas en el Reino Unido, que proporciona acceso público a información sobre empresas, como nombres, direcciones, administradores y registros financieros.
    • Licencia: CC0