COMPANY OF PROPRIETORS OF WHITCHURCH BRIDGE (THE)
Visión general
Nombre de la empresa | COMPANY OF PROPRIETORS OF WHITCHURCH BRIDGE (THE) |
---|---|
Estado de la empresa | Activa |
Forma jurídica | Sociedad no registrada |
Número de empresa | ZC000184 |
Jurisdicción | Inglaterra/Gales |
Resumen
Tiene PSCs súper seguros | No |
---|---|
Tiene gravámenes | No |
Tiene historial de insolvencia | No |
La sede social está en disputa | No |
¿Cuál es el propósito de COMPANY OF PROPRIETORS OF WHITCHURCH BRIDGE (THE)?
- Otras actividades de servicios auxiliares al transporte terrestre, n.c.p. (52219) / Transporte y almacenamiento
¿Dónde se encuentra COMPANY OF PROPRIETORS OF WHITCHURCH BRIDGE (THE)?
Dirección de la sede social | Hotspur House Prospect Place Hythe SO45 6AU Southampton Hampshire |
---|---|
Dirección de la sede social no entregable | No |
¿Cuáles son las últimas cuentas de COMPANY OF PROPRIETORS OF WHITCHURCH BRIDGE (THE)?
Últimas cuentas | |
---|---|
Últimas cuentas cerradas hasta |
¿Cuál es el estado de la última declaración de confirmación para COMPANY OF PROPRIETORS OF WHITCHURCH BRIDGE (THE)?
Última declaración de confirmación | |
---|---|
Próxima declaración de confirmación cerrada hasta | 31 dic 2018 |
¿Cuáles son las últimas presentaciones para COMPANY OF PROPRIETORS OF WHITCHURCH BRIDGE (THE)?
Fecha | Descripción | Documento | Tipo | |
---|---|---|---|---|
Nombramiento de Benjamin George Richardson como director el 22 abr 2024 | 3 páginas | AP01 | ||
Cese del nombramiento de Philip Malcolm Seedwell como director el 19 abr 2024 | 1 páginas | TM01 | ||
Exercice comptable précédent raccourci du 30 jun 2019 au 31 ene 2019 | 3 páginas | AA01 | ||
Notification de Whit Three Limited en tant que personne disposant d'un contrôle significatif le 21 feb 2019 | 4 páginas | PSC02 | ||
Notification de Whit Two Limited en tant que personne disposant d'un contrôle significatif le 21 feb 2019 | 4 páginas | PSC02 | ||
Notification de Whit One Limited en tant que personne disposant d'un contrôle significatif le 21 feb 2019 | 4 páginas | PSC02 | ||
Nombramiento de Mr James Crothers Habgood Percy como director el 21 feb 2019 | 2 páginas | AP01 | ||
Nombramiento de Mr Andrew George Percy como director el 21 feb 2019 | 2 páginas | AP01 | ||
Nombramiento de Mr Philip Malcolm Seedwell como director el 21 feb 2019 | 2 páginas | AP01 | ||
Cese del nombramiento de Geoffrey Rutherford Weir como director el 21 feb 2019 | 1 páginas | TM01 | ||
Cese del nombramiento de Robert Henry Charles Plumb como director el 21 feb 2019 | 1 páginas | TM01 | ||
Cese del nombramiento de Michael John Beckley como director el 21 feb 2019 | 1 páginas | TM01 | ||
Cese del nombramiento de Charles Thomas Micklem como director el 21 feb 2019 | 1 páginas | TM01 | ||
Cessation de Whitchurch Bridge Two Limited en tant que personne disposant d'un contrôle significatif le 21 feb 2019 | 3 páginas | PSC07 | ||
Cessation de Whitchurch Bridge Three Limited en tant que personne disposant d'un contrôle significatif le 21 feb 2019 | 3 páginas | PSC07 | ||
Cessation de Whitchurch Bridge One Limited en tant que personne disposant d'un contrôle significatif le 21 feb 2019 | 3 páginas | PSC07 | ||
Cese del nombramiento de Geoffrey Rutherford Weir como secretario el 21 feb 2019 | 2 páginas | TM02 | ||
Domicilio social registrado cambiado de The Toll House High Street Whitchurch on Thames Reading Berkshire RG8 7DF a Hotspur House Prospect Place Hythe Southampton Hampshire SO45 6AU el 12 mar 2019 | 2 páginas | AD01 | ||
Notification de Whitchurch Bridge Three Limited en tant que personne disposant d'un contrôle significatif le 20 feb 2019 | 4 páginas | PSC02 | ||
Notification de Whitchurch Bridge One Limited en tant que personne disposant d'un contrôle significatif le 20 feb 2019 | 4 páginas | PSC02 | ||
Notification de Whitchurch Bridge Two Limited en tant que personne disposant d'un contrôle significatif le 20 feb 2019 | 4 páginas | PSC02 | ||
Retrait d'une déclaration relative à une personne disposant d'un contrôle significatif le 06 mar 2019 | 3 páginas | PSC09 | ||
Declaración de confirmación presentada el 31 dic 2018 con actualizaciones | 2 páginas | CS01 | ||
Declaración de confirmación presentada el 31 dic 2017 con actualizaciones | 2 páginas | CS01 | ||
Declaración de confirmación presentada el 31 dic 2016 con actualizaciones | 7 páginas | CS01 | ||
¿Quiénes son los directivos de COMPANY OF PROPRIETORS OF WHITCHURCH BRIDGE (THE)?
Nombre | Nombrado el | Renunció el | Rol | Dirección | Identificación de la empresa | País de residencia | Nacionalidad | Fecha de nacimiento | Ocupación | Número |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PERCY, Andrew George | Director | Prospect Place Hythe SO45 6AU Southampton Hotspur House Hampshire | England | British | Director | 15943900001 | ||||
PERCY, James Crothers Habgood | Director | Prospect Place Hythe SO45 6AU Southampton Hotspur House Hampshire | England | British | Accountant | 99560570005 | ||||
RICHARDSON, Benjamin George | Director | Hythe SO45 6AU Southampton Hotspur House England | England | British | Company Director | 322848150001 | ||||
BECKLEY, Eric James Sexstone | Secretario | 3 Breckland Green North Pickenham PE37 8LG Swaffham Norfolk | British | Certified Accountant | 42191280001 | |||||
ELKINS, John Louis | Secretario | 20 Glynswood OX39 4JE Chinnor Oxfordshire | British | 50628090003 | ||||||
WEIR, Geoffrey Rutherford | Secretario | High Street Whitchurch-On-Thames RG8 7DB Reading Wells House Berkshire | British | 50628040001 | ||||||
BECKLEY, Eric James Sexstone | Director | 3 Breckland Green North Pickenham PE37 8LG Swaffham Norfolk | British | Certified Accountant | 42191280001 | |||||
BECKLEY, Michael John | Director | The Homestead Little Marsh OX27 0AP Marsh Gibbon Buckinghamshire | England | British | Accountant | 87272380001 | ||||
CUMBER, William John | Director | 62 High Street Theale RG7 5AN Reading | British | Farmer | 42191260001 | |||||
ELKINS, John Louis | Director | 20 Glynswood OX39 4JE Chinnor Oxfordshire | British | Company Secretary | 50628090003 | |||||
FITZGERALD, Patrick Ian | Director | Fairbourne 28 The Rise TN13 1RQ Sevenoaks Kent | United Kingdom | British | Banker | 34954130003 | ||||
FREEMAN, Margaret Jill | Director | Latchford Farm Great Haseley OX44 7BG Oxford | British | None | 61720850001 | |||||
FRYER, John Denny | Director | Sandacre Woodside Frilford Heath OX13 5QG Abingdon Oxfordshire | British | Retired | 46064820001 | |||||
MICKLEM, Charles Thomas | Director | Prospect Place Hythe SO45 6AU Southampton Hotspur House Hampshire | United Kingdom | British | None | 13267110001 | ||||
MICKLEM, Charles Thomas | Director | The Pheasantries Bellingdon HP5 2XW Chesham Buckinghamshire | United Kingdom | British | Solicitor | 13267110001 | ||||
MICKLEM, Eleanor Ruth | Director | 24 Frognal Court Finchley Road NW3 5HG London | British | Retired | 46064830001 | |||||
MICKLEM, Nathaniel | Director | Sheepstead House Abingdon Oxfordshire | British | Retired | 42191270001 | |||||
PLUMB, Robert Henry Charles | Director | Prospect Place Hythe SO45 6AU Southampton Hotspur House Hampshire | England | British | Chartered Accountants | 20686100001 | ||||
SEEDWELL, Philip Malcolm | Director | Prospect Place Hythe SO45 6AU Southampton Hotspur House Hampshire | United Kingdom | British | Company Director | 253682460001 | ||||
VALE, William Richard Frederick | Director | The White House Stoford Water EX15 2HG Cullompton Devon | British | Retired | 46064810001 | |||||
WEIR, Geoffrey Rutherford | Director | Wells House Eastfield Lane Whitchurch On Thames RG8 7EJ Reading Berkshire | United Kingdom | British | Management Consultant | 50628040001 |
¿Quiénes son las personas con control significativo de COMPANY OF PROPRIETORS OF WHITCHURCH BRIDGE (THE)?
Nombre | Notificado el | Dirección | Cesado | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Whit Two Limited | 21 feb 2019 | Prospect Place Hythe SO45 6AU Southampton Hotspur House Hampshire United Kingdom | No | ||||||||||
| |||||||||||||
Naturaleza del control
| |||||||||||||
Whit One Limited | 21 feb 2019 | Prospect Place Hythe SO45 6AU Southampton Hotspur House Hampshire United Kingdom | No | ||||||||||
| |||||||||||||
Naturaleza del control
| |||||||||||||
Whit Three Limited | 21 feb 2019 | Prospect Place Hythe SO45 6AU Southampton Hotspur House Hampshire United Kingdom | No | ||||||||||
| |||||||||||||
Naturaleza del control
| |||||||||||||
Whitchurch Bridge Two Limited | 20 feb 2019 | High Street Whitchurch On Thames RG8 7DB Reading Wells House United Kingdom | Sí | ||||||||||
| |||||||||||||
Naturaleza del control
| |||||||||||||
Whitchurch Bridge Three Limited | 20 feb 2019 | High Street Whitchurch On Thames RG8 7DB Reading Wells House United Kingdom | Sí | ||||||||||
| |||||||||||||
Naturaleza del control
| |||||||||||||
Whitchurch Bridge One Limited | 20 feb 2019 | High Street Whitchurch On Thames RG8 7DB Reading Wells House United Kingdom | Sí | ||||||||||
| |||||||||||||
Naturaleza del control
|
¿Cuáles son las últimas declaraciones sobre personas con control significativo para COMPANY OF PROPRIETORS OF WHITCHURCH BRIDGE (THE)?
Notificado el | Cesado el | Declaración |
---|---|---|
31 dic 2016 | 20 feb 2019 | La empresa sabe o tiene motivos razonables para creer que no existe ninguna persona registrable o entidad jurídica relevante registrable en relación con la empresa. |
Fuente de datos
- Companies House del Reino Unido
El registro oficial de empresas en el Reino Unido, que proporciona acceso público a información sobre empresas, como nombres, direcciones, administradores y registros financieros. - Licencia: CC0