• Datos
  • Gran Bretaña
  • Empresas
  • Buscar empresas
  • Sanciones
  • Buscar sanciones
  • Antony Gerard EBEL

    Persona Física

    TítuloMr
    NombreAntony
    Segundo NombreGerard
    ApellidoEBEL
    Fecha de Nacimiento
    ¿Es Ejecutivo Corporativo?No
    Nombramientos
    Activo15
    Inactivo7
    Renunciado26
    Total48

    Nombramientos

    Cargos Designados
    Designado enFecha de DesignaciónFecha de RenunciaEstado de la EmpresaOcupaciónRolDirecciónPaís de ResidenciaNacionalidad
    IPLICIT GROUP LIMITED28 abr 2022ActivaDirector
    The Square
    2-12 Commercial Road
    BH2 5LP Bournemouth
    1st Floor At Bobby's
    Dorset
    England
    EnglandBritish
    IPLICIT LIMITED28 abr 2022ActivaDirector
    The Square
    2-12 Commercial Road
    BH2 5LP Bournemouth
    1st Floor At Bobby's
    Dorset
    England
    EnglandBritish
    MEMORIAL MANAGEMENT LIMITED17 dic 2012DisueltaDirector
    Hunts Pond Road
    PO14 4PJ Fareham
    235
    Hampshire
    United Kingdom
    EnglandBritish
    KEMNAL INVESTMENTS LIMITED21 jun 2012DisueltaDirector
    Hunts Pond Road
    PO14 4PJ Fareham
    235
    United Kingdom
    EnglandBritish
    SMU INVESTMENTS LTD11 abr 2011DisueltaDirector
    The Close
    SP1 2EL Salisbury
    56a
    Wilts
    United Kingdom
    EnglandBritish
    DHPD LIMITED31 mar 2011DisueltaDirector
    Hunts Pond Road
    PO14 4PJ Fareham
    235a
    Hampshire
    England
    EnglandBritish
    PROPERTY MANAGEMENT SERVICES UK LIMITED04 dic 2002ActivaSecretario
    The Annexe
    56a The Close
    SP1 2EL Salisbury
    Wiltshire
    British
    VALLEYWEST LIMITED11 sept 2001ActivaSecretario
    The Annexe
    56a The Close
    SP1 2EL Salisbury
    Wiltshire
    British
    SWITCHVIEW DEVELOPMENTS LIMITED11 sept 2001ActivaSecretario
    The Annexe
    56a The Close
    SP1 2EL Salisbury
    Wiltshire
    British
    MANOR GARDENS INVESTMENTS LIMITED23 ago 2001ActivaDirector
    The Annexe
    56a The Close
    SP1 2EL Salisbury
    Wiltshire
    EnglandBritish
    FORMNEXT LIMITED15 may 2001ActivaSecretario
    The Annexe
    56a The Close
    SP1 2EL Salisbury
    Wiltshire
    British
    LEWIS ENTERTAINMENTS LIMITED16 ene 2001ActivaDirector
    The Annexe
    56a The Close
    SP1 2EL Salisbury
    Wiltshire
    EnglandBritish
    ENTERTAINMENT CORPORATION SPONSORSHIP & LICENSING COMPANY LIMITED29 sept 1999DisueltaDirector
    Princes Gate
    SW7 1QJ London
    5
    EnglandBritish
    PRIMEPOINT PROPERTIES LTD29 mar 1999ActivaSecretario
    The Annexe
    56a The Close
    SP1 2EL Salisbury
    Wiltshire
    British
    HAMILTONS MANAGEMENT SERVICES LTD.19 oct 1998ActivaSecretario
    The Annexe
    56a The Close
    SP1 2EL Salisbury
    Wiltshire
    British
    ALEXANDRA LODGE (BOURNEMOUTH) LIMITED23 sept 1998ActivaSecretario
    The Annexe
    56a The Close
    SP1 2EL Salisbury
    Wiltshire
    British
    NAPIER MANAGEMENT SERVICES LIMITED24 ago 1995ActivaDirector
    The Annexe
    56a The Close
    SP1 2EL Salisbury
    Wiltshire
    EnglandBritish
    ROAD RUNNER INTERNATIONAL LIMITED16 nov 1993DisueltaSecretario
    The Annexe
    56a The Close
    SP1 2EL Salisbury
    Wiltshire
    British
    WATLINGTON SECURITIES LIMITED18 oct 1993DisueltaDirector
    Princes Gate
    SW7 1QJ London
    5
    EnglandBritish
    HIGHTOWN SECURITIES LIMITEDActivaDirector
    The Annexe
    56a The Close
    SP1 2EL Salisbury
    Wiltshire
    EnglandBritish
    HTM (UK) LIMITED26 feb 1992ActivaSecretario
    The Annexe
    56a The Close
    SP1 2EL Salisbury
    Wiltshire
    British
    MICRODISC LIMITEDActivaSecretario
    The Annexe
    56a The Close
    SP1 2EL Salisbury
    Wiltshire
    British
    LIVING NATURE LIMITED25 oct 200130 jun 2025ActivaSecretario
    The Annexe
    56a The Close
    SP1 2EL Salisbury
    Wiltshire
    British
    UNDERWOODS INVESTMENTS LIMITED31 dic 201302 jun 2025ActivaDirector
    56a The Close
    Salisbury
    SP1 2EL
    EnglandBritish
    GREENACRES KEMNAL PARK LIMITED18 jun 201218 may 2018ActivaDirector
    Floor 17
    Grosvenor Gardens
    SW1W 0BD London
    5th
    United Kingdom
    EnglandBritish
    GRESHAM HOUSE LIMITED14 jun 200601 dic 2014ActivaDirector
    Hunts Pond Road
    PO14 4PJ Fareham
    235
    Hampshire
    England
    EnglandBritish
    SECURITY CHANGE LIMITED01 nov 200501 dic 2014ActivaDirector
    17 Grosvenor Gardens
    SW1W 0BD London
    5th Floor
    England
    EnglandBritish
    UNDERWOODS INVESTMENTS LIMITED09 nov 199831 dic 2013ActivaSecretario
    The Annexe
    56a The Close
    SP1 2EL Salisbury
    Wiltshire
    British
    THE M CORPORATION LIMITED06 ene 200021 jul 2011DisueltaSecretario
    The Annexe
    56a The Close
    SP1 2EL Salisbury
    Wiltshire
    British
    SPORTS INTERNATIONAL LIMITED01 oct 200923 may 2011DisueltaDirector
    Old Gas Works
    The Cranewell Building 2 Michael Road
    SW6 2AD London
    Unit Cw 17
    United Kingdom
    EnglandBritish
    BRITISH GAS SOLAR LIMITED21 feb 200325 sept 2008DisueltaSecretario
    The Annexe
    56a The Close
    SP1 2EL Salisbury
    Wiltshire
    British
    AZZURRI TECHNOLOGY LIMITED10 sept 199731 mar 2008DisueltaDirector
    The Annexe
    56a The Close
    SP1 2EL Salisbury
    Wiltshire
    EnglandBritish
    GRESHAM HOUSE LIMITED13 jun 2006ActivaDirector
    The Annexe
    56a The Close
    SP1 2EL Salisbury
    Wiltshire
    EnglandBritish
    RADCLIFFE COURT FREEHOLD LIMITED28 nov 200201 abr 2006ActivaSecretario
    The Annexe
    56a The Close
    SP1 2EL Salisbury
    Wiltshire
    British
    SECURITY CHANGE LIMITED31 oct 2005ActivaDirector
    The Annexe
    56a The Close
    SP1 2EL Salisbury
    Wiltshire
    EnglandBritish

    Fuente de datos

    • Companies House del Reino Unido
      El registro oficial de empresas en el Reino Unido, que proporciona acceso público a información sobre empresas, como nombres, direcciones, administradores y registros financieros.
    • Licencia: CC0