• Datos
  • Gran Bretaña
  • Empresas
  • Buscar empresas
  • Sanciones
  • Buscar sanciones
  • David William OWENS

    Persona Física

    TítuloMr
    NombreDavid
    Segundo NombreWilliam
    ApellidoOWENS
    Fecha de Nacimiento
    ¿Es Ejecutivo Corporativo?No
    Nombramientos
    Activo13
    Inactivo1
    Renunciado140
    Total154

    Nombramientos

    Cargos Designados
    Designado enFecha de DesignaciónFecha de RenunciaEstado de la EmpresaOcupaciónRolDirecciónPaís de ResidenciaNacionalidad
    ANCALA PARTNERS LLP01 abr 2026ActivaMiembro de LLP
    Gracechurch Street
    EC3V 0AF London
    20
    England
    United Kingdom
    BAZALGETTE POWER LIMITED31 jul 2023ActivaDirector
    36-37 King Street
    EC2V 8BB London
    Kings House
    England
    United KingdomBritish
    ANCALA WATER SERVICES TOPCO 1 LIMITED11 feb 2020ActivaDirector
    Gracechurch Street
    EC3V 0AF London
    20
    England
    United KingdomBritish
    ANCALA BIOENERGY INVESTCO LIMITED06 dic 2019ActivaDirector
    Gracechurch Street
    EC3V 0AF London
    20
    England
    United KingdomBritish
    ANCALA WATER SERVICES (ESTATES) LIMITED19 abr 2018ActivaDirector
    40 Gracechurch Street
    EC3V 0BT London
    C/O Ancala Partners Llp
    United Kingdom
    United KingdomBritish
    ANCALA WATER SERVICES MIDCO2 LIMITED09 abr 2018ActivaDirector
    Gracechurch Street
    EC3V 0AF London
    20
    England
    United KingdomBritish
    ANCALA WATER SERVICES INVESTCO LIMITED09 abr 2018ActivaDirector
    Gracechurch Street
    EC3V 0AF London
    20
    England
    United KingdomBritish
    ANCALA WATER SERVICES MIDCO1 LIMITED09 abr 2018ActivaDirector
    Gracechurch Street
    EC3V 0AF London
    20
    England
    United KingdomBritish
    ANCALA WATER SERVICES HOLDCO LIMITED09 abr 2018ActivaDirector
    Gracechurch Street
    EC3V 0AF London
    20
    England
    United KingdomBritish
    ANCALA WATER SERVICES BIDCO LIMITED09 abr 2018ActivaDirector
    Redbrook Business Park
    Wilthorpe Road
    S75 1JN Barnsley
    Unit 1b
    South Yorkshire
    United Kingdom
    United KingdomBritish
    ANCALA WATER SERVICES TOPCO LIMITED09 abr 2018ActivaDirector
    Gracechurch Street
    EC3V 0AF London
    20
    England
    United KingdomBritish
    ANCALA BIOENERGY MIDCO LIMITED13 abr 2017ActivaDirector
    Gracechurch Street
    EC3V 0AF London
    20
    England
    United KingdomBritish
    ANCALA BIOENERGY HOLDCO LIMITED13 abr 2017ActivaDirector
    Gracechurch Street
    EC3V 0AF London
    20
    England
    United KingdomBritish
    DAVID OWENS CONSULTING LIMITED08 may 2014DisueltaDirector
    Marlow Bridge Lane
    SL7 1RH Marlow
    The Garden House
    United Kingdom
    United KingdomBritish
    ANCALA PARTNERS LLP24 may 201631 dic 2024ActivaMiembro de LLP
    Gracechurch Street
    EC3V 0AF London
    20
    England
    United Kingdom
    LEEP NETWORKS (WATER) LIMITED19 jun 202113 jul 2023ActivaDirector
    33 Trafford Road
    M5 3NN Manchester
    Level 2, Metro
    England
    United KingdomBritish
    LEEP ELECTRICITY NETWORKS LIMITED19 jun 202113 jul 2023ActivaDirector
    33 Trafford Road
    M5 3NN Manchester
    Level 2, Metro
    England
    United KingdomBritish
    LEEP GAS NETWORKS LIMITED19 jun 202113 jul 2023ActivaDirector
    33 Trafford Road
    M5 3NN Manchester
    Level 2, Metro
    England
    United KingdomBritish
    ANCALA BIOENERGY LIMITED13 abr 201705 nov 2021ActivaDirector
    King's House
    36-37 King Street
    EC2V 8BB London
    C/O Ancala Partners Llp
    England
    United KingdomBritish
    ANCALA FORNIA MIDCO LIMITED03 nov 201612 abr 2021ActivaDirector
    West Street
    PO9 1LG Havant
    PO BOX 8
    England
    United KingdomBritish
    ANCALA FORNIA HOLDCO LIMITED03 nov 201612 abr 2021ActivaDirector
    West Street
    PO9 1LG Havant
    PO BOX 8
    Hampshire
    England
    United KingdomBritish
    ANCALA FORNIA LIMITED11 oct 201612 abr 2021ActivaDirector
    West Street
    PO BOX 8
    PO9 1LG Havant
    Brockhampton Springs
    Hampshire
    United Kingdom
    United KingdomBritish
    SOUTH DOWNS CAPITAL LIMITED16 mar 201805 mar 2021ActivaDirector
    Gracechurch Street
    EC3V 0BT London
    40
    England
    United KingdomBritish
    PORTSMOUTH WATER LIMITED16 mar 201805 mar 2021ActivaDirector
    Gracechurch Street
    EC3V 0BT London
    40
    England
    United KingdomBritish
    LEEP UTILITIES LIMITED26 abr 201712 may 2017ActivaDirector
    Traffordcity
    M17 8PL Manchester
    Peel Dome Intu Trafford Centre
    United Kingdom
    United Kingdom
    United KingdomBritish
    POWERDEBT LTD05 ene 201201 nov 2013DisueltaDirector
    Shenley Road
    WD6 1TE Borehamwood
    Hertsmere House
    Hertfordshire
    United Kingdom
    United KingdomBritish
    REVENUE ASSURANCE SERVICES HOLDINGS LIMITED05 ene 201201 nov 2013DisueltaDirector
    Shenley Road
    WD6 1TE Borehamwood
    Hertsmere House
    Hertfordshire
    United Kingdom
    United KingdomBritish
    MORFIND 2029 LIMITED21 dic 201101 nov 2013ActivaDirector
    Shenley Road
    WD6 1TE Borehamwood
    Hertsmere House
    Hertfordshire
    United Kingdom
    United KingdomBritish
    COMPLETEPEACEOFMIND LIMITED21 dic 201101 nov 2013DisueltaDirector
    Shenley Road
    WD6 1TE Borehamwood
    Hertsmere House
    Hertfordshire
    United Kingdom
    United KingdomBritish
    RED HALL 6 LIMITED21 dic 201101 nov 2013DisueltaDirector
    Shenley Road
    WD6 1TE Borehamwood
    Hertsmere House
    Hertfordshire
    United Kingdom
    United KingdomBritish
    RED HALL 1 LIMITED21 dic 201101 nov 2013DisueltaDirector
    Shenley Road
    WD6 1TE Borehamwood
    Hertsmere House
    Hertfordshire
    United Kingdom
    United KingdomBritish
    RED HALL 9 LIMITED21 dic 201101 nov 2013DisueltaDirector
    Shenley Road
    WD6 1TE Borehamwood
    Hertsmere House
    Hertfordshire
    United Kingdom
    United KingdomBritish
    GIS DIRECT LIMITED21 dic 201101 nov 2013DisueltaDirector
    Shenley Road
    WD6 1TE Borehamwood
    Hertsmere House
    Hertfordshire
    United Kingdom
    United KingdomBritish
    LINE DESIGN SOLUTIONS LIMITED21 dic 201101 nov 2013DisueltaDirector
    Shenley Road
    WD6 1TE Borehamwood
    Hertsmere House
    Hertfordshire
    United Kingdom
    United KingdomBritish
    WAYLEAVE SURVEY & ENGINEERING LTD21 dic 201101 nov 2013DisueltaDirector
    Shenley Road
    WD6 1TE Borehamwood
    Hertsmere House
    Hertfordshire
    United Kingdom
    United KingdomBritish

    Fuente de datos

    • Companies House del Reino Unido
      El registro oficial de empresas en el Reino Unido, que proporciona acceso público a información sobre empresas, como nombres, direcciones, administradores y registros financieros.
    • Licencia: CC0