• Datos
  • Gran Bretaña
  • Empresas
  • Buscar empresas
  • Sanciones
  • Buscar sanciones
  • Janet Anne COLLINSON

    Persona Física

    Título
    NombreJanet
    Segundo NombreAnne
    ApellidoCOLLINSON
    ¿Es Ejecutivo Corporativo?No
    Nombramientos
    Activo0
    Inactivo2
    Renunciado26
    Total28

    Nombramientos

    Cargos Designados
    Designado enFecha de DesignaciónFecha de RenunciaEstado de la EmpresaOcupaciónRolDirecciónPaís de ResidenciaNacionalidad
    21ST CENTURY ENTERPRISES LTD08 feb 2006DisueltaRetiredSecretario
    8 Gordon Road
    Chandlers Ford
    SO53 5AN Eastleigh
    Hampshire
    British
    21ST CENTURY ENTERPRISES LTD08 feb 2006DisueltaRetiredDirector
    8 Gordon Road
    Chandlers Ford
    SO53 5AN Eastleigh
    Hampshire
    British
    ADVANCED QUALITY TECHNOLOGY LTD02 jun 200310 jul 2013DisueltaSecretario
    Redcliffe Road
    BH19 1LZ Swanage
    17
    Dorset
    British
    ABACUS COMPANY SERVICES LTD01 abr 200015 dic 2005DisueltaCompany Formation AgentDirector
    8 Gordon Road
    Chandlers Ford
    SO53 5AN Eastleigh
    Hampshire
    British
    LINKWELL SYSTEMS LIMITED14 jul 2003DisueltaSecretario
    8 Gordon Road
    Chandlers Ford
    SO53 5AN Eastleigh
    Hampshire
    British
    NORTHOVER BENNETT & CO LTD01 jun 200131 mar 2003ActivaSecretario
    8 Gordon Road
    Chandlers Ford
    SO53 5AN Eastleigh
    Hampshire
    British
    ABACUS COMPANY SERVICES LTD18 jun 199801 jun 2001DisueltaCompany Formation AgentSecretario
    8 Gordon Road
    Chandlers Ford
    SO53 5AN Eastleigh
    Hampshire
    British
    ABACUS COMPANY SERVICES LTD18 jun 199814 oct 1998DisueltaCompany Formation AgentDirector
    8 Gordon Road
    Chandlers Ford
    SO53 5AN Eastleigh
    Hampshire
    British
    REFLO LTD08 abr 199809 abr 1998DisueltaSecretario
    8 Gordon Road
    Chandlers Ford
    SO53 5AN Eastleigh
    Hampshire
    British
    STORMY SEAS LTD07 abr 199808 abr 1998DisueltaSecretario
    8 Gordon Road
    Chandlers Ford
    SO53 5AN Eastleigh
    Hampshire
    British
    CAS CONSULTING LTD18 mar 199819 mar 1998DisueltaSecretario
    8 Gordon Road
    Chandlers Ford
    SO53 5AN Eastleigh
    Hampshire
    British
    1ST 4 CARS LTD.28 nov 199729 nov 1997DisueltaSecretario
    8 Gordon Road
    Chandlers Ford
    SO53 5AN Eastleigh
    Hampshire
    British
    TAVISTOCK FINANCIAL SERVICES LIMITED25 sept 199726 sept 1997ActivaSecretario
    8 Gordon Road
    Chandlers Ford
    SO53 5AN Eastleigh
    Hampshire
    British
    SIRS ONLY LTD22 sept 199723 sept 1997ActivaSecretario
    8 Gordon Road
    Chandlers Ford
    SO53 5AN Eastleigh
    Hampshire
    British
    INSPIREBUS LTD02 jul 199703 jul 1997DisueltaSecretario
    8 Gordon Road
    Chandlers Ford
    SO53 5AN Eastleigh
    Hampshire
    British
    HOODED SWAN LTD12 jun 199713 jun 1997ActivaSecretario
    8 Gordon Road
    Chandlers Ford
    SO53 5AN Eastleigh
    Hampshire
    British
    WILLIAMS ROOFING CONTRACTORS LIMITED30 may 199731 may 1997ActivaSecretario
    8 Gordon Road
    Chandlers Ford
    SO53 5AN Eastleigh
    Hampshire
    British
    INTERFACE (MJC) LTD02 ene 199703 ene 1997ActivaSecretario
    8 Gordon Road
    Chandlers Ford
    SO53 5AN Eastleigh
    Hampshire
    British
    STRONGBOX DATABASE MANAGEMENT LTD09 dic 199610 dic 1996DisueltaSecretario
    8 Gordon Road
    Chandlers Ford
    SO53 5AN Eastleigh
    Hampshire
    British
    MAD PRODUCTIONS LIMITED22 nov 199623 nov 1996DisueltaSecretario
    8 Gordon Road
    Chandlers Ford
    SO53 5AN Eastleigh
    Hampshire
    British
    DOCUMATION LTD23 may 199624 may 1996ActivaSecretario
    8 Gordon Road
    Chandlers Ford
    SO53 5AN Eastleigh
    Hampshire
    British
    COUGARTEK DESIGNS LTD09 may 199610 may 1996DisueltaSecretario
    8 Gordon Road
    Chandlers Ford
    SO53 5AN Eastleigh
    Hampshire
    British
    TEMIS SYSTEMS LIMITED19 oct 199520 oct 1995ActivaSecretario
    8 Gordon Road
    Chandlers Ford
    SO53 5AN Eastleigh
    Hampshire
    British
    SCOTT MARINE & OFFICE SERVICES LTD06 sept 199507 sept 1995DisueltaSecretario
    8 Gordon Road
    Chandlers Ford
    SO53 5AN Eastleigh
    Hampshire
    British
    SEATALLAN LIMITED21 jun 199522 jun 1995ActivaSecretario
    8 Gordon Road
    Chandlers Ford
    SO53 5AN Eastleigh
    Hampshire
    British
    VISUAL ARTS LIMITED17 mar 199518 mar 1995DisueltaSecretario
    8 Gordon Road
    Chandlers Ford
    SO53 5AN Eastleigh
    Hampshire
    British
    MOOR CONSTRUCTION LIMITED10 ene 199510 ene 1995ActivaSecretario
    8 Gordon Road
    Chandlers Ford
    SO53 5AN Eastleigh
    Hampshire
    British
    VENUES FOR BUSINESS LIMITED14 ene 199417 ene 1994ActivaSecretario
    8 Gordon Road
    Chandlers Ford
    SO53 5AN Eastleigh
    Hampshire
    British

    Fuente de datos

    • Companies House del Reino Unido
      El registro oficial de empresas en el Reino Unido, que proporciona acceso público a información sobre empresas, como nombres, direcciones, administradores y registros financieros.
    • Licencia: CC0