John Lambie TALLO
Persona Física
Título | |
---|---|
Nombre | John |
Segundo Nombre | Lambie |
Apellido | TALLO |
¿Es Ejecutivo Corporativo? | No |
Nombramientos | |
Activo | 0 |
Inactivo | 12 |
Renunciado | 8 |
Total | 20 |
Nombramientos
Designado en | Fecha de Designación | Fecha de Renuncia | Estado de la Empresa | Ocupación | Rol | Dirección | País de Residencia | Nacionalidad |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVONSIDE GROUP LIMITED | 23 oct 2003 | Disuelta | Secretario | 41 Gleneagles Drive Penwortham PR1 0JT Preston | British | |||
AVONSIDE GROUP HOLDINGS TRUSTEES LIMITED | 20 oct 2003 | Disuelta | Secretario | 41 Gleneagles Drive Penwortham PR1 0JT Preston | British | |||
AVONSIDE GROUP HOLDINGS LIMITED | 20 oct 2003 | Disuelta | Secretario | 41 Gleneagles Drive Penwortham PR1 0JT Preston | British | |||
AVONSIDE TRUSTEES LIMITED | 18 sept 2003 | Disuelta | Secretario | 41 Gleneagles Drive Penwortham PR1 0JT Preston | British | |||
AVONSIDE COUNTRY HOMES LIMITED | 18 sept 2003 | Disuelta | Secretario | 41 Gleneagles Drive Penwortham PR1 0JT Preston | British | |||
AVONSIDE HOUSES LIMITED | 18 sept 2003 | Disuelta | Secretario | 41 Gleneagles Drive Penwortham PR1 0JT Preston | British | |||
AVONSIDE HOLDINGS LIMITED | 18 sept 2003 | Disuelta | Secretario | 41 Gleneagles Drive Penwortham PR1 0JT Preston | British | |||
FINCHWOLD LIMITED | 18 sept 2003 | Disuelta | Secretario | 41 Gleneagles Drive Penwortham PR1 0JT Preston | British | |||
J.E. PARRY (ROSSETT) LIMITED | 18 sept 2003 | Disuelta | Secretario | 41 Gleneagles Drive Penwortham PR1 0JT Preston | British | |||
JOSHUA AND TOM TAYLOR LIMITED | 18 sept 2003 | Disuelta | Secretario | 41 Gleneagles Drive Penwortham PR1 0JT Preston | British | |||
GRAMPIAN PHARMACEUTICALS LIMITED | 13 ene 2000 | Disuelta | Self-Employed | Director | 41 Gleneagles Drive Penwortham PR1 0JT Preston | British | ||
GRAMPIAN PHARMACEUTICALS LIMITED | 01 nov 1997 | Disuelta | Secretario | 41 Gleneagles Drive Penwortham PR1 0JT Preston | British | |||
PARRY HOMES LIMITED | 18 sept 2003 | 22 ene 2010 | Disuelta | Secretario | 41 Gleneagles Drive Penwortham PR1 0JT Preston | British | ||
VERICORE LIMITED | 10 dic 1998 | 19 ene 2000 | Activa | Secretario | 41 Gleneagles Drive Penwortham PR1 0JT Preston | British | ||
ELANCO ANIMAL VACCINES LIMITED | 19 ene 2000 | Activa | Secretario | 41 Gleneagles Drive Penwortham PR1 0JT Preston | British | |||
ELANCO ANIMAL VACCINES LIMITED | 01 jun 1994 | 01 ago 1997 | Activa | Accountant | Director | 41 Gleneagles Drive Penwortham PR1 0JT Preston | British | |
EDINGLEN LIMITED | 01 jun 1994 | 30 nov 1994 | Activa | Accountant | Director | 41 Gleneagles Drive Penwortham PR1 0JT Preston | British | |
EDINGLEN LIMITED | 30 mar 1990 | 30 nov 1994 | Activa | Secretario | 41 Gleneagles Drive Penwortham PR1 0JT Preston | British | ||
VETBED (ANIMAL CARE) LIMITED | 22 oct 1993 | 31 oct 1994 | Activa | Secretario | 41 Gleneagles Drive Penwortham PR1 0JT Preston | British | ||
GRAMPIAN PHARMACEUTICALS LIMITED | 30 mar 1990 | 12 mar 1993 | Disuelta | Secretario | 12 Brenfield Drive G44 3LT Glasgow Lanarkshire | British |
Fuente de datos
- Companies House del Reino Unido
El registro oficial de empresas en el Reino Unido, que proporciona acceso público a información sobre empresas, como nombres, direcciones, administradores y registros financieros. - Licencia: CC0