SURREY GROUP LIMITED

  • Vue d'ensemble
  • Résumé
  • Objet social
  • Adresse
  • Dénominations sociales précédentes
  • Comptes
  • Dépôts
  • Dirigeants
  • Charges
  • Insolvabilité
  • Source de données
  • Vue d'ensemble

    Nom de la sociétéSURREY GROUP LIMITED
    Statut de la sociétéDissoute
    Forme juridiqueSociété à responsabilité limitée
    Numéro de société 00000425
    JuridictionAngleterre/Pays de Galles
    Date de création
    Date de cessation d'activité

    Résumé

    A des PSCs super sécurisésNon
    A des chargesOui
    A un historique d'insolvabilitéOui
    Le siège social est contestéNon

    Quel est l'objet de SURREY GROUP LIMITED ?

    • (7415) /

    Où se situe SURREY GROUP LIMITED ?

    Adresse du siège social
    8 Salisbury Square
    EC4Y 8BB London
    Adresse du siège social non livrableNon

    Quels étaient les noms précédents de SURREY GROUP LIMITED ?

    Dénominations sociales précédentes
    Nom de la sociétéDeJusqu'au
    BERWICK GROUP PUBLIC LIMITED COMPANY27 févr. 198727 févr. 1987
    BERWICK SALMON FISHERIES PUBLIC LIMITED COMPANY31 déc. 198131 déc. 1981
    BERWICK SALMON FISHERIES COMPANY LIMITED01 nov. 185601 nov. 1856

    Quels sont les derniers comptes de SURREY GROUP LIMITED ?

    Derniers comptes
    Derniers comptes arrêtés au30 juin 2010

    Quels sont les derniers dépôts pour SURREY GROUP LIMITED ?

    Dépôts
    DateDescriptionDocumentType

    Gazette finale dissoute à la suite d'une liquidation

    1 pagesGAZ2

    Retour de la réunion finale dans une liquidation volontaire des membres

    4 pages4.71

    Avis de cessation d'agir en tant que liquidateur volontaire

    1 pages4.40

    Nomination d'un liquidateur volontaire

    1 pages600

    Dépôt d'insolvabilité

    Insolvency:order of court appointing allan watson graham and removing jeremy simon spratt as liquidators of the company
    24 pagesLIQ MISC

    Déclaration des reçus et paiements des liquidateurs jusqu'à 29 juin 2013

    4 pages4.68

    Déclaration des reçus et paiements des liquidateurs jusqu'à 29 juin 2012

    6 pages4.68

    Changement d'adresse du siège social de Grant Way Isleworth Middlesex TW7 5QD le 18 juil. 2011

    2 pagesAD01

    Déclaration de solvabilité

    5 pages4.70

    Nomination d'un liquidateur volontaire

    1 pages600

    Résolutions

    Resolutions
    1 pagesRESOLUTIONS
    Résolutions
    CatégorieDateDescriptionType
    liquidation

    Résolution spéciale pour la liquidation au 30 juin 2011

    LRESSP

    Nomination de David Joseph Gormley en tant qu'administrateur

    2 pagesAP01

    Nomination de Christopher Jon Taylor en tant qu'administrateur

    2 pagesAP01

    Cessation de la nomination de Andrew Griffith en tant que directeur

    1 pagesTM01

    Cessation de la nomination de David Darroch en tant que directeur

    1 pagesTM01

    Déclaration annuelle jusqu'au 30 mai 2011 avec liste complète des actionnaires

    5 pagesAR01
    Dépôts associés
    CatégorieDateDescriptionType
    capital27 juin 2011

    État du capital au 27 juin 2011

    • Capital: GBP 100
    SH01

    Comptes annuels établis au 30 juin 2010

    20 pagesAA

    Déclaration annuelle jusqu'au 30 mai 2010 avec liste complète des actionnaires

    5 pagesAR01

    État du capital au 28 mai 2010

    • Capital: GBP 100
    4 pagesSH19

    legacy

    1 pagesSH20

    legacy

    1 pagesCAP-SS

    Résolutions

    Resolutions
    1 pagesRESOLUTIONS
    Résolutions
    CatégorieDateDescriptionType
    capital

    Résolution de réduction du capital social émis

    RES06
    capital

    Résolutions

    Share premium cancelled/ redemption reserve cancelled 14/05/2010
    RES13

    Comptes annuels établis au 30 juin 2009

    21 pagesAA

    legacy

    4 pages363a

    Comptes annuels établis au 30 juin 2008

    21 pagesAA

    Qui sont les dirigeants de SURREY GROUP LIMITED ?

    Dirigeants
    NomNommé leDate de démissionRôleAdresseIdentification de la sociétéPays de résidenceNationalitéDate de naissanceProfessionNuméro
    GORMLEY, David Joseph
    Grant Way
    TW7 5QD Isleworth
    Middlesex
    Secrétaire
    Grant Way
    TW7 5QD Isleworth
    Middlesex
    British150780210001
    GORMLEY, David Joseph
    Grant Way
    TW7 5QD Isleworth
    British Sky Broadcasting Group Plc
    Middlesex
    United Kingdom
    Administrateur
    Grant Way
    TW7 5QD Isleworth
    British Sky Broadcasting Group Plc
    Middlesex
    United Kingdom
    United KingdomBritishCompany Secretary150780210001
    TAYLOR, Christopher Jon
    Grant Way
    TW7 5QD Isleworth
    British Sky Broadcasting Group Plc
    Middlesex
    United Kingdom
    Administrateur
    Grant Way
    TW7 5QD Isleworth
    British Sky Broadcasting Group Plc
    Middlesex
    United Kingdom
    EnglandBritishCompany Secretary135143490001
    BOLGER, Patrick Anthony
    31 Alverstone Avenue
    Wimbledon Park
    SW19 8BD London
    Secrétaire
    31 Alverstone Avenue
    Wimbledon Park
    SW19 8BD London
    Irish37660110001
    DOBSON, Laura Jane
    18 Berkeley Mews
    Thames Street
    TW16 5QF Lower Sunbury
    Middlesex
    Secrétaire
    18 Berkeley Mews
    Thames Street
    TW16 5QF Lower Sunbury
    Middlesex
    British73308490001
    GORMLEY, David Joseph
    17 Middleton Drive
    HA5 2PQ Pinner
    Middlesex
    Secrétaire
    17 Middleton Drive
    HA5 2PQ Pinner
    Middlesex
    British150780210001
    PRICE, Simon John
    2 Hawkwell
    Church Crookham
    GU13 0XF Fleet
    Hampshire
    Secrétaire
    2 Hawkwell
    Church Crookham
    GU13 0XF Fleet
    Hampshire
    British57781400003
    WOOD, Mark Andrew Kenneth
    52 Leeds Road
    YO8 4JQ Selby
    North Yorkshire
    Secrétaire
    52 Leeds Road
    YO8 4JQ Selby
    North Yorkshire
    BritishDirector113494040001
    BALL, Anthony Frank Elliott
    6 Buckingham House
    Courtlands Sheen Road
    TW10 5AP Richmond
    Surrey
    Administrateur
    6 Buckingham House
    Courtlands Sheen Road
    TW10 5AP Richmond
    Surrey
    BritishChief Executive Officer49642300006
    BOLGER, Patrick Anthony
    31 Alverstone Avenue
    Wimbledon Park
    SW19 8BD London
    Administrateur
    31 Alverstone Avenue
    Wimbledon Park
    SW19 8BD London
    IrishChartered Accountant37660110001
    DARROCH, David Jeremy
    British Sky Broadcasting Group Plc
    Grant Way
    TW7 5QD Isleworth
    Middlesex
    Administrateur
    British Sky Broadcasting Group Plc
    Grant Way
    TW7 5QD Isleworth
    Middlesex
    EnglandBritishChief Executive Officer184936660001
    FATAH, Rafique John Paul
    Wenbans
    TN5 6NR Wadhurst
    East Sussex
    Administrateur
    Wenbans
    TN5 6NR Wadhurst
    East Sussex
    United KingdomBritishCompany Director34594470001
    FENN, Jeremy Mark
    4 Stone Rings Grange
    HG2 9HU Harrogate
    North Yorkshire
    Administrateur
    4 Stone Rings Grange
    HG2 9HU Harrogate
    North Yorkshire
    EnglandBritishDirector69458580005
    GORMLEY, David Joseph
    17 Middleton Drive
    HA5 2PQ Pinner
    Middlesex
    Administrateur
    17 Middleton Drive
    HA5 2PQ Pinner
    Middlesex
    United KingdomBritishCompany Secretary150780210001
    GREEN, Robert William
    26 Greencroft Gardens
    NW6 London
    Administrateur
    26 Greencroft Gardens
    NW6 London
    BritishChairman & Company Director41877270001
    GRIFFITH, Andrew John
    British Sky Broadcasting Group Plc
    Grant Way
    TW7 5QD Isleworth
    Middlesex
    Administrateur
    British Sky Broadcasting Group Plc
    Grant Way
    TW7 5QD Isleworth
    Middlesex
    United KingdomBritishChief Financial Officer129926510001
    JACKSON, Paul Francis
    Santon Manor
    Flanchford Road
    RH2 8QZ Reigate Heath
    Surrey
    Administrateur
    Santon Manor
    Flanchford Road
    RH2 8QZ Reigate Heath
    Surrey
    EnglandBritishChartered Accountant34594460001
    LEON, Terence Patrick
    13 Swan Street
    GU32 3AJ Petersfield
    Hampshire
    Administrateur
    13 Swan Street
    GU32 3AJ Petersfield
    Hampshire
    BritishCompany Director10632180001
    MCNAIR, John
    7 Westcombe Park Road
    SE3 7RE London
    Administrateur
    7 Westcombe Park Road
    SE3 7RE London
    BritishCompany Director61297520001
    MURDOCH, James Rupert
    British Sky Broadcasting Group Plc
    Grant Way
    TW7 5QD Isleworth
    Middlesex
    Administrateur
    British Sky Broadcasting Group Plc
    Grant Way
    TW7 5QD Isleworth
    Middlesex
    BritishChief Executive98054190002
    NORRIS, Michael
    9 Spur Drive
    LS15 8UD Leeds
    West Yorkshire
    Administrateur
    9 Spur Drive
    LS15 8UD Leeds
    West Yorkshire
    BritishCompany Director71004120003
    ODENDAAL, Robert
    12 Saint Johns Road
    TW9 2PE Richmond
    Surrey
    Administrateur
    12 Saint Johns Road
    TW9 2PE Richmond
    Surrey
    BritishAccountant71379010001
    PRICE, Simon John
    2 Hawkwell
    Church Crookham
    GU13 0XF Fleet
    Hampshire
    Administrateur
    2 Hawkwell
    Church Crookham
    GU13 0XF Fleet
    Hampshire
    BritishAccountant57781400003
    RUST, Nicholas John
    2 Manor Court
    Little Ouseburn
    YO26 9TB York
    North Yorkshire
    Administrateur
    2 Manor Court
    Little Ouseburn
    YO26 9TB York
    North Yorkshire
    United KingdomBritishManaging Director112088680001
    STEWART, Martin David
    123 Buckingham Palace Road
    SW1W 9SL London
    Administrateur
    123 Buckingham Palace Road
    SW1W 9SL London
    BritishChartered Accountant49920470007
    WILSON, Herbert James Mervyn
    34a Rydens Avenue
    KT12 3JP Walton On Thames
    Surrey
    Administrateur
    34a Rydens Avenue
    KT12 3JP Walton On Thames
    Surrey
    United KingdomBritishCompany Director18417070008
    WOOD, Mark Andrew Kenneth
    52 Leeds Road
    YO8 4JQ Selby
    North Yorkshire
    Administrateur
    52 Leeds Road
    YO8 4JQ Selby
    North Yorkshire
    EnglandBritishDirector113494040001
    WRIGHT, Roy Vincent
    Royston Place Chargate Close
    Burwood Park
    KT12 5DN Walton On Thames
    Surrey
    Administrateur
    Royston Place Chargate Close
    Burwood Park
    KT12 5DN Walton On Thames
    Surrey
    BritishCompany Director4601990001

    SURREY GROUP LIMITED a-t-elle des charges ?

    Charges
    ClassificationDatesStatutDétails
    Legal mortgage
    Créé le 25 juil. 2000
    Livré le 04 août 2000
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee
    Brèves mentions
    The property known as hersham golf course, hersham, surrey, all moveable plant machinery implements utensils, furniture and equipment building and other materials goods and other effects, all goodwill, full benefit of all licences held in connection with the business.
    Personnes ayant droit
    • Coutts & Company
    Transactions
    • 04 août 2000Enregistrement d'une charge (395)
    • 08 mars 2001Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Mortgage debenture
    Créé le 20 juin 2000
    Livré le 24 juin 2000
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    A specific equitable charge over all freehold and leasehold properties and/or the proceeds of sale thereof fixed and floating charges over undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts and the benefits of any licences.
    Personnes ayant droit
    • Coutts & Company
    Transactions
    • 24 juin 2000Enregistrement d'une charge (395)
    • 08 mars 2001Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Legal charge
    Créé le 15 juil. 1997
    Livré le 24 juil. 1997
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Hersham village golf club molesey road hersham surrey. All that f/h land lying to the east of molesey road hersham t/no.SY504264 and all that land comprising part of assher road off molesey road walton-on-thames t/no.SY515068. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Barclays Bank PLC
    Transactions
    • 24 juil. 1997Enregistrement d'une charge (395)
    • 08 mars 2001Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Guarantee and debenture
    Créé le 07 juil. 1997
    Livré le 14 juil. 1997
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    The principal at any time but excluding the investment income from time to time earned there on (both capitalised terms having the meaning given thereto in section 11-2.1(b) of the new york estates powers and trusts law) and the property in the actual and sole possession of the trustee (or held by the trustee in the name of a nominee at any time and held under the provisions of the trust deed allocable to the particular trust created by the company with respect to the particular year of account of the relevant syndicate and cash drawn down on any letter of credit at any time and held as an asset of the fund held under the provisions of the trust deed and other property referred to in the trust deed.
    Personnes ayant droit
    • Barclays Bank PLC
    Transactions
    • 14 juil. 1997Enregistrement d'une charge (395)
    • 08 mars 2001Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Fixed charge
    Créé le 01 sept. 1995
    Livré le 07 sept. 1995
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    By way of legal mortgage f/h property together with the buildings erected thereon or on part thereof (if any) k/a the former hersahm tree nursery hersham surrey t/n's SY504264 and SY515068 (including all fittings and fixtures thereon), assings all rents and other income or sums and any vat thereon, fixed charge all right title and interest in any proceeds of any insurance. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Anglo Irish Bank Corporation PLC
    Transactions
    • 07 sept. 1995Enregistrement d'une charge (395)
    • 08 mars 2001Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Fixed charge
    Créé le 04 août 1995
    Livré le 12 août 1995
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    F/H property together with the buildings erected thereon or on part thereof (if any) k/a the former hersham tree nursery hersham surrey t/n SY504264 and title possessory SY515068 (including all fittings and fixtures thereon), assigns all rents and other income. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Anglo Irish Bank Corporation PLC
    Transactions
    • 12 août 1995Enregistrement d'une charge (395)
    • 05 sept. 1995Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Charge and assignment
    Créé le 04 août 1995
    Livré le 12 août 1995
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    An option agreement dated 14 july 1993 relating to land at hersham the nursery hersham surrey and an agreement made on or around the date of the charge relating to the acquisition by the company from cedarmarsh limited of rights under the 1993 agreement. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Anglo Irish Bank Corporation PLC
    Transactions
    • 12 août 1995Enregistrement d'une charge (395)
    • 08 mars 2001Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Charge over deposit account
    Créé le 04 août 1995
    Livré le 12 août 1995
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the facility letter dated 26 july 1995 (as therein defined)
    Brèves mentions
    All monies which may from time to time constitute the balance standing to the credit of sterling deposit account no. 313/311936/01 (including interest (if any) arising on such monies credited thereto and all right title interest in the account.
    Personnes ayant droit
    • Anglo Irish Bank Corporation PLC
    Transactions
    • 12 août 1995Enregistrement d'une charge (395)
    • 05 juin 2001Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Deed
    Créé le 29 mai 1992
    Livré le 05 juin 1992
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the principal deed dated 29/2/92
    Brèves mentions
    The companys assets as referred to in the principal deed.
    Personnes ayant droit
    • Allied Irish Banks,PLC
    Transactions
    • 05 juin 1992Enregistrement d'une charge (395)
    • 08 mars 2001Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Mortgage debenture
    Créé le 29 févr. 1992
    Livré le 11 mars 1992
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personnes ayant droit
    • Allied Irish Banks,PLC
    Transactions
    • 11 mars 1992Enregistrement d'une charge (395)
    • 08 mars 2001Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Mortgage
    Créé le 09 févr. 1989
    Livré le 23 févr. 1989
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    The property k/a 42/44 the priory, queensway, birmingham. With buildings & fixtures. The goodwill of the company.. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Personnes ayant droit
    • Lloyds Bank PLC
    Transactions
    • 23 févr. 1989Enregistrement d'une charge
    • 20 sept. 2001Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Legal charge
    Créé le 30 déc. 1988
    Livré le 05 janv. 1989
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Freehold land hereditaments and premises situate in dysart park, grantham lincolnshire.
    Personnes ayant droit
    • Midland Bank PLC
    Transactions
    • 05 janv. 1989Enregistrement d'une charge
    • 05 juin 2001Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Mortgage
    Créé le 27 mai 1988
    Livré le 10 juin 1988
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    7/13 high st sittingbourne kent t/n k 72079, k 190057 k 477340, k 606984, 5 606985 k 359726, k 533817 and part k 422738. part k 192474 and part k 559726 and part k 408851 together with all buildings and fixtures goodwill if any. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Personnes ayant droit
    • Lloyds Bank PLC
    Transactions
    • 10 juin 1988Enregistrement d'une charge
    • 20 sept. 2001Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Legal charge
    Créé le 25 mars 1988
    Livré le 26 mars 1988
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    L/H property k/a or being 42/44 the priory queensway birmingham.
    Personnes ayant droit
    • Robert Fraser & Partners Limited
    Transactions
    • 26 mars 1988Enregistrement d'une charge
    • 20 sept. 2001Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Legal charge
    Créé le 25 sept. 1987
    Livré le 14 oct. 1987
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    7-13 high street (odd nos) sittingbourne kent t/nos k 72079, k 19005M, k 477340, k 533817, and part t/nos k 42273, k 559726 k 192474 & k 408851.
    Personnes ayant droit
    • Barclays Bank PLC
    Transactions
    • 14 oct. 1987Enregistrement d'une charge
    Legal charge
    Créé le 25 sept. 1987
    Livré le 08 oct. 1987
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    £500,000 and all other monies due or to become due from the company to the chargee. Under the terms of the charge
    Brèves mentions
    F/H property k/a hulburds department store 7/13 high street sittingbourne kent. T/nos k 72079, k 190057, k 477340 and parts of t/nos K422738, k 192474. k 559726 and k 408851 and the l/h property forming part of hulbards department store aforesaid and known as bell house, bell road sittingbourne t/n k 533817 and all buildings (see doc for full details.
    Personnes ayant droit
    • Hulburds (Sittingbourne) Limited
    Transactions
    • 08 oct. 1987Enregistrement d'une charge
    Guarantee & debenture
    Créé le 03 avr. 1987
    Livré le 09 avr. 1987
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company and/or berwick salmon fisheries company limited to the chargee on any account whatesoever.
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personnes ayant droit
    • Barclays Bank PLC
    Transactions
    • 09 avr. 1987Enregistrement d'une charge
    Debenture
    Créé le 21 déc. 1985
    Livré le 06 janv. 1986
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personnes ayant droit
    • Barclays Bank PLC
    Transactions
    • 06 janv. 1986Enregistrement d'une charge

    SURREY GROUP LIMITED a-t-elle des procédures d'insolvabilité ?

    Numéro de dossierDatesTypePraticiensAutre
    1
    DateType
    23 avr. 2014Dissolved on
    30 juin 2011Commencement of winding up
    Members voluntary liquidation
    NomRôleAdresseNommé leCessé le
    Jeremy Simon Spratt
    8 Salisbury Square
    EC4Y 8BB London
    practitioner
    8 Salisbury Square
    EC4Y 8BB London
    John David Thomas Milsom
    8 Salisbury Square
    EC4Y 8BB London
    practitioner
    8 Salisbury Square
    EC4Y 8BB London
    Allan Watson Graham
    Kpmg Restructuring
    8 Salisbury Square
    EC4Y 8BB London
    practitioner
    Kpmg Restructuring
    8 Salisbury Square
    EC4Y 8BB London

    Source de données

    • Companies House du Royaume-Uni
      Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers.
    • Licence: CC0