FINE FARE PROPERTIES LIMITED

FINE FARE PROPERTIES LIMITED

  • Vue d'ensemble
  • Résumé
  • Objet social
  • Adresse
  • Dénominations sociales précédentes
  • Comptes
  • Dépôts
  • Dirigeants
  • Charges
  • Source de données
  • Vue d'ensemble

    Nom de la sociétéFINE FARE PROPERTIES LIMITED
    Statut de la sociétéConverti / Fermé
    Forme juridiqueConverti ou fermé
    Numéro de société 00002907
    JuridictionAngleterre/Pays de Galles
    Date de création
    Date de cessation d'activité

    Résumé

    A des PSCs super sécurisésNon
    A des chargesOui
    A un historique d'insolvabilitéNon
    Le siège social est contestéNon

    Quel est l'objet de FINE FARE PROPERTIES LIMITED ?

    • (7020) /

    Où se situe FINE FARE PROPERTIES LIMITED ?

    Adresse du siège social
    New Century House
    Corporation Street
    M60 4ES Manchester
    United Kingdom
    Adresse du siège social non livrableNon

    Quels étaient les noms précédents de FINE FARE PROPERTIES LIMITED ?

    Dénominations sociales précédentes
    Nom de la sociétéDeJusqu'au
    AERATED BREAD COMPANY LIMITED28 oct. 186228 oct. 1862

    Quels sont les derniers comptes de FINE FARE PROPERTIES LIMITED ?

    En retardOui
    Prochains comptes
    Fin de la prochaine période comptable le04 janv. 2011
    Date d'échéance des prochains comptes04 oct. 2011
    Derniers comptes
    Derniers comptes arrêtés au02 janv. 2010

    Quels sont les derniers dépôts pour FINE FARE PROPERTIES LIMITED ?

    Dépôts
    DateDescriptionDocumentType

    Certificat d'immatriculation d'une société de secours mutuel

    pagesCERTIPS

    Divers

    Forms b and z- conversion to I &ps
    pagesMISC

    Résolutions

    Resolutions
    pagesRESOLUTIONS
    Résolutions
    CatégorieDateDescriptionType
    capital

    Résolutions

    Convert to I & ps 05/10/2010
    RES13

    Nomination de Mr Stephen Parry en tant que secrétaire

    pagesAP03

    Déclaration annuelle jusqu'au 01 sept. 2010 avec liste complète des actionnaires

    pagesAR01
    Dépôts associés
    CatégorieDateDescriptionType
    capital14 sept. 2010

    État du capital au 14 sept. 2010

    • Capital: GBP 20,045,030
    SH01

    Comptes pour une société dormante établis au 02 janv. 2010

    pagesAA

    Modification des coordonnées de l'administrateur Mr Timothy Hurrell le 01 août 2010

    pagesCH01

    Modification des coordonnées de l'administrateur Mr Stephen Humes le 01 août 2010

    pagesCH01

    Changement d'adresse du siège social de Somerfield House Whitchurch Lane Bristol BS14 0TJ le 23 févr. 2010

    pagesAD01

    Comptes annuels établis au 02 mai 2009

    pagesAA

    Période comptable actuelle raccourcie du 30 avr. 2010 au 04 janv. 2010

    pagesAA01

    Démission de l'auditeur

    pagesAUD

    Cessation de la nomination de William Robson en tant que directeur

    pagesTM01

    Nomination de Mrs Caroline Jane Sellers en tant que secrétaire

    pagesAP03

    Cessation de la nomination de Emily Martin en tant que secrétaire

    pagesTM02

    legacy

    pages363a

    legacy

    pages288b

    legacy

    pages363a

    legacy

    pages288a

    legacy

    pages288a

    legacy

    pages288b

    legacy

    pages288a

    Comptes annuels établis au 26 avr. 2008

    pagesAA

    legacy

    pages363a

    Comptes annuels établis au 28 avr. 2007

    pagesAA

    Qui sont les dirigeants de FINE FARE PROPERTIES LIMITED ?

    Dirigeants
    NomNommé leDate de démissionRôleAdresseIdentification de la sociétéPays de résidenceNationalitéDate de naissanceProfessionNuméro
    PARRY, Stephen
    Corporation Street
    M60 4ES Manchester
    New Century House
    United Kingdom
    Secrétaire
    Corporation Street
    M60 4ES Manchester
    New Century House
    United Kingdom
    154611440001
    SELLERS, Caroline Jane
    Corporation Street
    M60 4ES Manchester
    New Century House
    M60 4es
    United Kingdom
    Secrétaire
    Corporation Street
    M60 4ES Manchester
    New Century House
    M60 4es
    United Kingdom
    146911920001
    HUMES, Stephen
    c/o Governance Department
    Corporation Street
    M60 4ES Manchester
    5th Floor, New Century House
    United Kingdom
    Administrateur
    c/o Governance Department
    Corporation Street
    M60 4ES Manchester
    5th Floor, New Century House
    United Kingdom
    United KingdomBritishFinance Director84087790001
    HURRELL, Timothy
    c/o Governance Department
    Corporation Street
    M60 4ES Manchester
    5th Floor, New Century House
    United Kingdom
    Administrateur
    c/o Governance Department
    Corporation Street
    M60 4ES Manchester
    5th Floor, New Century House
    United Kingdom
    United KingdomBritishGeneral Manager Food Group99724260001
    BROWN, Michael Alfred
    Windrush Great Billing Park
    NN3 9BL Northampton
    Northamptonshire
    Secrétaire
    Windrush Great Billing Park
    NN3 9BL Northampton
    Northamptonshire
    British50692920001
    EGITTO, Joleen
    3 Abbots Close
    Whitchurch
    BS14 0UD Bristol
    Secrétaire
    3 Abbots Close
    Whitchurch
    BS14 0UD Bristol
    British61599540001
    GRANT, Stephen Martin
    3 Trelawn Court
    Rodney Road
    GL50 1JJ Cheltenham
    Gloucestershire
    Secrétaire
    3 Trelawn Court
    Rodney Road
    GL50 1JJ Cheltenham
    Gloucestershire
    British20888800002
    GRANT, Stephen Martin
    2 Beechwood Close
    Battledown
    GL52 6QQ Cheltenham
    Gloucestershire
    Secrétaire
    2 Beechwood Close
    Battledown
    GL52 6QQ Cheltenham
    Gloucestershire
    British20888800001
    HENSHAW, Stephen Anthony
    Eastleigh Stables
    Bishopstrow
    BA12 9HW Warminster
    Wiltshire
    Secrétaire
    Eastleigh Stables
    Bishopstrow
    BA12 9HW Warminster
    Wiltshire
    BritishCompany Secretary91828160006
    MARTIN, Emily Louise
    49 Henley Park
    Yatton
    BS49 4JJ Bristol
    Secrétaire
    49 Henley Park
    Yatton
    BS49 4JJ Bristol
    BritishCompany Secretary115285710001
    ASHTON, Yvonne Margaret
    1 West Dene
    Stoke Bishop
    BS9 2BQ Bristol
    Avon
    Administrateur
    1 West Dene
    Stoke Bishop
    BS9 2BQ Bristol
    Avon
    BritishChartered Accountant45225070002
    BACK, Steven John
    Fennels 119 Bicester Road
    Lower End
    HP18 9EF Long Crendon
    Administrateur
    Fennels 119 Bicester Road
    Lower End
    HP18 9EF Long Crendon
    United KingdomBritishFinance Director85825120001
    CHEYNE, David George Thomson
    The Covert 98 Woodlands Road
    Ashurst
    SO40 7AH Southampton
    Hampshire
    Administrateur
    The Covert 98 Woodlands Road
    Ashurst
    SO40 7AH Southampton
    Hampshire
    BritainBritishCompany Director74956170001
    CLELAND, Jonathan Bradley
    70 Andes Close
    Ocean Village
    SO14 3HS Southampton
    Administrateur
    70 Andes Close
    Ocean Village
    SO14 3HS Southampton
    BritishRetail Director111624590001
    COATES, Philip Raymond
    2 Berestede Road
    W6 9NP London
    Administrateur
    2 Berestede Road
    W6 9NP London
    United KingdomBritishChartered Surveyor60114990002
    COOPER, Geoffrey Ian
    Crossways House Old Coach Road
    Cross
    BS26 2EL Axbridge
    Somerset
    Administrateur
    Crossways House Old Coach Road
    Cross
    BS26 2EL Axbridge
    Somerset
    BritishCost & Management Accountant59071930001
    GATTO, Salvatore Martin
    11 Cavendish Lodge
    Cavendish Road
    BA1 2UD Bath
    Avon
    Administrateur
    11 Cavendish Lodge
    Cavendish Road
    BA1 2UD Bath
    Avon
    United KingdomBritishFinance Director37327260002
    GRANT, Stephen Martin
    3 Trelawn Court
    Rodney Road
    GL50 1JJ Cheltenham
    Gloucestershire
    Administrateur
    3 Trelawn Court
    Rodney Road
    GL50 1JJ Cheltenham
    Gloucestershire
    BritishCompany Secretary20888800002
    HARTE, Damien Bernard
    13 Cambridge Park
    Redland
    BS6 6XW Bristol
    Administrateur
    13 Cambridge Park
    Redland
    BS6 6XW Bristol
    BritishCertified Accountant33922420001
    HENSHAW, Stephen Anthony
    2 Ashton Coombe Lower Road
    Bratton
    BA13 4JQ Westbury
    Wiltshire
    Administrateur
    2 Ashton Coombe Lower Road
    Bratton
    BA13 4JQ Westbury
    Wiltshire
    BritishDirector91828160003
    MITCHELL INNES, Alistair Campbell
    Langton Lodge Station Road
    Sunningdale
    SL5 0QR Ascot
    Berkshire
    Administrateur
    Langton Lodge Station Road
    Sunningdale
    SL5 0QR Ascot
    Berkshire
    BritishChief Executive1386650001
    NELLIST, Robert Henry Harger
    Spooners 28 Park St Lane
    Park Street
    AL2 2JB St Albans
    Hertfordshire
    Administrateur
    Spooners 28 Park St Lane
    Park Street
    AL2 2JB St Albans
    Hertfordshire
    BritishChartered Accountant5435750001
    ROBSON, William Henry Mark
    12 Kimble Close
    Knightcote
    CV47 2SJ Southam
    Warwickshire
    Administrateur
    12 Kimble Close
    Knightcote
    CV47 2SJ Southam
    Warwickshire
    EnglandBritishFinance Director57803420002
    SHARP, Ernest Henry
    36 Tufton Court Tufton Street
    Westminster
    SW1P 3QH London
    Administrateur
    36 Tufton Court Tufton Street
    Westminster
    SW1P 3QH London
    BritishChartered Accountant777200001
    SMITH, Alan Frank
    Brambledown Grove Farm
    Droitwich Road Feckenham
    B96 6JA Redditch
    Worcestershire
    Administrateur
    Brambledown Grove Farm
    Droitwich Road Feckenham
    B96 6JA Redditch
    Worcestershire
    BritishDirector46000100003
    SMITH, Neil Reynold
    27 Broom Farm Close
    Nailsea
    BS48 4YJ Bristol
    Administrateur
    27 Broom Farm Close
    Nailsea
    BS48 4YJ Bristol
    BritishCompany Director61599510002

    FINE FARE PROPERTIES LIMITED a-t-elle des charges ?

    Charges
    ClassificationDatesStatutDétails
    Standard security
    Créé le 08 oct. 1993
    Livré le 18 oct. 1993
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    L/H subjects at unit 1/2 (otherwise 182) township centre easterhouse glasgow t/no GLA101661.
    Personnes ayant droit
    • Samuel Montagu & Co Limitedas Agent & Trustee for Itself & the Banks (As Defined in the Charge)
    Transactions
    • 18 oct. 1993Enregistrement d'une charge (395)
    Standard security reg in scotland 06/09/93
    Créé le 06 sept. 1993
    Livré le 24 sept. 1993
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All moneys due or to become due from the company to samuel montagu & co limited as agent and trustee for itself and the banks (as defined) on any account whatsoever under the terms of the composite guarantee and debenture
    Brèves mentions
    Car park at weaver row srirling.
    Personnes ayant droit
    • Samuel Montagu & Co Limitedas Agent and Trustee for Itself and the Banks
    Transactions
    • 24 sept. 1993Enregistrement d'une charge (395)
    Standard security reg in scotland 06/09/93
    Créé le 06 sept. 1993
    Livré le 24 sept. 1993
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All moneys due or to become due from the company to samuel montagu & co limited as agent and trustee for itself and the banks (as defined) on any account whatsoever under the terms of the composite gaurantee and debenture
    Brèves mentions
    1588 great western road anniesland glasgow title no GLA100884.
    Personnes ayant droit
    • Samuel Montagu & Co Limitedasagent and Trustee for Itself and the Banks
    Transactions
    • 24 sept. 1993Enregistrement d'une charge (395)
    Standard security reg in scotland 06/09/93
    Créé le 06 sept. 1993
    Livré le 24 sept. 1993
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All moneys due or to become due from the company to samuel montagu & co limited as agent and trustee for itself and the banks (as defined) on any account whatsoever under the terms of the composite guarantee and debenture
    Brèves mentions
    Subjects at new cross centre hamilton,l/h subjects at 88 graham street airdrie title no LAN95127,l/h subjects at 275/277 main street bellshill title no LAN95128,l/h subjects at 28/32 the plaza town centre east kilbride title no LAN95129,l/h subjects at 300 victoria road glasgow title no GLA100883,l/h subjects forming part of shillinghill alloa.
    Personnes ayant droit
    • Samuel Montagu & Co Limitedas Agent and Trustee for Itself and the Banks
    Transactions
    • 24 sept. 1993Enregistrement d'une charge (395)
    Standard security reg in scotland 06/09/93
    Créé le 06 sept. 1993
    Livré le 22 sept. 1993
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All moneys due or to become due from the company to samuel montagu & co limited as agent and trusteee for itself and the banks (as defined) on any account whatsoever under the terms of the composite guarantee and debenture dated 05/07/93
    Brèves mentions
    Area of ground in sinclair street helensburgh title no DMB11150 subjects under title no DMB16528 subjects on the south west side of carrochan road and north west side of lomond road balloch title no DMB18240.
    Personnes ayant droit
    • Samuel Montagu & Co Limitedas Agent and Trustee for Itself and the Banks
    Transactions
    • 22 sept. 1993Enregistrement d'une charge (395)
    Standard security reg in scotland 02/09/93
    Créé le 02 sept. 1993
    Livré le 22 sept. 1993
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All moneys due or to become due from the company to the chargee as agent and trustee for itself and the banks (as defined) on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Shop premises at high street lochee dundee.
    Personnes ayant droit
    • Samuel Montagu & Co Limitedas Agent and Trustee for Itself and the Banks
    Transactions
    • 22 sept. 1993Enregistrement d'une charge (395)
    Standard security reg in scotlands 02/09/93
    Créé le 02 sept. 1993
    Livré le 22 sept. 1993
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All moneys due or to become due from the company to the chargee as agent and trustee for itself and the banks (as defined) on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Retaildevelopment at high street cowdenbeath.
    Personnes ayant droit
    • Samuel Montagu & Co Limitedas Agent and Trustee for Itself and the Banks
    Transactions
    • 22 sept. 1993Enregistrement d'une charge (395)
    Standard security reg in scotland 02/09/93
    Créé le 02 sept. 1993
    Livré le 22 sept. 1993
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All moneys due or to become due from the company to the chargee as agent and trustee for itself and the banks (as defined) on any account whatsoever
    Brèves mentions
    101/105 high street invergordon.
    Personnes ayant droit
    • Samuel Montagu & Co Limitedas Agent and Trustee for Itself and the Banks
    Transactions
    • 22 sept. 1993Enregistrement d'une charge (395)
    Standard security reg in scotland 02/09/93
    Créé le 02 sept. 1993
    Livré le 22 sept. 1993
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All moneys due or to become due from the company to the chargee as agent and trustee for itself and the banks (as defined) on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Retail store at 46/48 high street alness.
    Personnes ayant droit
    • Samuel Montagu & Co Limitedas Agent and Trustee for Itself and the Banks (As Defined)
    Transactions
    • 22 sept. 1993Enregistrement d'une charge (395)
    Standard security reg in scotland 02/09/93
    Créé le 02 sept. 1993
    Livré le 22 sept. 1993
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All moneys due or to become due from the company to the chargee as agent and trustee for itself and the banks (as defined) on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Subjects at shillinghill alloa and dingwall,l/h 15/17 and 26 main street prestwick,l/h 485 great western road aberdeen,l/h 26/30 swan street brechin,l/h 45 castle street forfar,l/h 114 dalry road edinburgh,l/h 23 unicorn way glenrothes,subjects at grampian road aviemore.
    Personnes ayant droit
    • Samuel Montagu & Co Limitedas Agent and Trustee for Itself and the Banks (As Defined)
    Transactions
    • 22 sept. 1993Enregistrement d'une charge (395)
    • 27 juil. 1994Déclaration que tout ou partie de la propriété d'une charge flottante a été libérée (403b)
    Composite guarantee and debenture
    Créé le 05 juil. 1993
    Livré le 16 juil. 1993
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due from the company,each other group company (as defined) andany other present or future subsidiary of gateway group limited (as defined) to the chargee and/or the facility agent and/or the security agent (as defined)
    Brèves mentions
    See form 395. fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personnes ayant droit
    • Samuel Montagu & Co. Limitedas Agent and Trustee for the Banks (As Defined)
    Transactions
    • 16 juil. 1993Enregistrement d'une charge (395)
    • 18 mars 1994Déclaration que tout ou partie de la propriété d'une charge flottante a été libérée (403b)
    • 13 août 1996Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Supplemental deed
    Créé le 05 juil. 1993
    Livré le 15 juil. 1993
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All moneys due or to become due from the company to the chargee as agent and trustee for the lenders in respect of a guarantee & debenture dated 25/10/89 as amended by a supplemental deed dated 05/07/93
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personnes ayant droit
    • Samuel Montagu & Co Limitedas Agent and Trustee
    Transactions
    • 15 juil. 1993Enregistrement d'une charge (395)
    • 18 mars 1994Déclaration que tout ou partie de la propriété d'une charge flottante a été libérée (403b)
    • 13 août 1996Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Standard security
    Créé le 19 sept. 1991
    Livré le 04 oct. 1991
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee (under the terms of the guarantee & debenture dated 25.10.89 and the charge
    Brèves mentions
    Subjects k/a new cross centre, hamilton. (For full details refer to doc 395 ref M216C).
    Personnes ayant droit
    • Samuel Montagu & Co Limited
    Transactions
    • 04 oct. 1991Enregistrement d'une charge
    Standard security
    Créé le 19 sept. 1991
    Livré le 02 oct. 1991
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of a guarantee and debenture dated 25.10.1991
    Brèves mentions
    Shillinghill place alloa and others.
    Personnes ayant droit
    • Samuel Montagu & Co Limited
    Transactions
    • 02 oct. 1991Enregistrement d'une charge (395)
    Standard security
    Créé le 19 sept. 1991
    Livré le 26 sept. 1991
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the guarantee & debenture dated 25.10.89 & all other security documents
    Brèves mentions
    Area of ground at sinclair st, helensburgh county of dumbarton title no dmb 11150 & lease by strathclyde regional council in favour of the fine fare limited title no dmb 16528.
    Personnes ayant droit
    • Samuel Montagu & Co Limited
    Transactions
    • 26 sept. 1991Enregistrement d'une charge
    • 23 oct. 1996Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Legal charge
    Créé le 29 oct. 1990
    Livré le 02 nov. 1990
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to be come due from each obligen to the chagee on any account whatsoever to the agent and the banks or any of them (as defined in the charge) under the terms of the financing documents to which such obliger is a party and of each olbiger to the subordinated lenders agent and to the subordinated lenders under the subordinated facilities agreement (all as defined in the charge).
    Brèves mentions
    Various properties registered and unregistered, f'hold and r' hold. Please see form 395 (ref: M27) for full details.
    Personnes ayant droit
    • S G Warburg & Co LTD(As Security Agent)
    • G E Capital Corporate Finance Group Limited(As Subordinated Lenders Agent)
    Transactions
    • 02 nov. 1990Enregistrement d'une charge
    • 18 mars 1994Déclaration que tout ou partie de la propriété d'une charge flottante a été libérée (403b)
    • 29 mars 1994Déclaration que tout ou partie de la propriété d'une charge flottante a été libérée (403b)
    • 13 août 1996Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Guarantee and debenture
    Créé le 25 oct. 1989
    Livré le 31 oct. 1989
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from each obligor to the chargee as agent & trustee for itself and for the banks as defined in the charge & to G.e capital corporate furnace group limited as agent & trustee for the subordinated lenders (as defined) on any account whatsoever under the terms of the financing docs as defined in the charge & the subordinated facilities agreement dated 17.4.89
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personnes ayant droit
    • S.G. Warburg & Co Limited
    Transactions
    • 31 oct. 1989Enregistrement d'une charge
    • 01 nov. 1990Déclaration que tout ou partie de la propriété d'une charge flottante a été libérée (403b)
    • 18 mars 1994Déclaration que tout ou partie de la propriété d'une charge flottante a été libérée (403b)
    • 29 mars 1994Déclaration que tout ou partie de la propriété d'une charge flottante a été libérée (403b)
    • 31 mars 1994Déclaration que tout ou partie de la propriété d'une charge flottante a été libérée (403b)
    • 13 août 1996Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Standard security registered in scotland
    Créé le 07 août 1986
    Livré le 21 août 1986
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the charge
    Brèves mentions
    Charge over all the properties listed in the schedule attached to the form 395.
    Personnes ayant droit
    • Balfour Beatty Limited
    Transactions
    • 21 août 1986Enregistrement d'une charge
    Mortgage
    Créé le 24 nov. 1939
    Livré le 15 déc. 1939
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All moneys due etc
    Brèves mentions
    The camsden town bakery. Together with fixed and moveable plant machinery fixtures implements and utensils.
    Personnes ayant droit
    • National Prov Bank LTD
    Transactions
    • 15 déc. 1939Enregistrement d'une charge
    • 14 mai 2002Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Mortgage
    Créé le 24 nov. 1939
    Livré le 15 déc. 1939
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All moneys etc
    Brèves mentions
    29, kensington high st, london. Together with fixed and moveable plant machinery fixtures implements and utensils.
    Personnes ayant droit
    • National Provincial Bank LTD
    Transactions
    • 15 déc. 1939Enregistrement d'une charge
    Mortgage
    Créé le 24 nov. 1939
    Livré le 15 déc. 1939
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All moneys due etc
    Brèves mentions
    47, high st, floating, london. Together with fixed and moveable plant machinery fixtures implements and utensils.
    Personnes ayant droit
    • National Provincial Bank LTD
    Transactions
    • 15 déc. 1939Enregistrement d'une charge
    • 14 mai 2002Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Mortgage
    Créé le 24 nov. 1939
    Livré le 15 déc. 1939
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All moneys due etc
    Brèves mentions
    23, golden green rd, 1, accomodation rd, london, middx. Together with fixed and moveable plant machinery fixtures implements and utensils.
    Personnes ayant droit
    • National Provincial Bank LTD
    Transactions
    • 15 déc. 1939Enregistrement d'une charge
    • 14 mai 2002Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Mortgage
    Créé le 24 nov. 1939
    Livré le 15 déc. 1939
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All moneys due etc
    Brèves mentions
    11, princes parade, north finchley, middx. Together with fixed and moveable plant machinery fixtures implements and utensils.
    Personnes ayant droit
    • National Provincial Bank LTD
    Transactions
    • 15 déc. 1939Enregistrement d'une charge
    • 14 mai 2002Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)

    Source de données

    • Companies House du Royaume-Uni
      Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers.
    • Licence: CC0