FSP REALISATIONS PLC

  • Vue d'ensemble
  • Résumé
  • Objet social
  • Adresse
  • Dénominations sociales précédentes
  • Comptes
  • Dépôts
  • Dirigeants
  • Charges
  • Insolvabilité
  • Source de données
  • Vue d'ensemble

    Nom de la sociétéFSP REALISATIONS PLC
    Statut de la sociétéDissoute
    Forme juridiqueSociété anonyme cotée en bourse
    Numéro de société 00009081
    JuridictionAngleterre/Pays de Galles
    Date de création
    Date de cessation d'activité

    Résumé

    A des PSCs super sécurisésNon
    A des chargesOui
    A un historique d'insolvabilitéOui
    Le siège social est contestéNon

    Quel est l'objet de FSP REALISATIONS PLC ?

    • (2875) /

    Où se situe FSP REALISATIONS PLC ?

    Adresse du siège social
    Beaufort House
    94-96 Newhall Street
    B3 1PB Birmingham
    Adresse du siège social non livrableNon

    Quels étaient les noms précédents de FSP REALISATIONS PLC ?

    Dénominations sociales précédentes
    Nom de la sociétéDeJusqu'au
    FIRMIN & SONS P.L.C.04 janv. 187504 janv. 1875

    Quels sont les derniers comptes de FSP REALISATIONS PLC ?

    Derniers comptes
    Derniers comptes arrêtés au31 mars 2005

    Quels sont les derniers dépôts pour FSP REALISATIONS PLC ?

    Dépôts
    DateDescriptionDocumentType

    Gazette finale dissoute à la suite d'une liquidation

    1 pagesGAZ2

    Retour de la réunion finale dans une liquidation volontaire des créanciers

    3 pages4.72

    Déclaration des reçus et paiements des liquidateurs jusqu'à 31 mars 2011

    5 pages4.68

    Cessation de la nomination de Frederik Hsu en tant que directeur

    1 pagesTM01

    Déclaration des reçus et paiements des liquidateurs jusqu'à 30 sept. 2010

    5 pages4.68

    Déclaration des reçus et paiements des liquidateurs jusqu'à 31 mars 2010

    5 pages4.68

    Dépôt d'insolvabilité

    INSOLVENCY:sos cert release of liquidator
    1 pagesLIQ MISC

    Avis de cessation d'agir en tant que liquidateur volontaire

    1 pages4.40

    Ordonnance du tribunal d'insolvabilité

    Court order insolvency:- replacement of liquidator
    30 pagesLIQ MISC OC

    Nomination d'un liquidateur volontaire

    1 pages600

    Déclaration des reçus et paiements des liquidateurs jusqu'à 30 sept. 2009

    5 pages4.68

    Dépôt d'insolvabilité

    Insolvency:secretary of state's release of liquidator
    1 pagesLIQ MISC

    Avis de cessation d'agir en tant que liquidateur volontaire

    1 pages4.40

    Déclaration des reçus et paiements des liquidateurs jusqu'à 31 mars 2009

    5 pages4.68

    Déclaration des reçus et paiements des liquidateurs jusqu'à 30 sept. 2008

    5 pages4.68

    Ordonnance du tribunal d'insolvabilité

    Court order INSOLVENCY:replacement of liquidator
    14 pagesLIQ MISC OC

    Nomination d'un liquidateur volontaire

    1 pages600

    Dépôt d'insolvabilité

    Insolvency:miscellaneous ;- secretary of state's certificate of release of liquiidator
    1 pagesLIQ MISC

    Dépôt d'insolvabilité

    Insolvency:secretary of state's release of liquidator
    1 pagesLIQ MISC

    Déclaration des reçus et paiements des liquidateurs jusqu'à 30 sept. 2008

    5 pages4.68

    Avis de transition de l'administration à la liquidation volontaire des créanciers

    6 pages2.34B

    legacy

    1 pages288b

    Déclaration des affaires

    11 pages2.16B

    Rapport d'avancement de l'administrateur

    11 pages2.24B

    Résultat de la réunion des créanciers

    5 pages2.23B

    Qui sont les dirigeants de FSP REALISATIONS PLC ?

    Dirigeants
    NomNommé leDate de démissionRôleAdresseIdentification de la sociétéPays de résidenceNationalitéDate de naissanceProfessionNuméro
    CHIU, Cheung Yau Pedro
    15/F Fung House
    19-20 Connaught Road Central
    FOREIGN Hong Kong
    China
    Administrateur
    15/F Fung House
    19-20 Connaught Road Central
    FOREIGN Hong Kong
    China
    ChineseManager90150720001
    HSU, Keith Kai-Foo
    Berkswell House
    CV7 7BW Berkswell
    Warwickshire
    Administrateur
    Berkswell House
    CV7 7BW Berkswell
    Warwickshire
    BritishCo Director4818510002
    ALLSOPP, Ronald James
    Gateshaw
    Shillinglee Road
    RH14 0PQ Plaistow
    West Sussex
    Secrétaire
    Gateshaw
    Shillinglee Road
    RH14 0PQ Plaistow
    West Sussex
    British38240930006
    DONNELLY, Roy Kevin
    Flat 11
    22 Artillery Street
    B9 4QH Birmingham
    West Midlands
    Secrétaire
    Flat 11
    22 Artillery Street
    B9 4QH Birmingham
    West Midlands
    British73942190001
    PETERS, Kenneth Vincent
    6 Woodlands Road
    Wombourne
    WV5 0JZ Wolverhampton
    West Midlands
    Secrétaire
    6 Woodlands Road
    Wombourne
    WV5 0JZ Wolverhampton
    West Midlands
    BritishAccountant54972530001
    EDGE, Barrington
    12 Eastwood Avenue
    Burntwood
    WS7 8DX Walsall
    West Midlands
    Administrateur
    12 Eastwood Avenue
    Burntwood
    WS7 8DX Walsall
    West Midlands
    BritishWorks Director20382570001
    EDWARDS, William Harold
    Attwood Cottage
    Church Hill Bishops Tachbrook
    CV33 9RJ Leamington Spa
    Warwickshire
    Administrateur
    Attwood Cottage
    Church Hill Bishops Tachbrook
    CV33 9RJ Leamington Spa
    Warwickshire
    BritishCo Director4818520002
    HSU, Frederik Louis Tsun Meng
    Berkswell House
    Berkswell
    CV7 7BW Warwickshire
    Administrateur
    Berkswell House
    Berkswell
    CV7 7BW Warwickshire
    EnglandBritishCo Director54972490001
    HSU, Marvin
    Flat 2j Shan Kwong Towers 24 Shawk
    Kwong Road
    Happy Valley
    Hong Kong
    Administrateur
    Flat 2j Shan Kwong Towers 24 Shawk
    Kwong Road
    Happy Valley
    Hong Kong
    CanadianCompany Director67355090001
    MATTINGLY, William Reginald
    62 Briarsleigh
    ST17 4QP Stafford
    Staffordshire
    Administrateur
    62 Briarsleigh
    ST17 4QP Stafford
    Staffordshire
    BritishCo Director5714600001
    RIDDLE, Mark Andrew
    Stonelee 78 Harborough Road North
    Broughton
    NN2 8LZ Northampton
    Northamptonshire
    Administrateur
    Stonelee 78 Harborough Road North
    Broughton
    NN2 8LZ Northampton
    Northamptonshire
    BritishDirector109955530001
    SIMMONS, Michael Colin
    11 Flax Piece
    WR7 4PA Upton Snodsbury
    Worcestershire
    Administrateur
    11 Flax Piece
    WR7 4PA Upton Snodsbury
    Worcestershire
    BritishExport Director55009580001
    SPEIRS, David Leslie, Dr
    The Old Tythe Barn
    Bredicot Lane
    WR7 4AY Crowle
    Worcestershire
    Administrateur
    The Old Tythe Barn
    Bredicot Lane
    WR7 4AY Crowle
    Worcestershire
    BritishCo Director73521030002

    FSP REALISATIONS PLC a-t-elle des charges ?

    Charges
    ClassificationDatesStatutDétails
    Debenture
    Créé le 30 juin 2001
    Livré le 07 juil. 2001
    En cours
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Hsbc Bank PLC
    Transactions
    • 07 juil. 2001Enregistrement d'une charge (395)
    Fixed charge on purchased debts which fail to vest
    Créé le 04 avr. 2001
    Livré le 05 avr. 2001
    En cours
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee whether arising under an agreement for the purchase of debts or otherwise
    Brèves mentions
    By way of fixed equitable charge all debts purchased or purported to be purchased by the security holder pursuant to an agreement for the purchase of debts between the security holder and the company (including associated rights relating thereto) which fail to vest effectively or absolutely in the security holder for any reason.
    Personnes ayant droit
    • Hsbc Invoice Finance (UK) LTD
    Transactions
    • 05 avr. 2001Enregistrement d'une charge (395)
    Charge
    Créé le 10 nov. 1994
    Livré le 15 nov. 1994
    En cours
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Fixed charge on all goodwill and uncalled capital for the time being of the company; and all patents patent applications inventions trade marks trade names etc.
    Personnes ayant droit
    • Midland Bank PLC
    Transactions
    • 15 nov. 1994Enregistrement d'une charge (395)
    Charge
    Créé le 25 janv. 1993
    Livré le 28 janv. 1993
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    £49,063 due from the company to the chargee pursuant to the terms of the agreement
    Brèves mentions
    All its right title and interest in and to all sums payable under the insurance, particulars whereof are set out on the reverse of the form 395 and continuation sheet.
    Personnes ayant droit
    • Close Brothers Limited
    Transactions
    • 28 janv. 1993Enregistrement d'une charge (395)
    • 08 mars 1995Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Agreement for deposit of rent.
    Créé le 01 août 1989
    Livré le 18 août 1989
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from and/or diaward equipment (UK) limited. The company to the chargee. Under the terms of a lease dated 25TH january 1986.
    Brèves mentions
    The sum of forty thousand pounds held in a separate bank account in the name of boasey & hawkes properties limited.
    Personnes ayant droit
    • Boasey & Hawkes Properties Limited.
    Transactions
    • 18 août 1989Enregistrement d'une charge
    • 15 mars 1995Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Legal charge
    Créé le 14 août 1987
    Livré le 19 août 1987
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Land k/a unit 3 hatchett street, newtown, birmingham l/hold title no wm 13659.
    Personnes ayant droit
    • Midland Bank PLC
    Transactions
    • 19 août 1987Enregistrement d'une charge
    • 16 avr. 1997Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Legal charge
    Créé le 14 août 1987
    Livré le 19 août 1987
    En cours
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    F/Hold land on the south side of hatchett street newtown birmingham title no wm 222515.
    Personnes ayant droit
    • Midland Bank PLC
    Transactions
    • 19 août 1987Enregistrement d'une charge
    Fixed and floating charge
    Créé le 16 déc. 1986
    Livré le 19 déc. 1986
    En cours
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Fixed and floating charge over undertaking and all property and assets present and future including book debts and uncalled capital.
    Personnes ayant droit
    • Midland Bank PLC
    Transactions
    • 19 déc. 1986Enregistrement d'une charge

    FSP REALISATIONS PLC a-t-elle des procédures d'insolvabilité ?

    Numéro de dossierDatesTypePraticiensAutre
    1
    DateType
    04 avr. 2006Administration started
    01 avr. 2007Administration ended
    In administration
    NomRôleAdresseNommé leCessé le
    Nigel Price
    Moore Stephens Llp
    Beaufort House
    B3 1PB 94-96 Newhall Street
    Birmingham
    practitioner
    Moore Stephens Llp
    Beaufort House
    B3 1PB 94-96 Newhall Street
    Birmingham
    Mark Elijah Thomas Bowen
    Moore Stephens Llp
    Beaufort House
    B3 1PB 94-96 Newhall Street
    Birmingham
    practitioner
    Moore Stephens Llp
    Beaufort House
    B3 1PB 94-96 Newhall Street
    Birmingham
    2
    DateType
    01 avr. 2007Commencement of winding up
    24 août 2011Dissolved on
    Creditors voluntary liquidation
    NomRôleAdresseNommé leCessé le
    Nigel Price
    Moore Stephens Llp
    Beaufort House
    B3 1PB 94-96 Newhall Street
    Birmingham
    practitioner
    Moore Stephens Llp
    Beaufort House
    B3 1PB 94-96 Newhall Street
    Birmingham
    Mark Elijah Thomas Bowen
    Moore Stephens Llp
    Beaufort House
    B3 1PB 94-96 Newhall Street
    Birmingham
    practitioner
    Moore Stephens Llp
    Beaufort House
    B3 1PB 94-96 Newhall Street
    Birmingham
    Colin Andrew Prescott
    Moore Stephens
    1/2 Little King Street
    BS1 4HW Bristol
    practitioner
    Moore Stephens
    1/2 Little King Street
    BS1 4HW Bristol
    David Alan Rolph
    Moore Stephens Llp
    1 Snow Hill
    EC1A 2DH London
    practitioner
    Moore Stephens Llp
    1 Snow Hill
    EC1A 2DH London
    Phillip Rodney Sykes
    1-3 Snow Hill
    EC1A 2DH London
    practitioner
    1-3 Snow Hill
    EC1A 2DH London

    Source de données

    • Companies House du Royaume-Uni
      Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers.
    • Licence: CC0