BROOKMANN HOME MANCHESTER 1877 LTD

BROOKMANN HOME MANCHESTER 1877 LTD

  • Vue d'ensemble
  • Résumé
  • Objet social
  • Adresse
  • Dénominations sociales précédentes
  • Comptes
  • Déclaration de confirmation
  • Bilan annuel
  • Dépôts
  • Dirigeants
  • Charges
  • Insolvabilité
  • Source de données
  • Vue d'ensemble

    Nom de la sociétéBROOKMANN HOME MANCHESTER 1877 LTD
    Statut de la sociétéActive
    Forme juridiqueSociété à responsabilité limitée
    Numéro de société 00011136
    JuridictionAngleterre/Pays de Galles
    Date de création
    Date de cessation d'activité

    Résumé

    A des PSCs super sécurisésNon
    A des chargesOui
    A un historique d'insolvabilitéOui
    Le siège social est contestéNon

    Quel est l'objet de BROOKMANN HOME MANCHESTER 1877 LTD ?

    • Commerce de gros de textiles (46410) / Commerce de gros et de détail ; réparation de véhicules automobiles et de motocycles
    • Vente au détail de textiles en magasin spécialisé (47510) / Commerce de gros et de détail ; réparation de véhicules automobiles et de motocycles

    Où se situe BROOKMANN HOME MANCHESTER 1877 LTD ?

    Adresse du siège social
    Kpmg Llp
    1 St Peter's Square
    M2 3AE Manchester
    Adresse du siège social non livrableNon

    Quels étaient les noms précédents de BROOKMANN HOME MANCHESTER 1877 LTD ?

    Dénominations sociales précédentes
    Nom de la sociétéDeJusqu'au
    DAWSON HOME GROUP LIMITED20 août 200820 août 2008
    DORMA GROUP LIMITED18 juil. 200218 juil. 2002
    C.V. HOME FURNISHINGS LIMITED19 janv. 187719 janv. 1877

    Quels sont les derniers comptes de BROOKMANN HOME MANCHESTER 1877 LTD ?

    En retardOui
    Prochains comptes
    Fin de la prochaine période comptable le31 mars 2013
    Date d'échéance des prochains comptes31 déc. 2013
    Derniers comptes
    Derniers comptes arrêtés au31 mars 2012

    Quel est le statut de la dernière déclaration de confirmation pour BROOKMANN HOME MANCHESTER 1877 LTD ?

    En retardOui
    Dernière déclaration de confirmation établie jusqu'au01 août 2016
    Date d'échéance de la prochaine déclaration de confirmation15 août 2016
    En retardOui

    Quel est le statut du dernier bilan annuel pour BROOKMANN HOME MANCHESTER 1877 LTD ?

    Bilan annuel
    Dernier bilan annuel
    En retardOui

    Quels sont les derniers dépôts pour BROOKMANN HOME MANCHESTER 1877 LTD ?

    Dépôts
    DateDescriptionDocumentType

    Restauration par ordonnance du tribunal

    3 pagesAC92

    Gazette finale dissoute à la suite d'une liquidation

    1 pagesGAZ2

    Rapport d'avancement de l'administrateur jusqu'à 01 mai 2015

    18 pages2.24B

    Avis de transition de l'administration à la dissolution le 22 mai 2015

    19 pages2.35B

    Rapport d'avancement de l'administrateur jusqu'à 22 mai 2015

    19 pages2.24B

    Changement d'adresse du siège social de Kpmg Llp 1 St Peter's Square Manchester M2 3AE à Kpmg Llp 1 St Peter's Square Manchester M2 3AE le 29 janv. 2015

    2 pagesAD01

    Changement d'adresse du siège social de Kpmg Llp St James's Square Manchester M2 6DS à Kpmg Llp 1 St Peter's Square Manchester M2 3AE le 29 janv. 2015

    2 pagesAD01

    Avis de prolongation de la période de l'administration

    21 pages2.31B

    Rapport d'avancement de l'administrateur jusqu'à 24 mai 2014

    22 pages2.24B

    Avis d'achèvement de l'accord volontaire

    18 pages1.4

    Avis d'approbation réputée des propositions

    1 pagesF2.18

    Déclaration de la proposition de l'administrateur

    35 pages2.17B

    Déclaration des affaires avec le formulaire 2.14B

    12 pages2.16B

    Cessation de la nomination de Myron Mann en tant que directeur

    4 pagesTM01

    Cessation de la nomination de Charles Johnson en tant que directeur

    2 pagesTM01

    Changement d'adresse du siège social de , C/O Uhy Hacker Young, St James Building 79 Oxford Street, Manchester, M1 6HT, United Kingdom le 04 déc. 2013

    2 pagesAD01

    Nomination d'un administrateur

    1 pages2.12B

    Comptes consolidés établis au 31 mars 2012

    21 pagesAA

    Avis au registre des sociétés de l'accord volontaire prenant effet

    14 pages1.1

    La procédure de radiation d'office a été suspendue

    1 pagesDISS16(SOAS)

    Premier avis au Bulletin officiel pour la radiation d'office

    1 pagesGAZ1

    Comptes annuels établis au 31 mars 2011

    21 pagesAA

    legacy

    3 pagesMG02

    legacy

    3 pagesMG02

    Déclaration annuelle jusqu'au 01 août 2012 avec liste complète des actionnaires

    4 pagesAR01
    Dépôts associés
    CatégorieDateDescriptionType
    capital15 août 2012

    État du capital au 15 août 2012

    • Capital: GBP 33,765,961
    SH01

    Qui sont les dirigeants de BROOKMANN HOME MANCHESTER 1877 LTD ?

    Dirigeants
    NomNommé leDate de démissionRôleAdresseIdentification de la sociétéPays de résidenceNationalitéDate de naissanceProfessionNuméro
    CLUEIT, William Kenneth
    Samron Copthurst Lane
    Whittle Le Woods
    PR6 8LR Chorley
    Lancashire
    Secrétaire
    Samron Copthurst Lane
    Whittle Le Woods
    PR6 8LR Chorley
    Lancashire
    British42784900001
    CRANNY, Dennis John
    6 Applewood
    Chadderton
    OL9 9UD Oldham
    Greater Manchester
    Secrétaire
    6 Applewood
    Chadderton
    OL9 9UD Oldham
    Greater Manchester
    British60295060001
    CRANSTON, John Charles
    8 Nottingham Road
    NG25 0LF Southwell
    Nottinghamshire
    Secrétaire
    8 Nottingham Road
    NG25 0LF Southwell
    Nottinghamshire
    British145205440001
    HUNT, Kieron Anthony
    Heights House Heights Lane
    Fence
    BB12 9JF Burnley
    Lancs
    Secrétaire
    Heights House Heights Lane
    Fence
    BB12 9JF Burnley
    Lancs
    British10836030001
    HUNT, Malcolm Keith
    c/o Uhy Hacker Young
    79 Oxford Street
    M1 6HT Manchester
    St James Building
    United Kingdom
    Secrétaire
    c/o Uhy Hacker Young
    79 Oxford Street
    M1 6HT Manchester
    St James Building
    United Kingdom
    British150209980001
    SHINN, Stephen Andrew
    1 Hampshire Close
    SK13 8SA Glossop
    Derbyshire
    Secrétaire
    1 Hampshire Close
    SK13 8SA Glossop
    Derbyshire
    British116832630001
    ALBINSON, Glenn
    104 Lacey Green
    SK9 4BN Wilmslow
    Cheshire
    Administrateur
    104 Lacey Green
    SK9 4BN Wilmslow
    Cheshire
    British104238290001
    ALBINSON, Glenn
    89 Heyes Lane
    SK9 7LN Alderley Edge
    Cheshire
    Administrateur
    89 Heyes Lane
    SK9 7LN Alderley Edge
    Cheshire
    British74341470002
    BAIN, Neville Clifford, Dr
    High Trees
    Cavendish Road St Georges Hill
    KT13 0JX Weybridge
    Surrey
    Administrateur
    High Trees
    Cavendish Road St Georges Hill
    KT13 0JX Weybridge
    Surrey
    United KingdomBritish48436050001
    BARTMESS, Andrew Dwayne
    Building Five Universal Square
    Devonshire Street
    M12 6JH Ardwick
    Manchester
    Administrateur
    Building Five Universal Square
    Devonshire Street
    M12 6JH Ardwick
    Manchester
    UsaAmerican118504930001
    BINCH, Richard Paul
    41 Coppice Avenue
    M33 4ND Sale
    Cheshire
    Administrateur
    41 Coppice Avenue
    M33 4ND Sale
    Cheshire
    British71313480001
    CARRIE, James Kemp
    KY13 8GL Kinross
    Lochleven Mills
    Scotland
    Administrateur
    KY13 8GL Kinross
    Lochleven Mills
    Scotland
    ScotlandBritish155134710001
    COOPER, David Gordon
    Building Five Universal Square
    Devonshire Street
    M12 6JH Ardwick
    Manchester
    Administrateur
    Building Five Universal Square
    Devonshire Street
    M12 6JH Ardwick
    Manchester
    United KingdomBritish73528470001
    CRANSTON, John Charles
    8 Nottingham Road
    NG25 0LF Southwell
    Nottinghamshire
    Administrateur
    8 Nottingham Road
    NG25 0LF Southwell
    Nottinghamshire
    EnglandBritish145205440001
    CRANSTON, John Charles
    8 Nottingham Road
    NG25 0LF Southwell
    Nottinghamshire
    Administrateur
    8 Nottingham Road
    NG25 0LF Southwell
    Nottinghamshire
    EnglandBritish145205440001
    DOWDS, Brian Francis
    Little Orchard Sanley Road
    Grindleton
    Clitheroe
    Lancs
    Administrateur
    Little Orchard Sanley Road
    Grindleton
    Clitheroe
    Lancs
    British10014630001
    FOLLEY, Keith
    Coniston 9 Noyna View
    BB8 7AU Colne
    Lancashire
    Administrateur
    Coniston 9 Noyna View
    BB8 7AU Colne
    Lancashire
    British2845500001
    HARTLEY, Michael George
    70 Ravensden Road,
    Renhold,
    MK41 0JY Bedford,
    Bedfordshire
    Administrateur
    70 Ravensden Road,
    Renhold,
    MK41 0JY Bedford,
    Bedfordshire
    United KingdomBritish56889040004
    HARTLEY, Michael George
    Summerfield House White Tor Road
    Starkholmes
    DE4 5JF Matlock
    Derbyshire
    Administrateur
    Summerfield House White Tor Road
    Starkholmes
    DE4 5JF Matlock
    Derbyshire
    British56889040003
    HARTLEY, Michael George
    Summerfield House White Tor Road
    Starkholmes
    DE4 5JF Matlock
    Derbyshire
    Administrateur
    Summerfield House White Tor Road
    Starkholmes
    DE4 5JF Matlock
    Derbyshire
    British56889040003
    HEALY, Christopher William
    50 Marville Road
    Fulham
    SW6 7BD London
    Administrateur
    50 Marville Road
    Fulham
    SW6 7BD London
    United KingdomBritish58484770001
    HOLDEN, William
    2 Belmont Road
    Hindley
    WN2 4JD Wigan
    Lancashire
    Administrateur
    2 Belmont Road
    Hindley
    WN2 4JD Wigan
    Lancashire
    British14591750001
    HUNT, Kieron Anthony
    Heights House Heights Lane
    Fence
    BB12 9JF Burnley
    Lancs
    Administrateur
    Heights House Heights Lane
    Fence
    BB12 9JF Burnley
    Lancs
    EnglandBritish10836030001
    JOHNSON, Charles Senter Brook
    c/o Uhy Hacker Young
    79 Oxford Street
    M1 6HT Manchester
    St James Building
    England
    Administrateur
    c/o Uhy Hacker Young
    79 Oxford Street
    M1 6HT Manchester
    St James Building
    England
    Conneticut UsaAmerican168544270001
    JOHNSON, Charles Senter Brook
    c/o Uhy Hacker Young
    79 Oxford Street
    M1 6HT Manchester
    St James Building
    United Kingdom
    Administrateur
    c/o Uhy Hacker Young
    79 Oxford Street
    M1 6HT Manchester
    St James Building
    United Kingdom
    United StatesAmerican160235650001
    JOHNSON, David Alan
    1 Paddock Chase
    SK12 1XR Poynton
    Cheshire
    Administrateur
    1 Paddock Chase
    SK12 1XR Poynton
    Cheshire
    British51671920001
    LEA, Jonathan David
    Little Manor
    Fulmer Road
    SL9 7EF Gerrards Cross
    Buckinghamshire
    Administrateur
    Little Manor
    Fulmer Road
    SL9 7EF Gerrards Cross
    Buckinghamshire
    EnglandBritish67105270002
    LEWIS, Gareth Howell
    23 The Croft
    Euxton
    PR7 6LH Chorley
    Lancashire
    Administrateur
    23 The Croft
    Euxton
    PR7 6LH Chorley
    Lancashire
    British74425250001
    LUCAS, Bernard
    2 Bledlow Close
    Eccles
    M30 9LP Manchester
    Lancashire
    Administrateur
    2 Bledlow Close
    Eccles
    M30 9LP Manchester
    Lancashire
    British14591740001
    MANN, Myron Tennyson
    Universal Square
    Devonshire Street Ardwick
    M12 6JH Manchester
    Building Five
    United Kingdom
    Administrateur
    Universal Square
    Devonshire Street Ardwick
    M12 6JH Manchester
    Building Five
    United Kingdom
    United KingdomAustralian160235690002
    NIXON, Blake Andrew
    103 Arthur Road
    SW19 7DR Wimbledon
    London
    Administrateur
    103 Arthur Road
    SW19 7DR Wimbledon
    London
    EnglandBritish5872150007
    OST, Michael Stuart
    Pinelawns Chanctonbury Drive
    SL5 9PT Sunningdale
    Berkshire
    Administrateur
    Pinelawns Chanctonbury Drive
    SL5 9PT Sunningdale
    Berkshire
    British16322990001
    RUSSELL, Stephen Barrie
    9 The Close
    Upton
    NG23 5SS Newark
    Nottinghamshire
    Administrateur
    9 The Close
    Upton
    NG23 5SS Newark
    Nottinghamshire
    EnglandBritish4830590001
    SWAIN, Glynn David
    9 Esk Avenue
    Ramsbottom
    BL0 0JA Bury
    Lancashire
    Administrateur
    9 Esk Avenue
    Ramsbottom
    BL0 0JA Bury
    Lancashire
    British14591770001
    SYKES, Sydney Albert
    Breeze Cottage
    6 Cliffe Road
    SK13 8NY Glossop
    Derbyshire
    Administrateur
    Breeze Cottage
    6 Cliffe Road
    SK13 8NY Glossop
    Derbyshire
    British14591780001

    BROOKMANN HOME MANCHESTER 1877 LTD a-t-elle des charges ?

    Charges
    ClassificationDatesStatutDétails
    Debenture
    Créé le 01 août 2012
    Livré le 07 août 2012
    En cours
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill uncalled capital buildings fixtures plant and machinery see image for full details.
    Personnes ayant droit
    • Aldermore Invoice Finance, a Division of Aldermore Bank PLC
    Transactions
    • 07 août 2012Enregistrement d'une charge (MG01)
    Full form debenture
    Créé le 17 mai 2011
    Livré le 24 mai 2011
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    Personnes ayant droit
    • Leumi Abl Limited ("Leumi")
    Transactions
    • 24 mai 2011Enregistrement d'une charge (MG01)
    • 29 août 2012Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (MG02)
    Mortgage debenture
    Créé le 17 mai 2011
    Livré le 21 mai 2011
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, fixtures, plant & machinery see image for full details.
    Personnes ayant droit
    • Dawson International Public Limited
    Transactions
    • 21 mai 2011Enregistrement d'une charge (MG01)
    • 29 août 2012Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (MG02)
    Composite all assets guarantee and indemnity and debenture
    Créé le 01 mars 2011
    Livré le 05 mars 2011
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company and the obligors to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    Personnes ayant droit
    • Ge Commercial Finance Limited
    Transactions
    • 05 mars 2011Enregistrement d'une charge (MG01)
    • 28 juil. 2012Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (MG02)
    A composite guarantee and floating charge
    Créé le 14 févr. 2005
    Livré le 26 févr. 2005
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the issuer and from the company to the chargee and all monies due or to become due from the scottish group companies on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    A floating charge over all assets being the whole of the property (including uncalled capital) which is or may be from time to time comprised in the property and undertaking. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • The Law Debenture Trust Corporation P.L.C.
    Transactions
    • 26 févr. 2005Enregistrement d'une charge (395)
    • 20 janv. 2006Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Composite guarantee and debenture
    Créé le 11 févr. 2005
    Livré le 18 févr. 2005
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Gmac Commercial Finance PLC
    Transactions
    • 18 févr. 2005Enregistrement d'une charge (395)
    • 13 mai 2011Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (MG02)
    An assignment of credit and other insurance policies
    Créé le 11 févr. 2005
    Livré le 18 févr. 2005
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    The policy and the whole right title benefit and interest in the policy and all sums arising thereunder. The policy means the credit and other insurance detailed as insurer: euler hermes UK PLC policy no. 185409101, zurich insurance policy no. LE453675, KV453611, GL453716. For details are further policies charged please refer to form 395. see the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Gmac Commercial Finance PLC
    Transactions
    • 18 févr. 2005Enregistrement d'une charge (395)
    • 13 mai 2011Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (MG02)
    Charge of deposit
    Créé le 11 févr. 2005
    Livré le 16 févr. 2005
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    All deposits now and in the future credited to account designation 63106876 with the bank and any deposit or account of any other currency description or designation which derives in whole or in part from such deposits or account.
    Personnes ayant droit
    • National Westminster Bank PLC
    Transactions
    • 16 févr. 2005Enregistrement d'une charge (395)
    • 13 mai 2011Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (MG02)
    Trust deed
    Créé le 28 mai 1971
    Livré le 04 juin 1974
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    £12,323,906 debenture stock of carrington viyella LTD
    Brèves mentions
    Floating charge on. Undertaking and all property and assets present and future including uncalled capital.
    Personnes ayant droit
    • Commercial Union Assurance Co. LTD
    Transactions
    • 04 juin 1974Enregistrement d'une charge
    • 27 sept. 1995Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)

    BROOKMANN HOME MANCHESTER 1877 LTD a-t-elle des procédures d'insolvabilité ?

    Numéro de dossierDatesTypePraticiensAutre
    1
    DateType
    28 mai 2013Date of meeting to approve CVA
    25 nov. 2013Date of completion or termination of CVA
    Corporate voluntary arrangement (CVA)
    NomRôleAdresseNommé leCessé le
    Brian Green
    Kpmg Llp
    St James' Square
    M2 6DS Manchester
    practitioner
    Kpmg Llp
    St James' Square
    M2 6DS Manchester
    Paul Andrew Flint
    Kpmg
    St James' Square
    M2 6DS Manchester
    practitioner
    Kpmg
    St James' Square
    M2 6DS Manchester
    2
    DateType
    22 mai 2015Administration ended
    25 nov. 2013Administration started
    In administration
    NomRôleAdresseNommé leCessé le
    Brian Green
    Kpmg Llp
    St James' Square
    M2 6DS Manchester
    practitioner
    Kpmg Llp
    St James' Square
    M2 6DS Manchester
    Paul Andrew Flint
    Kpmg
    St James' Square
    M2 6DS Manchester
    practitioner
    Kpmg
    St James' Square
    M2 6DS Manchester

    Source de données

    • Companies House du Royaume-Uni
      Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers.
    • Licence: CC0