BOURNE END PROPERTIES

  • Vue d'ensemble
  • Résumé
  • Objet social
  • Adresse
  • Dénominations sociales précédentes
  • Comptes
  • Dépôts
  • Dirigeants
  • Charges
  • Insolvabilité
  • Source de données
  • Vue d'ensemble

    Nom de la sociétéBOURNE END PROPERTIES
    Statut de la sociétéDissoute
    Forme juridiqueSociété privée à responsabilité illimitée
    Numéro de société 00034472
    JuridictionAngleterre/Pays de Galles
    Date de création
    Date de cessation d'activité

    Résumé

    A des PSCs super sécurisésNon
    A des chargesOui
    A un historique d'insolvabilitéOui
    Le siège social est contestéNon

    Quel est l'objet de BOURNE END PROPERTIES ?

    • (7020) /

    Où se situe BOURNE END PROPERTIES ?

    Adresse du siège social
    32 Cornhill
    EC3V 3BT London
    Adresse du siège social non livrableNon

    Quels étaient les noms précédents de BOURNE END PROPERTIES ?

    Dénominations sociales précédentes
    Nom de la sociétéDeJusqu'au
    JACKSONS BOURNE END PLC29 juil. 189129 juil. 1891

    Quels sont les derniers comptes de BOURNE END PROPERTIES ?

    Derniers comptes
    Derniers comptes arrêtés au31 déc. 2008

    Quels sont les derniers dépôts pour BOURNE END PROPERTIES ?

    Dépôts
    DateDescriptionDocumentType

    Gazette finale dissoute à la suite d'une liquidation

    1 pagesGAZ2

    Retour de la réunion finale dans une liquidation volontaire des membres

    3 pages4.71

    Changement d'adresse du siège social de 11th Floor East 33 Cavendish Square London W1G 0PW le 18 févr. 2010

    2 pagesAD01

    Nomination d'un liquidateur volontaire

    1 pages600

    Déclaration de solvabilité

    3 pages4.70

    Résolutions

    Resolutions
    1 pagesRESOLUTIONS
    Résolutions
    CatégorieDateDescriptionType
    liquidation

    Résolution spéciale pour la liquidation au 10 févr. 2010

    LRESSP

    legacy

    3 pagesMG02

    legacy

    3 pagesMG02

    legacy

    3 pagesMG02

    legacy

    3 pagesMG02

    Comptes consolidés établis au 31 déc. 2008

    14 pagesAA

    legacy

    1 pages288b

    legacy

    1 pages288a

    legacy

    5 pages363a

    legacy

    1 pages288c

    Comptes consolidés établis au 31 déc. 2007

    16 pagesAA

    legacy

    7 pages363s

    Comptes consolidés établis au 31 déc. 2006

    16 pagesAA

    legacy

    7 pages363s

    Comptes consolidés établis au 31 déc. 2005

    15 pagesAA

    legacy

    7 pages363s

    legacy

    pages363(288)

    legacy

    1 pages122

    legacy

    1 pages288b

    legacy

    1 pages288b

    Qui sont les dirigeants de BOURNE END PROPERTIES ?

    Dirigeants
    NomNommé leDate de démissionRôleAdresseIdentification de la sociétéPays de résidenceNationalitéDate de naissanceProfessionNuméro
    CHRISTOFI, Christakis, Mr.
    10 Litchfield Way
    NW11 6NJ London
    Secrétaire
    10 Litchfield Way
    NW11 6NJ London
    British67125820002
    KASCH, Peter Carwile
    Filston Oast
    Filston Lane
    TN14 5JU Shoreham
    Kent
    Administrateur
    Filston Oast
    Filston Lane
    TN14 5JU Shoreham
    Kent
    United KingdomBritishDirector61386600003
    LEE, Charles Mackenzie
    Ongar Hill Cottage
    Magpie Lane Coleshill
    HP7 0LU Amersham
    Buckinghamshire
    Administrateur
    Ongar Hill Cottage
    Magpie Lane Coleshill
    HP7 0LU Amersham
    Buckinghamshire
    EnglandBritishChartered Surveyor88355580001
    SCOTT, Keith
    Clarendon Road
    HP16 0PL Prestwood
    Michaelmas Farm
    Buckinghamshire
    Secrétaire
    Clarendon Road
    HP16 0PL Prestwood
    Michaelmas Farm
    Buckinghamshire
    BritishAccountant141163370001
    SMITH, Ivor
    1 Bridge Lane
    NW11 0EA London
    Secrétaire
    1 Bridge Lane
    NW11 0EA London
    British21120940001
    WARD, Geoffrey Colin Neville
    131 Bishopsteignton
    Shoeburyness
    SS3 8BQ Southend On Sea
    Essex
    Secrétaire
    131 Bishopsteignton
    Shoeburyness
    SS3 8BQ Southend On Sea
    Essex
    BritishCompany Secretary67300170001
    BAIN, Duncan Whiteford Taylor
    St Huberts Hill Marley Common
    GU27 3PT Haslemere
    Surrey
    Administrateur
    St Huberts Hill Marley Common
    GU27 3PT Haslemere
    Surrey
    BritishChartered Accountant28099480001
    BENSON, Julian Riou
    The Old Rectory
    Abbotts Ann
    SP11 7NR Andover
    Hampshire
    Administrateur
    The Old Rectory
    Abbotts Ann
    SP11 7NR Andover
    Hampshire
    United KingdomBritishDirector9442490001
    GREEN, Matthew Hollister
    9015 Nw Bartholomew Drive
    Portland
    Oregon 97229
    Usa
    Administrateur
    9015 Nw Bartholomew Drive
    Portland
    Oregon 97229
    Usa
    AmericanFinance74596640001
    HOWARD, Robin Ivan
    Broadacre House
    Coningsby Lane, Fifield
    SL6 2PF Maidenhead
    Berkshire
    Administrateur
    Broadacre House
    Coningsby Lane, Fifield
    SL6 2PF Maidenhead
    Berkshire
    United KingdomBritish,Director2570730002
    HUGHES, Donald James, Mr.
    19 Church Avenue
    HA4 7HU Ruislip
    Middlesex
    Administrateur
    19 Church Avenue
    HA4 7HU Ruislip
    Middlesex
    EnglandBritishChartered Accountants2591700001
    KLIMT, Peter Richard
    Redington Road
    NW3 7RS London
    54
    Administrateur
    Redington Road
    NW3 7RS London
    54
    United KingdomBritishSolicitor23621230001
    NEWMARCH, Michael George
    27 Paultons Square
    SW3 5DS London
    Administrateur
    27 Paultons Square
    SW3 5DS London
    BritishCompany Director1109560002
    NOE, Leopold
    5 Wigmore Street
    W1U 1PB London
    Administrateur
    5 Wigmore Street
    W1U 1PB London
    EnglandBritishManaging Director64965010001
    ROBERTS, David Ian
    Old Brookside House
    Winkfield Road
    SL5 7LX Ascot
    Berkshire
    Administrateur
    Old Brookside House
    Winkfield Road
    SL5 7LX Ascot
    Berkshire
    BritishCompany Director38276960001
    SMITH, Ivor
    1 Bridge Lane
    NW11 0EA London
    Administrateur
    1 Bridge Lane
    NW11 0EA London
    BritishFinance Director21120940001
    TRIBE, Nicholas John Grove
    Yew Tree Cottage
    Sherbourne Street, Edwardstone
    CO10 5PD Sudbury
    Suffolk
    Administrateur
    Yew Tree Cottage
    Sherbourne Street, Edwardstone
    CO10 5PD Sudbury
    Suffolk
    United KingdomBritishDirector141163390001
    TRIBE, Nicholas John Grove
    Yew Tree Cottage
    Sherbourne Street, Edwardstone
    CO10 5PD Sudbury
    Suffolk
    Administrateur
    Yew Tree Cottage
    Sherbourne Street, Edwardstone
    CO10 5PD Sudbury
    Suffolk
    United KingdomBritishDirector141163390001

    BOURNE END PROPERTIES a-t-elle des charges ?

    Charges
    ClassificationDatesStatutDétails
    Composite guarantee and debenture
    Créé le 14 juin 2001
    Livré le 05 mars 2002
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All indebtedness,liabilities and obligations whatsoever due or to become due from any of the borrowers or any charging company to the lenders in any currency under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Nationwide Building Society
    Transactions
    • 05 mars 2002Enregistrement d'une charge (395)
    • 02 déc. 2009Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (MG02)
    Deed of accession and variation to the debenture made between (1) the new charging companies (2) the initial charging companies (3) nationwide building society
    Créé le 14 juin 2001
    Livré le 21 juin 2001
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All present and future indebtedness obligations and liabilities due from any of the borrowers and/or any charging company to the chargee under any finance document on any account whatsoever (all terms defined therein)
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Nationwide Building Society (The "Security Trustee")
    Transactions
    • 21 juin 2001Enregistrement d'une charge (395)
    • 08 mai 2002Déclaration que tout ou partie de la propriété d'une charge flottante a été libérée (403b)
    • 02 déc. 2009Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (MG02)
    Mortgage of shares
    Créé le 26 mars 1998
    Livré le 10 avr. 1998
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All present and future obligations and liabilities whether actual or contingent and whether owed jointly or severally or in any other capacity whatsoever of each obligor to the chargee under each finance document
    Brèves mentions
    One ordinary share of one pound each in the share capital of bourne end (fleet) limited (the borrower) and all dividends on all or any of the shares and all stocks shares securities rights moneys or property accruing or offered. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Wurttembergeische Hypothekenbank Aktiengesellschaft
    Transactions
    • 10 avr. 1998Enregistrement d'une charge (395)
    • 14 nov. 2001Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Legal charge and floating charge
    Créé le 21 déc. 1993
    Livré le 07 janv. 1994
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    £565,000 and all other monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    All f/h land k/a 95 high street strood kent and 100 bridge street warrington cheshire t/n's K485189 and CH269069 and all assets property and undertaking including all the goodwill and uncalled capital for the time being.
    Personnes ayant droit
    • Allied Dunbar Assurance PLC
    Transactions
    • 07 janv. 1994Enregistrement d'une charge (395)
    • 07 oct. 1999Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Debenture
    Créé le 21 déc. 1993
    Livré le 30 déc. 1993
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the hongkong and shanghai banking corporation limited as trustee for and on behalf of the beneficiaries as defined under the terms of this debenture and any agreement defined therein
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limiteds as Definedas Trustee for and on Behalf of the Beneficiarie
    Transactions
    • 30 déc. 1993Enregistrement d'une charge (395)
    • 07 oct. 1999Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Memorandum of security
    Créé le 03 juin 1992
    Livré le 10 juin 1992
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    All amounts which are now or which may from time to time hereafter be standing to the credit of the company's rental deposit account (see form 395 for full details).
    Personnes ayant droit
    • Svenska Handelsbanken
    Transactions
    • 10 juin 1992Enregistrement d'une charge (395)
    • 07 oct. 1999Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Floating charge
    Créé le 03 juin 1992
    Livré le 10 juin 1992
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Undertaking and all property and assets.
    Personnes ayant droit
    • Svenska Handelsbanken
    Transactions
    • 10 juin 1992Enregistrement d'une charge (395)
    • 07 oct. 1999Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Legal charge
    Créé le 03 juin 1992
    Livré le 05 juin 1992
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    L/H property k/a unit C8 and ground floor unit C9A select house, progress business centre, whittle parkway, bath road, slough (see form 395 for full details). Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Personnes ayant droit
    • American Express Bank Limited
    Transactions
    • 05 juin 1992Enregistrement d'une charge (395)
    • 07 oct. 1999Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Charge
    Créé le 04 sept. 1991
    Livré le 13 sept. 1991
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    72 furlong road,bourne end,buckinghamshire.
    Personnes ayant droit
    • Midland Bank PLC
    Transactions
    • 13 sept. 1991Enregistrement d'une charge
    • 15 juil. 1995Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Legal charge
    Créé le 04 sept. 1991
    Livré le 13 sept. 1991
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    F/H propety k/a units 1-5 jackson industrial park and wessex road bourne end buckinghamshire.
    Personnes ayant droit
    • Midland Bank PLC
    Transactions
    • 13 sept. 1991Enregistrement d'une charge
    • 15 juil. 1995Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Legal charge
    Créé le 04 sept. 1991
    Livré le 13 sept. 1991
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    L/H property k/a units C8 and 9 progress business centre whittle parkway bath road slough t/nos bk 265444 and bk 265445.
    Personnes ayant droit
    • Midland Bank PLC
    Transactions
    • 13 sept. 1991Enregistrement d'une charge
    • 15 juil. 1995Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Legal mortgage
    Créé le 29 mars 1990
    Livré le 06 avr. 1990
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    F/H property being land at wessex road and furlong road, high wycombe. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Personnes ayant droit
    • Svenska Handelsbanken
    Transactions
    • 06 avr. 1990Enregistrement d'une charge
    • 14 nov. 2001Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    • 02 déc. 2009Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (MG02)
    Legal charge
    Créé le 08 févr. 1990
    Livré le 13 févr. 1990
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    F/H property k/a syston mill, syston, leicestershire.
    Personnes ayant droit
    • Midland Bank PLC
    Transactions
    • 13 févr. 1990Enregistrement d'une charge
    • 14 avr. 1994Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Legal charge
    Créé le 06 févr. 1990
    Livré le 09 févr. 1990
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    F/H property k/a meadowbank estate, furlong road, bourne end, buckinghamshire (formerly known as 74 furlong road).
    Personnes ayant droit
    • Midland Bank PLC
    Transactions
    • 09 févr. 1990Enregistrement d'une charge
    • 14 avr. 1994Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Legal charge
    Créé le 17 juil. 1989
    Livré le 19 juil. 1989
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    L/H premises k/a: units C8 & C9 progress business centre whittle parkway bath road slough berkshire with all buildings fixtures (including trade fixtures) and fixed plant and machinery. T/nos. Bk 265444 & bk 265445. floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Personnes ayant droit
    • American Express Bank LTD
    Transactions
    • 19 juil. 1989Enregistrement d'une charge
    • 07 oct. 1999Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Legal charge
    Créé le 17 juil. 1989
    Livré le 19 juil. 1989
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    F/H property k/a: units 1-5 jacksons industrial park wessex and bourne end buckinghamshire with all buildings, fixtures (including trade fixtures) and fixed plant and machinery.. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Personnes ayant droit
    • American Express Bank Limited
    Transactions
    • 19 juil. 1989Enregistrement d'une charge
    • 07 oct. 1999Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Legal charge
    Créé le 17 juil. 1989
    Livré le 19 juil. 1989
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    F/H property k/a: 72 furlong road bourne end buckinghamshire with all buildings fixtures (including trade fixtures) and fixed plant and machinery.. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Personnes ayant droit
    • American Express Bank Limited
    Transactions
    • 19 juil. 1989Enregistrement d'une charge
    • 07 oct. 1999Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Legal mortgage
    Créé le 04 juil. 1989
    Livré le 06 juil. 1989
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    F/H land & buildings situate and k/a block & octagon centre high wycombe county of buckingham t/n bm 114958.
    Personnes ayant droit
    • Svenska Handelsbanken
    Transactions
    • 06 juil. 1989Enregistrement d'une charge
    • 14 nov. 2001Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    • 02 déc. 2009Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (MG02)
    Legal charge
    Créé le 07 févr. 1989
    Livré le 23 févr. 1989
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    F/H land situate at the junction of furlong road and corres end road, bourne endbuckinghamshire fixed charge over all movable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Personnes ayant droit
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transactions
    • 23 févr. 1989Enregistrement d'une charge
    • 28 janv. 1992Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Legal charge
    Créé le 07 févr. 1989
    Livré le 23 févr. 1989
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    F/H land situate and k/a jacksons industrial park, wessex road, bourne end, buckinghamshire fixed charge over all movable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Personnes ayant droit
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transactions
    • 23 févr. 1989Enregistrement d'une charge
    • 28 janv. 1992Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Legal charge
    Créé le 07 févr. 1989
    Livré le 23 févr. 1989
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    F/H land k/a furlong road bourne end bucks charge over all plant machinery implements utensils furniture and equipment fixtures and fittings.
    Personnes ayant droit
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transactions
    • 23 févr. 1989Enregistrement d'une charge
    Deed
    Créé le 01 juin 1982
    Livré le 05 juin 1982
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    £550,000
    Brèves mentions
    All that piece or parcel of land off cones end road bourne end bucks having an area of approx 6.7 acres.
    Transactions
    • 05 juin 1982Enregistrement d'une charge
    Legal charge
    Créé le 26 févr. 1981
    Livré le 16 mars 1981
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    £200 and all other monies due or to be come due from the company to the chargee not exceeding £600,000
    Brèves mentions
    1)F/h property main office buildings, laboratories, offices, workshop & car park situate in furlong rd bourne end bucks 2) land & buildings to be erected thereon situate at wesseex rd bourne end bucks.
    Personnes ayant droit
    • Lloyds Bank PLC
    Transactions
    • 16 mars 1981Enregistrement d'une charge
    Legal charge
    Créé le 22 mai 1980
    Livré le 22 mai 1980
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    For securing £21,137 and further advances from the company to the chargee not exceeding £250,000
    Brèves mentions
    Freehold property formerly main office buildings, laboratories offices, workshop and car park situate in furlong road, bourne end bucks.
    Personnes ayant droit
    • Lloyds Bank PLC
    Transactions
    • 22 mai 1980Enregistrement d'une charge

    BOURNE END PROPERTIES a-t-elle des procédures d'insolvabilité ?

    Numéro de dossierDatesTypePraticiensAutre
    1
    DateType
    10 févr. 2010Commencement of winding up
    05 avr. 2011Dissolved on
    Members voluntary liquidation
    NomRôleAdresseNommé leCessé le
    Neil John Mather
    Begbies Traynor
    32 Cornhill
    EC3V 3BT London
    practitioner
    Begbies Traynor
    32 Cornhill
    EC3V 3BT London
    Gary Paul Shankland
    Begbies Traynor (Central) Llp 32 Cornhill
    EC3V 3BT London
    practitioner
    Begbies Traynor (Central) Llp 32 Cornhill
    EC3V 3BT London

    Source de données

    • Companies House du Royaume-Uni
      Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers.
    • Licence: CC0