WALSALL BUSINESS SUPPORT LIMITED
Vue d'ensemble
Nom de la société | WALSALL BUSINESS SUPPORT LIMITED |
---|---|
Statut de la société | Active |
Forme juridique | Société privée à responsabilité limitée par garantie sans capital social |
Numéro de société | 00036148 |
Juridiction | Angleterre/Pays de Galles |
Date de création |
Résumé
A des PSCs super sécurisés | Non |
---|---|
A des charges | Non |
A un historique d'insolvabilité | Non |
Le siège social est contesté | Non |
Où se situe WALSALL BUSINESS SUPPORT LIMITED ?
Adresse du siège social | C/O Ptp Training Essex Terrace Intown WS1 1SQ Walsall England |
---|---|
Adresse du siège social non livrable | Non |
Quels sont les derniers comptes de WALSALL BUSINESS SUPPORT LIMITED ?
En retard | Non |
---|---|
Prochains comptes | |
Fin de la prochaine période comptable le | 31 juil. 2025 |
Date d'échéance des prochains comptes | 30 avr. 2026 |
Derniers comptes | |
Derniers comptes arrêtés au | 31 juil. 2024 |
Quel est le statut de la dernière déclaration de confirmation pour WALSALL BUSINESS SUPPORT LIMITED ?
Dernière déclaration de confirmation établie jusqu'au | 11 mai 2026 |
---|---|
Date d'échéance de la prochaine déclaration de confirmation | 25 mai 2026 |
Dernière déclaration de confirmation | |
Prochaine déclaration de confirmation établie jusqu'au | 11 mai 2025 |
En retard | Non |
Quels sont les derniers dépôts pour WALSALL BUSINESS SUPPORT LIMITED ?
Date | Description | Document | Type | |
---|---|---|---|---|
Déclaration de confirmation établie le 11 mai 2025 sans mise à jour | 3 pages | CS01 | ||
Modification des coordonnées de l'administrateur Mr Robert Colbourne le 02 juin 2025 | 2 pages | CH01 | ||
Modification des coordonnées de l'administrateur Mr John Murray le 02 juin 2025 | 2 pages | CH01 | ||
Modification des coordonnées de l'administrateur Mr John Nicholas Punch le 02 juin 2025 | 2 pages | CH01 | ||
Modification des coordonnées de l'administrateur Adam Charles Frederick Howell le 02 juin 2025 | 2 pages | CH01 | ||
Modification des coordonnées du secrétaire Mr John Derek Baker le 02 juin 2025 | 1 pages | CH03 | ||
Modification des coordonnées de l'administrateur Ms Angela Anne Henderson le 02 juin 2025 | 2 pages | CH01 | ||
Changement d'adresse du siège social de 3rd Floor, International House 20, Hatherton Street Walsall WS4 2LA England à C/O Ptp Training Essex Terrace Intown Walsall WS1 1SQ le 02 juin 2025 | 1 pages | AD01 | ||
Nomination de Ms Angela Anne Henderson en tant qu'administrateur le 18 mars 2025 | 2 pages | AP01 | ||
Modification des coordonnées de l'administrateur Mr Robert Colbourne le 26 sept. 2022 | 2 pages | CH01 | ||
Modification des coordonnées de l'administrateur Adam Charles Frederick Howell le 26 sept. 2022 | 2 pages | CH01 | ||
Modification des coordonnées du secrétaire Mr John Derek Baker le 26 sept. 2022 | 1 pages | CH03 | ||
Modification des coordonnées de l'administrateur Mr John Murray le 26 sept. 2022 | 2 pages | CH01 | ||
Modification des coordonnées de l'administrateur Mr John Nicholas Punch le 26 sept. 2022 | 2 pages | CH01 | ||
Comptes d'exonération totale établis au 31 juil. 2024 | 10 pages | AA | ||
Déclaration de confirmation établie le 11 mai 2024 sans mise à jour | 3 pages | CS01 | ||
Comptes d'exonération totale établis au 31 juil. 2023 | 11 pages | AA | ||
Déclaration de confirmation établie le 11 mai 2023 sans mise à jour | 3 pages | CS01 | ||
Comptes d'exonération totale établis au 31 juil. 2022 | 11 pages | AA | ||
Changement d'adresse du siège social de 16 Broadway North Walsall West Midlands WS1 2AN à 3rd Floor, International House 20, Hatherton Street Walsall WS4 2LA le 26 sept. 2022 | 1 pages | AD01 | ||
Déclaration de confirmation établie le 11 mai 2022 avec mises à jour | 3 pages | CS01 | ||
Comptes pour une petite entreprise établis au 31 juil. 2021 | 10 pages | AA | ||
Nomination de Mr Robert Colbourne en tant qu'administrateur le 29 juin 2021 | 2 pages | AP01 | ||
Déclaration de confirmation établie le 11 mai 2021 sans mise à jour | 3 pages | CS01 | ||
Statuts | 12 pages | MA | ||
Qui sont les dirigeants de WALSALL BUSINESS SUPPORT LIMITED ?
Nom | Nommé le | Date de démission | Rôle | Adresse | Identification de la société | Pays de résidence | Nationalité | Date de naissance | Profession | Numéro |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BAKER, John Derek | Secrétaire | Essex Terrace Intown WS1 1SQ Walsall C/O Ptp Training England | British | 9908500001 | ||||||
COLBOURNE, Robert | Administrateur | Essex Terrace Intown WS1 1SQ Walsall C/O Ptp Training West Midlands England | England | British | Managing Director | 108533510001 | ||||
HENDERSON, Angela Anne | Administrateur | Essex Terrace Intown WS1 1SQ Walsall C/O Ptp Training United Kingdom | United Kingdom | British | Director | 93946770001 | ||||
HOWELL, Adam Charles Frederick | Administrateur | Essex Terrace Intown WS1 1SQ Walsall C/O Ptp Training United Kingdom | England | British | Engineering | 244715540001 | ||||
MURRAY, John | Administrateur | Essex Terrace Intown WS1 1SQ Walsall C/O Ptp Training West Midlands United Kingdom | United Kingdom | British | Electrical Engineer | 54047350001 | ||||
PUNCH, John Nicholas | Administrateur | Essex Terrace Intown WS1 1SQ Walsall C/O Ptp Training West Midlands United Kingdom | United Kingdom | British | Chartered Quantity Surveyor | 34266410001 | ||||
COTTERILL, Alan | Secrétaire | 2 Fox Walk Walsall Wood WS9 9EP Walsall West Midlands | British | 27747060002 | ||||||
FROST, David Stuart | Secrétaire | 5 Norfolk Gardens B75 6SS Sutton Coldfield West Midlands | British | Chief Executive | 39569190001 | |||||
FROST, David Stuart | Secrétaire | 5 Norfolk Gardens B75 6SS Sutton Coldfield West Midlands | British | Chief Executive | 39569190001 | |||||
GRUBB, David John | Secrétaire | 101 Cannock Road WS11 2DA Cannock Staffordshire | British | Accountant | 82226730001 | |||||
HUTCHINSON, Terrence David | Secrétaire | 58 Bentley Drive WS2 8RX Walsall West Midlands | British | Accountant | 53050580001 | |||||
JOBSON, Timothy Akers | Secrétaire | 6 Redhouse Road Tettenhall WV6 8ST Wolverhampton West Midlands | British | 34676900001 | ||||||
TENNANT, Nicholas John | Secrétaire | 34 Alma Hill Kimberley NG16 2JF Nottingham | British | Chartered Accountant | 55722200001 | |||||
ACKERS, James, Sir | Administrateur | 39 Newstead The Alders B79 7UU Tamworth Staffordshire | British | Company Director | 39108400001 | |||||
ADCOCK, Mark Hedley | Administrateur | Haycroft The Gardens B79 9DD Elford Tamworth | England | British | Solicitor | 19857510001 | ||||
ANTILL, James | Administrateur | 5 Royston Chase B74 3DS Sutton Coldfield West Midlands | British | Company Director | 8592770001 | |||||
ANTILL, Rosemary Jane | Administrateur | 16 Clearwater Place KT6 4ET Surbiton Surrey | British | Marketing Director | 33478840002 | |||||
ARNOLD, Susan Pauline | Administrateur | Haselour House Haselour Lane Harlaston B79 9JT Tamworth Staffordshire | England | British | Publisher | 75528320001 | ||||
BAKER, John Derek | Administrateur | Broadway North WS1 2AN Walsall 16 West Midlands United Kingdom | England | British | Chartered Accountant | 9908500001 | ||||
BLACK, Susan Jennifer | Administrateur | 24 Main Street Barton Under Needwood DE13 8AA Burton On Trent Staffordshire | British | Director | 43467110001 | |||||
BOWKER, Arthur | Administrateur | Sandon St Pauls Road WS10 Wednesbury West Midlands | British | Retired | 28847360001 | |||||
BRADFORD, Philip Stuart | Administrateur | Peacock House Farm Lichfield Road WS7 0HX Burntwood Staffordshire | England | British | Director | 65565720001 | ||||
BROWN, Michael David | Administrateur | The Coppice Western Avenue B62 8QH Halesowen West Midlands | England | British | Engineer | 3068790001 | ||||
BROWN, Michael David | Administrateur | The Coppice Western Avenue B62 8QH Halesowen West Midlands | England | British | Company Director | 3068790001 | ||||
BURNS-BEECH, Andrea Susan | Administrateur | 50 Liskeard Road WS5 3ES Walsall West Midlands | British | Solicitor | 28847190003 | |||||
BUTLER, Christopher James | Administrateur | The Pines Streetly Wood Streetly B74 3DQ Sutton Coldfield West Midlands | British | Manufacturer | 8273230001 | |||||
CARVER, David Lewis | Administrateur | Meredale House Meretown TF10 8BX Newport Shropshire | England | British | Managing Director | 15922050001 | ||||
CHALLENDER, Barry James | Administrateur | 97 Scalpcliffe Road DE15 9AB Burton On Trent Staffordshire | British | Solicitor | 31162880002 | |||||
CHATTAWAY, Robert Walter | Administrateur | The Bungalow Church Lane Seckington B79 0LD Tamworth Staffordshire | British | Telecoms | 38739310002 | |||||
COLLINS, Michael | Administrateur | 6 Skip Lane WS5 3LL Walsall West Midlands | England | British | Company Director | 3509120001 | ||||
COTTERILL, Alan | Administrateur | 2 Fox Walk Walsall Wood WS9 9EP Walsall West Midlands | Great Britain | British | Accountant | 27747060002 | ||||
CRANE, Roger Charles | Administrateur | 208 Ashby Road DE15 0LB Burton On Trent Staffordshire | British | Architect | 51300410001 | |||||
CRUNDWELL, Robert Frank | Administrateur | 40 Bennett Road B74 4TH Sutton Coldfield West Midlands | England | British | Company Director | 16526020001 | ||||
DAIN, John Stewart | Administrateur | 32 Captains Lane Barton Under Needwood DE13 8EZ Burton On Trent Staffordshire | England | British | Director | 7028540001 | ||||
DEAN, George Charles | Administrateur | 64 Gillity Avenue WS5 3PP Walsall West Midlands | British | Company Director | 3005330001 |
Quelles sont les dernières déclarations sur les personnes ayant un contrôle significatif pour WALSALL BUSINESS SUPPORT LIMITED ?
Notifié le | Cessé le | Déclaration |
---|---|---|
11 mai 2017 | La société sait ou a des raisons de croire qu'aucune personne enregistrable ou entité juridique pertinente enregistrable n'est liée à la société. |
Source de données
- Companies House du Royaume-Uni
Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers. - Licence: CC0