THE NORWICH UNION LIFE INSURANCE COMPANY LIMITED

THE NORWICH UNION LIFE INSURANCE COMPANY LIMITED

  • Vue d'ensemble
  • Résumé
  • Objet social
  • Adresse
  • Dénominations sociales précédentes
  • Comptes
  • Dépôts
  • Dirigeants
  • Personnes ayant un contrôle significatif
  • Charges
  • Insolvabilité
  • Source de données
  • Vue d'ensemble

    Nom de la sociétéTHE NORWICH UNION LIFE INSURANCE COMPANY LIMITED
    Statut de la sociétéDissoute
    Forme juridiqueSociété à responsabilité limitée
    Numéro de société 00038832
    JuridictionAngleterre/Pays de Galles
    Date de création
    Date de cessation d'activité

    Résumé

    A des PSCs super sécurisésNon
    A des chargesOui
    A un historique d'insolvabilitéOui
    Le siège social est contestéNon

    Quel est l'objet de THE NORWICH UNION LIFE INSURANCE COMPANY LIMITED ?

    • Société inactive (99999) / Activités des organisations et organismes extraterritoriaux

    Où se situe THE NORWICH UNION LIFE INSURANCE COMPANY LIMITED ?

    Adresse du siège social
    1020 Eskdale Road
    Winnersh
    RG41 5TS Wokingham
    Adresse du siège social non livrableNon

    Quels étaient les noms précédents de THE NORWICH UNION LIFE INSURANCE COMPANY LIMITED ?

    Dénominations sociales précédentes
    Nom de la sociétéDeJusqu'au
    NORWICH UNION LIFE INSURANCE SOCIETY(THE)10 mai 189310 mai 1893

    Quels sont les derniers comptes de THE NORWICH UNION LIFE INSURANCE COMPANY LIMITED ?

    Derniers comptes
    Derniers comptes arrêtés au31 déc. 2017

    Quels sont les derniers dépôts pour THE NORWICH UNION LIFE INSURANCE COMPANY LIMITED ?

    Dépôts
    DateDescriptionDocumentType

    Gazette finale dissoute à la suite d'une liquidation

    1 pagesGAZ2

    Retour de la réunion finale dans une liquidation volontaire des membres

    7 pagesLIQ13

    Changement d'adresse du siège social de Aviva Wellington Row York North Yorkshire YO90 1WR England à 1020 Eskdale Road Winnersh Wokingham RG41 5TS le 09 juil. 2019

    1 pagesAD01

    Déclaration de solvabilité

    4 pagesLIQ01

    Nomination d'un liquidateur volontaire

    2 pages600

    Résolutions

    Resolutions
    1 pagesRESOLUTIONS
    Résolutions
    CatégorieDateDescriptionType
    liquidation

    Résolution spéciale pour la liquidation au 18 juin 2019

    LRESSP

    Déclaration de confirmation établie le 01 mai 2019 sans mise à jour

    3 pagesCS01

    Nomination de Mrs Karina Jane Bye en tant qu'administrateur le 29 avr. 2019

    2 pagesAP01

    Cessation de la nomination de Amy Victoria Gwynne Garvin en tant que directeur le 29 avr. 2019

    1 pagesTM01

    Cessation de la nomination de Linda Hall en tant que directeur le 29 avr. 2019

    1 pagesTM01

    Nomination de Mr David Rowley Rose en tant qu'administrateur le 29 avr. 2019

    2 pagesAP01

    Comptes pour une société dormante établis au 31 déc. 2017

    3 pagesAA

    Déclaration de confirmation établie le 01 mai 2018 sans mise à jour

    3 pagesCS01

    Cessation de la nomination de Clair Louise Marshall en tant que directeur le 29 sept. 2017

    1 pagesTM01

    Comptes pour une société dormante établis au 31 déc. 2016

    3 pagesAA

    Nomination de Amy Victoria Gwynne Garvin en tant qu'administrateur le 31 août 2017

    2 pagesAP01

    Nomination de Ms Linda Hall en tant qu'administrateur le 31 août 2017

    2 pagesAP01

    Cessation de la nomination de Aviva Company Secretarial Services Limited en tant que directeur le 31 août 2017

    1 pagesTM01

    Déclaration de confirmation établie le 01 mai 2017 avec mises à jour

    5 pagesCS01

    Cessation de la nomination de Aviva Director Services Limited en tant que directeur le 24 avr. 2017

    1 pagesTM01

    Comptes pour une société dormante établis au 31 déc. 2015

    3 pagesAA

    Déclaration annuelle jusqu'au 01 mai 2016 avec liste complète des actionnaires

    6 pagesAR01
    Dépôts associés
    CatégorieDateDescriptionType
    capital26 mai 2016

    État du capital au 26 mai 2016

    • Capital: GBP 100
    SH01

    Changement d'adresse du siège social de 2 Rougier Street York YO90 1UU à Aviva Wellington Row York North Yorkshire YO90 1WR le 29 févr. 2016

    1 pagesAD01

    Cessation de la nomination de Jennifer Jane Wilman en tant que directeur le 31 août 2015

    1 pagesTM01

    Nomination de Clair Louise Marshall en tant qu'administrateur le 01 août 2015

    2 pagesAP01

    Qui sont les dirigeants de THE NORWICH UNION LIFE INSURANCE COMPANY LIMITED ?

    Dirigeants
    NomNommé leDate de démissionRôleAdresseIdentification de la sociétéPays de résidenceNationalitéDate de naissanceProfessionNuméro
    AVIVA COMPANY SECRETARIAL SERVICES LIMITED
    1 Undershaft
    EC3P 3DQ London
    St Helen's
    United Kingdom
    Secrétaire
    1 Undershaft
    EC3P 3DQ London
    St Helen's
    United Kingdom
    Type d'identificationEEE
    Numéro d'enregistrement2084205
    1278390004
    BYE, Karina Jane
    1 Undershaft
    EC3P 3DQ London
    St Helen's
    United Kingdom
    Administrateur
    1 Undershaft
    EC3P 3DQ London
    St Helen's
    United Kingdom
    United KingdomBritishCompany Secretary239237640001
    ROSE, David Rowley
    1 Undershaft
    EC3P 3DQ London
    St Helen's
    United Kingdom
    Administrateur
    1 Undershaft
    EC3P 3DQ London
    St Helen's
    United Kingdom
    United KingdomBritishDirector89567200001
    BOURNER, Penelope Ellen Moira
    30 Saint Peters Road
    West Mersea
    CO5 8LJ Colchester
    Essex
    Secrétaire
    30 Saint Peters Road
    West Mersea
    CO5 8LJ Colchester
    Essex
    British63901950001
    HOWLETT, Annette Frances
    2 Newfound Drive
    Cringleford
    NR4 7RY Norwich
    Norfolk
    Secrétaire
    2 Newfound Drive
    Cringleford
    NR4 7RY Norwich
    Norfolk
    British51808770001
    JONES, Edward Graham
    61 The Street
    Brundall
    NR13 5LZ Norwich
    Norfolk
    Secrétaire
    61 The Street
    Brundall
    NR13 5LZ Norwich
    Norfolk
    British33670360003
    STANFORTH, John David
    8 Surrey Street
    NR1 3NG Norwich
    Norfolk
    Secrétaire
    8 Surrey Street
    NR1 3NG Norwich
    Norfolk
    BritishSecretary34926770001
    UTTING, Harry William
    17 Bishops Close
    NR7 0EH Norwich
    Norfolk
    Secrétaire
    17 Bishops Close
    NR7 0EH Norwich
    Norfolk
    British5286930001
    WHITE, Philip Martin
    5 Buttacre Lane
    Askham Richard
    YO23 3PE York
    Secrétaire
    5 Buttacre Lane
    Askham Richard
    YO23 3PE York
    British41789910004
    AVIVA COMPANY SECRETARIAL SERVICES LIMITED
    St Helen's
    1 Undershaft
    EC3P 3DQ London
    Secrétaire
    St Helen's
    1 Undershaft
    EC3P 3DQ London
    1278390004
    BASSET, Bryan Ronald
    67 Cottesmore Court
    Stamford Road
    W8 5QW Kensington
    London
    Administrateur
    67 Cottesmore Court
    Stamford Road
    W8 5QW Kensington
    London
    BritishCompany Director37804060002
    BIGGS, Michael Nicholas
    415 Unthank Road
    NR4 7QB Norwich
    Norfolk
    Administrateur
    415 Unthank Road
    NR4 7QB Norwich
    Norfolk
    BritishInsurance Company Official28234260001
    BIGGS, Michael Nicholas
    415 Unthank Road
    NR4 7QB Norwich
    Norfolk
    Administrateur
    415 Unthank Road
    NR4 7QB Norwich
    Norfolk
    BritishInsurance Company Official28234260001
    BRIDGEWATER, Allan
    30 St Mary Axe
    EC3A 8EP London
    Administrateur
    30 St Mary Axe
    EC3A 8EP London
    BritishChief Executive484540003
    BUXTON, Andrew Edward
    Hoveton Hall
    Wroxham
    NR12 8RJ Norwich
    Norfolk
    Administrateur
    Hoveton Hall
    Wroxham
    NR12 8RJ Norwich
    Norfolk
    United KingdomBritishCompany Director21920860003
    CALVER, Ronald
    16 Wentworth Green
    NR4 6AE Norwich
    Norfolk
    Administrateur
    16 Wentworth Green
    NR4 6AE Norwich
    Norfolk
    BritishActuary Ins Co Official37627040001
    CATOR, Francis
    The Old House
    Ranworth
    NR13 6HS Norwich
    Norfolk
    Administrateur
    The Old House
    Ranworth
    NR13 6HS Norwich
    Norfolk
    BritishCompany Director10596830001
    CLEMINSON, James Arnold Stacey, Sir
    Loddon Hall
    Hales
    NR14 6TB Norfolk
    Administrateur
    Loddon Hall
    Hales
    NR14 6TB Norfolk
    BritishCompany Director22530210003
    COPEMAN, Geoffrey Henry Charles
    Willows Farm
    Weston Longville
    NR9 5LG Norwich
    Norfolk
    Administrateur
    Willows Farm
    Weston Longville
    NR9 5LG Norwich
    Norfolk
    United KingdomBritishCompany Director484580001
    COURTENAY-SMITH, Nicholas Andrew
    Hillcrest
    Mount Pleasant
    NR2 2DG Norwich
    Norfolk
    Administrateur
    Hillcrest
    Mount Pleasant
    NR2 2DG Norwich
    Norfolk
    BritishInsurance Company Official38586970004
    FALCON, Michael Gascoigne
    Keswick Old Hall
    NR4 6TZ Norwich
    Norfolk
    Administrateur
    Keswick Old Hall
    NR4 6TZ Norwich
    Norfolk
    EnglandBritishCompany Director1922950001
    GARVIN, Amy Victoria Gwynne
    1 Undershaft
    EC3P 3DQ London
    St Helen's
    United Kingdom
    Administrateur
    1 Undershaft
    EC3P 3DQ London
    St Helen's
    United Kingdom
    United KingdomBritishChartered Secretary237531640001
    HALL, Linda
    Wellington Row
    YO90 1WR York
    Aviva
    North Yorkshire
    England
    Administrateur
    Wellington Row
    YO90 1WR York
    Aviva
    North Yorkshire
    England
    United KingdomBritishDirector180622890001
    HARVEY, Richard John
    33 Burnsall Street
    Chelsea
    SW3 3SR London
    Administrateur
    33 Burnsall Street
    Chelsea
    SW3 3SR London
    BritishActuary/Ins.Co.Offical73191390001
    HEYWORTH-DUNNE, James Anthony
    Smallburgh Hall
    Smallburgh
    NR12 9NW Norwich
    Administrateur
    Smallburgh Hall
    Smallburgh
    NR12 9NW Norwich
    BritishInsurance Company Official45398490002
    HOLMES, Peter Geoffrey
    The Old Rectory
    Shotesham All Saints
    NR15 1YL Norwich
    Norfolk
    Administrateur
    The Old Rectory
    Shotesham All Saints
    NR15 1YL Norwich
    Norfolk
    BritishCompany Director484600001
    KELLY, Thomas Anthony
    The Hollies 89 The Street
    Brooke
    NR15 1JT Norwich
    Norfolk
    Administrateur
    The Hollies 89 The Street
    Brooke
    NR15 1JT Norwich
    Norfolk
    BritishInsurance Company Official1147200001
    KEYS, David Chaloner
    Tower Hill House
    Tower Hill
    RH4 2AP Dorking
    Surrey
    Administrateur
    Tower Hill House
    Tower Hill
    RH4 2AP Dorking
    Surrey
    BritishCo.Chairman+Director13890050001
    LEAKE, Nigel Paul
    15 Hinckley Road
    Burton Hastings
    CV11 6RG Nuneaton
    Warwickshire
    Administrateur
    15 Hinckley Road
    Burton Hastings
    CV11 6RG Nuneaton
    Warwickshire
    BritishRetail Management36807440001
    MARSHALL, Clair Louise
    Wellington Row
    YO90 1WR York
    Aviva
    United Kingdom
    Administrateur
    Wellington Row
    YO90 1WR York
    Aviva
    United Kingdom
    United KingdomBritishSolicitor200178890001
    MILLS, Albert Gordon
    Rossacre
    Church Lane Wicklewood Wymondham
    NR18 9QH Norwich
    Norfolk
    Administrateur
    Rossacre
    Church Lane Wicklewood Wymondham
    NR18 9QH Norwich
    Norfolk
    BritishInsurance Company Official19967790002
    PARTRIDGE, Michael John Anthony
    27 High View
    HA5 3NZ Pinner
    Middlesex
    Administrateur
    27 High View
    HA5 3NZ Pinner
    Middlesex
    EnglandBritishRetired Civil Servant28205070001
    PAUL, George William
    Bluegates
    Wherstead
    IP9 2AU Ipswich
    Suffolk
    Administrateur
    Bluegates
    Wherstead
    IP9 2AU Ipswich
    Suffolk
    EnglandBritishCo.Chairman+Director1724130001
    PEEL, Jonathan Sidney, Reverend
    Barton Hall
    Barton Turf
    NR12 8AU Norwich
    Norfolk
    Administrateur
    Barton Hall
    Barton Turf
    NR12 8AU Norwich
    Norfolk
    BritishLand Economist484620001
    PERELMAN, Alan Steven
    66 Woodside Avenue
    Highgate
    N6 4ST London
    Administrateur
    66 Woodside Avenue
    Highgate
    N6 4ST London
    British And AustralianCompany Director78359020001

    Qui sont les personnes ayant un contrôle significatif sur THE NORWICH UNION LIFE INSURANCE COMPANY LIMITED ?

    Personnes ayant un contrôle significatif
    NomNotifié leAdresseCessé
    Wellington Row
    YO90 1WR York
    Aviva
    United Kingdom
    06 avr. 2016
    Wellington Row
    YO90 1WR York
    Aviva
    United Kingdom
    Non
    Forme juridiqueLimited By Shares
    Pays d'enregistrementEngland
    Autorité légaleUnited Kingdom (England)
    Lieu d'enregistrementCompanies House
    Numéro d'enregistrement3253947
    Nature du contrôle
    • La personne détient, directement ou indirectement, plus de 75 % des actions de la société.
    • La personne détient, directement ou indirectement, plus de 75 % des droits de vote dans la société.
    • La personne détient, directement ou indirectement, le droit de nommer ou de révoquer une majorité des membres du conseil d'administration de la société.

    THE NORWICH UNION LIFE INSURANCE COMPANY LIMITED a-t-elle des charges ?

    Charges
    ClassificationDatesStatutDétails
    Agreement in respect of a deposit and pledge
    Créé le 11 juin 1997
    Livré le 28 juin 1997
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All payment and indemnity obligations of the company to the chargee under the pledge agreement and deed of indemnity dated 11TH june 1997 including but not limited to the obligations by the company to buy a loan (the loan) of an amount of £158,200,000 from the chargee to winchester property investments limited made under an agreement dated 11TH june 1997 pursuant to the terms and conditions of the pledge agreement for an amount equal to the monies due to the chargee in respect of the loan and under the pledge agreement or the deed of indemnity
    Brèves mentions
    The registered certificate of deposit issued by the bank documented by an inscription in a special register held by the bank and representing the deposit of an amount of £158,200,000 placed in cash by the company with the bank on 11TH june 1997 and held in account number 196899. see the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Abn Amro Bank (Luxembourg) S.A.
    Transactions
    • 28 juin 1997Enregistrement d'une charge (395)
    • 09 juil. 2002Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Agreement in respect of a deposit and pledge (the "pledge agreement")
    Créé le 26 mars 1997
    Livré le 12 avr. 1997
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the "pledge agreement" and a deed of indemnity of even date including, but not limited to, the obligation by the company to buy a loan of an amount of £58,275,000 from the chargee to winchester property investments limited made under an agreement of even date, pursuant to the terms and conditions of the pledge agreement, for an amount equal to the principal, interest, accessories, fees, costs, expenses and other amounts due to the chargee in respect of the loan and under the pledge agreement of the deed of indemnity
    Brèves mentions
    The registered certificate of deposit issued by the bank, documented by an inscription in a special register held by the bank and representing the deposit of an amount of £58,275,000 placed in cash by the company with the bank on 26/3/97 and held in account number 196881 (designated as the "account which includes all sub-accounts bearing the same number) together with interest. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Abn Amro Bank (Luxembourg) S.A.
    Transactions
    • 12 avr. 1997Enregistrement d'une charge (395)
    • 09 juil. 2002Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Agreement in respect of a deposit and pledge (the "pledge agreement")
    Créé le 26 mars 1997
    Livré le 12 avr. 1997
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the "pledge agreement" and a deed of indemnity of even date including, but not limited to, the obligation by the company to buy a loan of an amount of £84,975,000 from the chargee to winchester property investments limited made under an agreement of even date, pursuant to the terms and conditions of the pledge agreement, for an amount equal to the principal, interest, accessories, fees, costs, expenses and other amounts due to the chargee in respect of the loan and under the pledge agreement of the deed of indemnity
    Brèves mentions
    The registered certificate of deposit issued by the bank, documented by an inscription in a special register held by the bank and representing the deposit of an amount of £84,975,000 placed in cash by the company with the bank on 26/3/97 and held in account number 196550 (designated as the "account which includes all sub-accounts bearing the same number) together with interest. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Abn Amro Bank (Luxembourg) S.A.
    Transactions
    • 12 avr. 1997Enregistrement d'une charge (395)
    • 09 juil. 2002Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Mortgage
    Créé le 30 juil. 1990
    Livré le 01 août 1990
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    £57,000 and all monies due or to become due from the company and michael joseph perry and meryl ann perry to the chargee.
    Brèves mentions
    F/H property k/a 5 blackthorn close lutterworth leicestershire (held by the said michael joseph perry and meryl ann perry and the company as tenants in common in unequal shares).
    Personnes ayant droit
    • Lloyds Bank PLC
    Transactions
    • 01 août 1990Enregistrement d'une charge
    • 22 avr. 2003Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Mortgage
    Créé le 16 juil. 1990
    Livré le 21 juil. 1990
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    £88,500 due from the company and roger william watts and dawn tanya watts to the chargee
    Brèves mentions
    F/Hold property k/as 5 oaklands cross oak rd, berkhamsted hertfordshire.
    Personnes ayant droit
    • Lloyds Bank PLC
    Transactions
    • 21 juil. 1990Enregistrement d'une charge
    • 22 avr. 2003Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Legal charge
    Créé le 22 sept. 1989
    Livré le 06 oct. 1989
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    £30,000 and all other moneys due or to become due from the company and/or john michael callaghan and/or ann whitley callaghan to the chargee including further advances under the terms of the mortgage.
    Brèves mentions
    F/H property k/a or being "ashling" meynell gardens snailwell road, newmarket suffolk including all fixtures thereon and additions thereto.
    Personnes ayant droit
    • Lloyds Bank PLC
    Transactions
    • 06 oct. 1989Enregistrement d'une charge
    • 22 avr. 2003Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)

    THE NORWICH UNION LIFE INSURANCE COMPANY LIMITED a-t-elle des procédures d'insolvabilité ?

    Numéro de dossierDatesTypePraticiensAutre
    1
    DateType
    18 juin 2019Commencement of winding up
    02 févr. 2020Dissolved on
    Members voluntary liquidation
    NomRôleAdresseNommé leCessé le
    Sean Kenneth Croston
    Grant Thornton Uk Llp 1020 Eskdale Road
    Winnersh
    RG41 5TS Wokingham
    practitioner
    Grant Thornton Uk Llp 1020 Eskdale Road
    Winnersh
    RG41 5TS Wokingham

    Source de données

    • Companies House du Royaume-Uni
      Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers.
    • Licence: CC0