00043765 LIMITED

  • Vue d'ensemble
  • Résumé
  • Objet social
  • Adresse
  • Dénominations sociales précédentes
  • Comptes
  • Dépôts
  • Dirigeants
  • Charges
  • Insolvabilité
  • Source de données
  • Vue d'ensemble

    Nom de la société00043765 LIMITED
    Statut de la sociétéDissoute
    Forme juridiqueSociété à responsabilité limitée
    Numéro de société 00043765
    JuridictionAngleterre/Pays de Galles
    Date de création
    Date de cessation d'activité

    Résumé

    A des PSCs super sécurisésNon
    A des chargesOui
    A un historique d'insolvabilitéOui
    Le siège social est contestéNon

    Quel est l'objet de 00043765 LIMITED ?

    • Tissage de textiles (13200) / Industries manufacturières

    Où se situe 00043765 LIMITED ?

    Adresse du siège social
    Kpmg Llp One Snowhill
    Snow Hill Queensway
    B4 6GH Birmingham
    Adresse du siège social non livrableNon

    Quels étaient les noms précédents de 00043765 LIMITED ?

    Dénominations sociales précédentes
    Nom de la sociétéDeJusqu'au
    J.& J.CASH LIMITED04 avr. 189504 avr. 1895

    Quels sont les derniers comptes de 00043765 LIMITED ?

    Derniers comptes
    Derniers comptes arrêtés au30 sept. 2012

    Quels sont les derniers dépôts pour 00043765 LIMITED ?

    Dépôts
    DateDescriptionDocumentType

    Bulletin officiel final dissous par radiation d'office

    1 pagesGAZ2

    Premier avis au Bulletin officiel pour la radiation d'office

    1 pagesGAZ1

    Restauration par ordonnance du tribunal

    5 pagesAC92

    Certificat de changement de nom

    Company name changed cash's (uk)\certificate issued on 12/03/16
    pagesCERTNM

    Gazette finale dissoute à la suite d'une liquidation

    1 pagesGAZ2

    Avis de transition de l'administration à la dissolution le 27 juil. 2015

    20 pages2.35B

    Rapport d'avancement de l'administrateur jusqu'à 14 mai 2015

    18 pages2.24B

    Avis de prolongation de la période de l'administration

    1 pages2.31B

    Rapport d'avancement de l'administrateur jusqu'à 14 nov. 2014

    19 pages2.24B

    Rapport d'avancement de l'administrateur jusqu'à 28 juil. 2014

    29 pages2.24B

    Cessation de la nomination de Sylvie Moreau en tant que directeur

    2 pagesTM01

    Cessation de la nomination de Sylvie Moreau en tant que secrétaire

    2 pagesTM02

    Cessation de la nomination de Andrew Ives en tant que directeur

    1 pagesTM01

    Avis d'approbation réputée des propositions

    1 pagesF2.18

    Déclaration de la proposition de l'administrateur

    39 pages2.17B

    Satisfaction de la charge 7 en totalité

    4 pagesMR04

    Déclaration des affaires avec le formulaire 2.14B

    12 pages2.16B

    Changement d'adresse du siège social de * Torrington Avenue Coventry West Midlands CV4 9UZ* le 06 févr. 2014

    2 pagesAD01

    Nomination d'un administrateur

    1 pages2.12B

    Déclaration annuelle jusqu'au 26 sept. 2013 avec liste complète des actionnaires

    4 pagesAR01
    Dépôts associés
    CatégorieDateDescriptionType
    capital26 sept. 2013

    État du capital au 26 sept. 2013

    • Capital: GBP 496,050
    SH01

    Nomination de Ms Sylvie Annie Renee Moreau en tant que secrétaire

    1 pagesAP03

    Cessation de la nomination de Alan Durber en tant que directeur

    1 pagesTM01

    Cessation de la nomination de Alan Durber en tant que secrétaire

    1 pagesTM02

    Comptes annuels établis au 30 sept. 2012

    18 pagesAA

    Déclaration annuelle jusqu'au 26 sept. 2012 avec liste complète des actionnaires

    5 pagesAR01

    Qui sont les dirigeants de 00043765 LIMITED ?

    Dirigeants
    NomNommé leDate de démissionRôleAdresseIdentification de la sociétéPays de résidenceNationalitéDate de naissanceProfessionNuméro
    DURBER, Alan
    3 Andrews Close
    DY5 2XB Brierley Hill
    West Midlands
    Secrétaire
    3 Andrews Close
    DY5 2XB Brierley Hill
    West Midlands
    BritishDirector63902460001
    DURBER, Alan
    3 Andrews Close
    DY5 2XB Brierley Hill
    West Midlands
    Secrétaire
    3 Andrews Close
    DY5 2XB Brierley Hill
    West Midlands
    BritishAccountant63902460001
    KERRY, Michael Joseph
    Four Winds Main Street
    Birdingbury
    CV23 8EL Rugby
    Warwickshire
    Secrétaire
    Four Winds Main Street
    Birdingbury
    CV23 8EL Rugby
    Warwickshire
    British19404400001
    MAYNARD, Lars Olaf
    The White House Hill
    Leamington Hastings
    CV23 8DX Rugby
    Warwickshire
    Secrétaire
    The White House Hill
    Leamington Hastings
    CV23 8DX Rugby
    Warwickshire
    BritishDirector47266610004
    MOREAU, Sylvie Annie Renee
    One Snowhill
    Snow Hill Queensway
    B4 6GH Birmingham
    Kpmg Llp
    Secrétaire
    One Snowhill
    Snow Hill Queensway
    B4 6GH Birmingham
    Kpmg Llp
    178495220001
    ARCHER, Anthony Charles
    Musley Bank Old School Lane
    Hampton On The Hill
    CV35 8QS Warwick
    Warwickshire
    Administrateur
    Musley Bank Old School Lane
    Hampton On The Hill
    CV35 8QS Warwick
    Warwickshire
    BritishDirector19048010001
    DURBER, Alan
    3 Andrews Close
    DY5 2XB Brierley Hill
    West Midlands
    Administrateur
    3 Andrews Close
    DY5 2XB Brierley Hill
    West Midlands
    United KingdomBritishDirector63902460001
    DURBER, Alan
    3 Andrews Close
    DY5 2XB Brierley Hill
    West Midlands
    Administrateur
    3 Andrews Close
    DY5 2XB Brierley Hill
    West Midlands
    United KingdomBritishFinance Director63902460001
    HALSTEAD, David
    26 South Parade
    Harbury
    CV33 9JE Leamington Spa
    Warwickshire
    Administrateur
    26 South Parade
    Harbury
    CV33 9JE Leamington Spa
    Warwickshire
    BritishDirector19404420001
    IVES, Andrew George, Doctor
    One Snowhill
    Snow Hill Queensway
    B4 6GH Birmingham
    Kpmg Llp
    Administrateur
    One Snowhill
    Snow Hill Queensway
    B4 6GH Birmingham
    Kpmg Llp
    United KingdomBritishDirector50887130001
    JONES, Peter Wingfield
    27 Beeston Fields Drive
    Beeston
    NG9 3DB Nottingham
    Nottinghamshire
    Administrateur
    27 Beeston Fields Drive
    Beeston
    NG9 3DB Nottingham
    Nottinghamshire
    BritishDirector1640870001
    JONES, Philip Locke
    Broadeaves Newstead Abbey Park
    Linby
    NG15 8GE Nottingham
    Nottinghamshire
    Administrateur
    Broadeaves Newstead Abbey Park
    Linby
    NG15 8GE Nottingham
    Nottinghamshire
    BritishDirector15447620001
    KERRY, Michael Joseph
    Four Winds Main Street
    Birdingbury
    CV23 8EL Rugby
    Warwickshire
    Administrateur
    Four Winds Main Street
    Birdingbury
    CV23 8EL Rugby
    Warwickshire
    BritishDirector19404400001
    LEE, Martine Tracey
    The Birches
    Cleeton St Mary
    DY14 0QR Cleobury Mortimer
    Shropshire
    Administrateur
    The Birches
    Cleeton St Mary
    DY14 0QR Cleobury Mortimer
    Shropshire
    United KingdomBritishSales And Marketing Consultant109016960001
    LOWE, John Charles, Dr
    7 Southey Close
    B91 3US Solihull
    Administrateur
    7 Southey Close
    B91 3US Solihull
    BritishDirector19404430002
    MAYNARD, Lars Olaf
    The White House Hill
    Leamington Hastings
    CV23 8DX Rugby
    Warwickshire
    Administrateur
    The White House Hill
    Leamington Hastings
    CV23 8DX Rugby
    Warwickshire
    United KingdomBritishFinancial Director47266610004
    MCGIBBON, Lewis
    Green Close Golf Lane
    Church Brampton
    NN16 8AY Northampton
    Northamptonshire
    Administrateur
    Green Close Golf Lane
    Church Brampton
    NN16 8AY Northampton
    Northamptonshire
    BritishDirector10780150001
    MOREAU, Sylvie Annie Renee
    One Snowhill
    Snow Hill Queensway
    B4 6GH Birmingham
    Kpmg Llp
    Administrateur
    One Snowhill
    Snow Hill Queensway
    B4 6GH Birmingham
    Kpmg Llp
    EnglandFrenchDirector65268900006
    SEWELL RUTTER, John Stuart
    The Old Vicarage
    GL19 4BX Deerhurst
    Gloucestershire
    Administrateur
    The Old Vicarage
    GL19 4BX Deerhurst
    Gloucestershire
    BritishDirector77644330001

    00043765 LIMITED a-t-elle des charges ?

    Charges
    ClassificationDatesStatutDétails
    Rent deposit charge
    Créé le 29 sept. 2006
    Livré le 30 sept. 2006
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    All moneys from time to time standing to the credit of the account referred to in the rent deposit charge. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Handara Properties Limited
    Transactions
    • 30 sept. 2006Enregistrement d'une charge (395)
    • 13 mars 2014Satisfaction d'une charge (MR04)
    Legal charge
    Créé le 04 mai 2006
    Livré le 05 mai 2006
    En cours
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    F/H land and factory premises on the south side of torrington avenue coventry west midlands t/no WK29035. By way of fixed charge the benefit of all covenants and rights concerning the property and plant machinery fixtures fittings furniture equipment implements and utensils the goodwill of any business carried on at the property and the proceeds of any insurance affecting the property or assets.
    Personnes ayant droit
    • National Westminster Bank PLC
    Transactions
    • 05 mai 2006Enregistrement d'une charge (395)
    Guarantee and floating charge
    Créé le 05 déc. 2000
    Livré le 14 déc. 2000
    En cours
    Montant garanti
    All obligations due and payable from time to time pursuant to loan notes consituting up to £7,000,000 6.5 per cent sudordinated secured loan notes of composite materials technology PLC ("cmt") constituted by an instrument dated 29 september 1999 executed by cmt and loan note certificates in respect thereof (the "loan notes ") (the secured obligations)
    Brèves mentions
    By way of floating charge ( subject to the provisions of a subordination agreement dated 5 december 2000 ) its undertaking and all its property and assets both present and future. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Nottcor 114 Limited
    Transactions
    • 14 déc. 2000Enregistrement d'une charge (395)
    Mortgage debenture
    Créé le 05 déc. 2000
    Livré le 07 déc. 2000
    En cours
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    A specific equitable charge over all freehold and leasehold properties and/or the proceeds of sale thereof fixed and floating charges over undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts and the benefits of any licences.
    Personnes ayant droit
    • National Westminster Bank PLC
    Transactions
    • 07 déc. 2000Enregistrement d'une charge (395)
    Guarantee & debenture
    Créé le 14 déc. 1999
    Livré le 22 janv. 2000
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become from the company and/or all or any of the other companies defined therein to the chargee under the terms of any of the finance documents (as defined)
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personnes ayant droit
    • Bank of America, National Association
    Transactions
    • 22 janv. 2000Enregistrement d'une charge (395)
    • 02 oct. 2000Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Legal mortgage
    Créé le 14 déc. 1999
    Livré le 30 déc. 1999
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies obligations and liabilities due or to become due from each obligor (as defined) to the chargee in its capacity as trustee for the beneficiaries (as defined) ("the security trustee") under or pursuant to the terms of any of the finance documents (as defined) and/or in connection with any loan facility or other financial accommodation from time to time granted or otherwise made available pursuant thereto together with all expenses (as defined) under the terms of any of the finance documents (as defined)
    Brèves mentions
    F/H land and buildings at torrington avenue coventry west midlands t/no: WK29035. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Bank of America, National Association
    Transactions
    • 30 déc. 1999Enregistrement d'une charge (395)
    • 02 oct. 2000Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Mortgage
    Créé le 09 juin 1975
    Livré le 13 juin 1975
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Premises on the east side of lockhurst lane, coventry and 41, park street coventry.
    Personnes ayant droit
    • Lloyds Bank PLC
    Transactions
    • 13 juin 1975Enregistrement d'une charge
    • 30 sept. 1999Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)

    00043765 LIMITED a-t-elle des procédures d'insolvabilité ?

    Numéro de dossierDatesTypePraticiensAutre
    1
    DateType
    29 janv. 2014Administration started
    27 juil. 2015Administration ended
    In administration
    NomRôleAdresseNommé leCessé le
    William James Wright
    One Snowhill Snow Hill Queensway
    B4 6GH Birmingham
    practitioner
    One Snowhill Snow Hill Queensway
    B4 6GH Birmingham
    Mark Jeremy Orton
    Kpmg Llp One Snowhill
    Snow Hill Queensway
    B4 6GH Birmingham
    practitioner
    Kpmg Llp One Snowhill
    Snow Hill Queensway
    B4 6GH Birmingham

    Source de données

    • Companies House du Royaume-Uni
      Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers.
    • Licence: CC0