STEWARD AND PATTESON LIMITED
Vue d'ensemble
| Nom de la société | STEWARD AND PATTESON LIMITED |
|---|---|
| Statut de la société | Dissoute |
| Forme juridique | Société à responsabilité limitée |
| Numéro de société | 00044502 |
| Juridiction | Angleterre/Pays de Galles |
| Date de création | |
| Date de cessation d'activité |
Résumé
| A des PSCs super sécurisés | Non |
|---|---|
| A des charges | Oui |
| A un historique d'insolvabilité | Oui |
| Le siège social est contesté | Non |
Où se situe STEWARD AND PATTESON LIMITED ?
| Adresse du siège social | Resolve Partners Limited 22 York Buildings John Adam Street WC2N 6JU London |
|---|---|
| Adresse du siège social non livrable | Non |
Quels sont les derniers comptes de STEWARD AND PATTESON LIMITED ?
| Derniers comptes | |
|---|---|
| Derniers comptes arrêtés au | 22 août 2015 |
Quels sont les derniers dépôts pour STEWARD AND PATTESON LIMITED ?
| Date | Description | Document | Type | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gazette finale dissoute à la suite d'une liquidation | 1 pages | GAZ2 | ||||||||||
Retour de la réunion finale dans une liquidation volontaire des membres | 10 pages | LIQ13 | ||||||||||
Déclaration des reçus et paiements des liquidateurs jusqu'à 11 janv. 2018 | 9 pages | LIQ03 | ||||||||||
Changement d'adresse du siège social de Resolve Partners Limited 48 Warwick Street London W1B 5NL à Resolve Partners Limited 22 York Buildings John Adam Street London WC2N 6JU le 13 sept. 2017 | 2 pages | AD01 | ||||||||||
Déclaration de confirmation établie le 02 mars 2017 avec mises à jour | 5 pages | CS01 | ||||||||||
Changement d'adresse du siège social de Westgate Brewery Bury St Edmunds Suffolk IP33 1QT United Kingdom à 48 Warwick Street London W1B 5NL le 08 févr. 2017 | 2 pages | AD01 | ||||||||||
Déclaration de solvabilité | 3 pages | 4.70 | ||||||||||
Nomination d'un liquidateur volontaire | 1 pages | 600 | ||||||||||
Résolutions Resolutions | 2 pages | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
Nomination de Lindsay Anne Keswick en tant que secrétaire le 25 avr. 2016 | 2 pages | AP03 | ||||||||||
Cessation de la nomination de Claire Susan Stewart en tant que secrétaire le 25 avr. 2016 | 1 pages | TM02 | ||||||||||
Changement d'adresse du siège social de Sunrise House Ninth Avenue Burton upon Trent Staffordshire DE14 3JZ à Westgate Brewery Bury St Edmunds Suffolk IP33 1QT le 07 mars 2016 | 1 pages | AD01 | ||||||||||
Déclaration annuelle jusqu'au 02 mars 2016 avec liste complète des actionnaires | 3 pages | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Comptes pour une société dormante établis au 22 août 2015 | 3 pages | AA | ||||||||||
Cessation de la nomination de Jonathan Robert Langford en tant que directeur le 26 janv. 2016 | 1 pages | TM01 | ||||||||||
Cessation de la nomination de Daryl Antony Kelly en tant que directeur le 26 janv. 2016 | 1 pages | TM01 | ||||||||||
Cessation de la nomination de Lucy Jane Bell en tant que directeur le 26 janv. 2016 | 1 pages | TM01 | ||||||||||
Nomination de Kirk Dyson Davis en tant qu'administrateur le 21 déc. 2015 | 2 pages | AP01 | ||||||||||
Cessation de la nomination de Henry Jones en tant que secrétaire le 04 déc. 2015 | 1 pages | TM02 | ||||||||||
Période comptable actuelle raccourcie du 24 août 2016 au 30 avr. 2016 | 1 pages | AA01 | ||||||||||
Cessation de la nomination de Patrick James Gallagher en tant que directeur le 23 juin 2015 | 1 pages | TM01 | ||||||||||
Déclaration annuelle jusqu'au 02 mars 2015 avec liste complète des actionnaires | 7 pages | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Comptes pour une société dormante établis au 23 août 2014 | 3 pages | AA | ||||||||||
Déclaration annuelle jusqu'au 02 mars 2014 avec liste complète des actionnaires | 7 pages | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Comptes pour une société dormante établis au 17 août 2013 | 3 pages | AA | ||||||||||
Qui sont les dirigeants de STEWARD AND PATTESON LIMITED ?
| Nom | Nommé le | Date de démission | Rôle | Adresse | Identification de la société | Pays de résidence | Nationalité | Date de naissance | Profession | Numéro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KESWICK, Lindsay Anne | Secrétaire | 22 York Buildings John Adam Street WC2N 6JU London Resolve Partners Limited | 207523700001 | |||||||
| DAVIS, Kirk Dyson | Administrateur | Ninth Avenue DE14 3JZ Burton Upon Trent Sunrise House Staffordshire United Kingdom | United Kingdom | British | 158484730001 | |||||
| ADAMS, Susanne Margaret | Secrétaire | Azalea 167 High Street Northchurch HP4 3QT Berkhamsted Hertfordshire | British | 28738400002 | ||||||
| CUTHBERTSON, Colin | Secrétaire | 5 Hill Gardens LE16 9EB Market Harborough Leicestershire | British | 26369940001 | ||||||
| HOMER, Neville Rex | Secrétaire | Caberfeidh 12 Forth Street EH39 4HY North Berwick East Lothian | British | 895960001 | ||||||
| HOMER, Neville Rex | Secrétaire | Caberfeidh 12 Forth Street EH39 4HY North Berwick East Lothian | British | 895960001 | ||||||
| JONES, Henry | Secrétaire | Ninth Avenue DE14 3JZ Burton Upon Trent Sunrise House Staffordshire United Kingdom | 180592730001 | |||||||
| KENDALL, Timothy James | Secrétaire | 31 Canterbury Close Erdington B23 7QL Birmingham West Midlands | British | 117397470002 | ||||||
| RUDD, Susan Clare | Secrétaire | Ninth Avenue DE14 3JZ Burton Upon Trent Sunrise House Staffordshire United Kingdom | 172445440001 | |||||||
| RUDD, Susan Clare | Secrétaire | 17 Thacker Drive WS13 6NS Lichfield Staffordshire | British | 81789210004 | ||||||
| STEVENS, Mark | Secrétaire | 5 Lyon Drive Murieston EH54 9HF Livingston West Lothian | British | 80951870001 | ||||||
| STEWART, Claire Susan | Secrétaire | Ninth Avenue DE14 3JZ Burton Upon Trent Sunrise House Staffordshire United Kingdom | 181021700001 | |||||||
| STEWART, Claire Susan | Secrétaire | Ninth Avenue DE14 3JZ Burton Upon Trent Sunrise House Staffordshire United Kingdom | Other | 130369890001 | ||||||
| WALMSLEY, Derek Kerr | Secrétaire | High Street Pavenham MK43 7NJ Bedford Walnut Barn Bedfordshire | British | 135181230001 | ||||||
| BASHFORTH, Edward Michael | Administrateur | Second Avenue DE14 2WF Burton Upon Trent Jubilee House Staffordshire United Kingdom | United Kingdom | British | 131551840002 | |||||
| BELL, Lucy Jane | Administrateur | Ninth Avenue DE14 3JZ Burton Upon Trent Sunrise House Staffordshire United Kingdom | United Kingdom | British | 164754670001 | |||||
| BUBB, Stewart Edmund Conyers | Administrateur | Clare Cottage 42 Lammas Lane KT10 8PD Esher Surrey | British | 36779040001 | ||||||
| CUMMING, Johanna Louise | Administrateur | 18 Prospect Quay 98 Point Pleasant SW18 1PR London | United Kingdom | British | 111108910001 | |||||
| DANDO, Stephen Peter | Administrateur | Second Avenue DE14 2WF Burton Upon Trent Jubilee House Staffordshire United Kingdom | United Kingdom | British | 152083750001 | |||||
| DUTTON, Philip | Administrateur | Second Avenue DE14 2WF Burton Upon Trent Jubilee House Staffordshire United Kingdom | United Kingdom | British | 141395280001 | |||||
| GALLAGHER, Patrick James | Administrateur | Ninth Avenue DE14 3JZ Burton Upon Trent Sunrise House Staffordshire United Kingdom | England | British | 205366190001 | |||||
| GODWIN-BRATT, Robert James | Administrateur | Ninth Avenue DE14 3JZ Burton Upon Trent Sunrise House Staffordshire United Kingdom | United Kingdom | British | 170184800001 | |||||
| HOMER, Neville Rex | Administrateur | Caberfeidh 12 Forth Street EH39 4HY North Berwick East Lothian | British | 895960001 | ||||||
| HOMER, Neville Rex | Administrateur | Caberfeidh 12 Forth Street EH39 4HY North Berwick East Lothian | British | 895960001 | ||||||
| JONES, Karen Elisabeth Dind | Administrateur | Paddock House 9 Spencer Park Wandsworth SW18 2SX London | United Kingdom | British | 47793260007 | |||||
| KELLY, Daryl Antony | Administrateur | Ninth Avenue DE14 3JZ Burton Upon Trent Sunrise House Staffordshire United Kingdom | United Kingdom | British | 86246470001 | |||||
| KNIGHT, Andrew Ronald | Administrateur | 89 Main Street DE13 7ED Alrewas Staffordshire | British | 81555100002 | ||||||
| LANGFORD, Jonathan Robert | Administrateur | Ninth Avenue DE14 3JZ Burton Upon Trent Sunrise House Staffordshire United Kingdom | United Kingdom | British | 135408140001 | |||||
| MARGERRISON, Russell John | Administrateur | Ninth Avenue DE14 3JZ Burton Upon Trent Sunrise House Staffordshire United Kingdom | England | British | 170590800001 | |||||
| MCDONALD, Robert James | Administrateur | 46 Wentworth Drive WS14 9HN Lichfield Staffordshire | British | 42019620001 | ||||||
| MILLER, Louise | Administrateur | 13 Traquair Park West EH12 7AN Edinburgh Midlothian | British | 63895470001 | ||||||
| MYDDELTON, Roger Hugh | Administrateur | 21 Lawford Road NW5 2LH London | British | 399500001 | ||||||
| PEAREY, Michael John | Administrateur | The Lodge EH32 0RE Aberlady East Lothian | British | 46305030001 | ||||||
| PEAREY, Michael John | Administrateur | The Lodge EH32 0RE Aberlady East Lothian | British | 46305030001 | ||||||
| PRESTON, Neil David | Administrateur | Second Avenue DE14 2WF Burton Upon Trent Jubilee House Staffordshire United Kingdom | United Kingdom | British | 63043630002 |
Quelles sont les dernières déclarations sur les personnes ayant un contrôle significatif pour STEWARD AND PATTESON LIMITED ?
| Notifié le | Cessé le | Déclaration |
|---|---|---|
| 02 mars 2017 | La société sait ou a des raisons de croire qu'aucune personne enregistrable ou entité juridique pertinente enregistrable n'est liée à la société. |
STEWARD AND PATTESON LIMITED a-t-elle des charges ?
| Classification | Dates | Statut | Détails | |
|---|---|---|---|---|
| Security agreement | Créé le 15 déc. 2003 Livré le 31 déc. 2003 | Totalement satisfaite | Montant garanti All monies due or to become due from each obligor to any finance party under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Brèves mentions Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
| Twelfth supplemental trust deed | Créé le 30 sept. 1985 Livré le 07 oct. 1985 | Totalement satisfaite | Montant garanti £1,288,988 debenture stock of watney mann & truman holdings PLC comprising of £349,595 5% redeemable debenture stock 2000 £ 243,200 6 1/2% redeemable debenture stock 1988/93 & £696,193, 7 3/4% redeemable debenture stock 1988/93 and all other monies intended to be secured by a trust deed 7/2/62 & deeds supplemental thereto | |
Brèves mentions First floating charge. Undertaking and all property and assets present and future including uncalled capital. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
| Trust deed | Créé le 24 mai 1983 Livré le 25 mai 1983 | Totalement satisfaite | Montant garanti £50,000,000 12 1/8% redeemable debenture stock 2008 of watney mann & truman holdings PLC and for further securing all monies due or/to become due from watney mann & truman holdings PLC to the chargee under the terms of a trust deed dated 7/2/62 & deeds supplemental thereto | |
Brèves mentions Undertaking and all property and assets present and future including uncalled capital. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
| Trust deed | Créé le 28 juil. 1970 Livré le 12 août 1970 | Totalement satisfaite | Montant garanti Foe securing debenture stock of watney mann LTD amounting to £53,127,463 inclusive of £45,627,463 secured by a trust deed dated 7TH feb 1962 and deeds supplemental thereto | |
Brèves mentions By way of collateral security first floating charge on undertaking and assets present and future including uncalled capital. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
| Trust deed | Créé le 31 juil. 1967 Livré le 31 juil. 1967 | Totalement satisfaite | Montant garanti For securing debenture stock of watney mann LTD amounting to £ 45,627,463 inclusive of £35,627,463 secured by a trust deed dated 7TH. Feb 1962 and deeds supplemental theretoand deeds supplemental therrto | |
Brèves mentions By way of collateral security first floating charge on undertaking and assets present and future including uncalled capital. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
| Equitable charge without an instrument | Créé le 08 mai 1967 Livré le 26 mai 1967 | Totalement satisfaite | Montant garanti For securing debenture stock of watney mann LTD amounting to £10,000,000 | |
Brèves mentions First floating charge on undertaking and assets present and future including uncalled capital. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
| Trust deed | Créé le 26 juil. 1965 Livré le 28 juil. 1965 | Totalement satisfaite | Montant garanti For securing £7,500,000 debenture stock of watney mann supplemental to a trust deed dated 7/2/62 and three deeds supplemental thereto | |
Brèves mentions Floating charge on undertaking and assets present and future including uncalled capital. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
| Trust deed | Créé le 26 mars 1965 Livré le 06 avr. 1965 | Totalement satisfaite | Montant garanti For securing £28,127,463 debenture stock of watney mann LTD. Inclusive of £26,780,195 secured by a trust deed dated 7/2/62 & deed supplemental thereto | |
Brèves mentions Further charge on and first floating charge on undertaking and assets present and future including uncalled capital. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
STEWARD AND PATTESON LIMITED a-t-elle des procédures d'insolvabilité ?
| Numéro de dossier | Dates | Type | Praticiens | Autre | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
| Members voluntary liquidation |
|
Source de données
- Companies House du Royaume-Uni
Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers. - Licence: CC0