BARHAM PHOTOGRAPHIC LIMITED

  • Vue d'ensemble
  • Résumé
  • Objet social
  • Adresse
  • Dénominations sociales précédentes
  • Comptes
  • Dépôts
  • Dirigeants
  • Charges
  • Source de données
  • Vue d'ensemble

    Nom de la sociétéBARHAM PHOTOGRAPHIC LIMITED
    Statut de la sociétéDissoute
    Forme juridiqueSociété à responsabilité limitée
    Numéro de société 00049753
    JuridictionAngleterre/Pays de Galles
    Date de création
    Date de cessation d'activité

    Résumé

    A des PSCs super sécurisésNon
    A des chargesOui
    A un historique d'insolvabilitéNon
    Le siège social est contestéNon

    Quel est l'objet de BARHAM PHOTOGRAPHIC LIMITED ?

    • (7499) /

    Où se situe BARHAM PHOTOGRAPHIC LIMITED ?

    Adresse du siège social
    Mortimer House
    37-41 Mortimer Street
    W1T 3JH London
    Adresse du siège social non livrableNon

    Quels étaient les noms précédents de BARHAM PHOTOGRAPHIC LIMITED ?

    Dénominations sociales précédentes
    Nom de la sociétéDeJusqu'au
    DOLLONDS PHOTOGRAPHIC LIMITED16 oct. 189616 oct. 1896

    Quels sont les derniers comptes de BARHAM PHOTOGRAPHIC LIMITED ?

    Derniers comptes
    Derniers comptes arrêtés au31 déc. 2009

    Quels sont les derniers dépôts pour BARHAM PHOTOGRAPHIC LIMITED ?

    Dépôts
    DateDescriptionDocumentType

    Bulletin officiel final dissous par radiation volontaire

    1 pagesGAZ2(A)

    Premier avis au Bulletin officiel pour la radiation volontaire

    1 pagesGAZ1(A)

    Demande de radiation de la société du registre du commerce

    4 pagesDS01

    legacy

    1 pagesCAP-SS

    État du capital au 23 déc. 2010

    • Capital: GBP 1
    4 pagesSH19

    Résolutions

    Resolutions
    2 pagesRESOLUTIONS
    Résolutions
    CatégorieDateDescriptionType
    capital

    Résolutions

    Reduce share premium account 30/11/2010
    RES13
    capital

    Résolution de réduction du capital social émis

    RES06

    Modification des coordonnées de l'administrateur Mr Adam Christopher Walker le 05 oct. 2010

    2 pagesCH01

    Modification des coordonnées de l'administrateur Mr Peter Stephen Rigby le 05 oct. 2010

    2 pagesCH01

    Modification des coordonnées du secrétaire Miss Julie Louise Wilson le 27 sept. 2010

    1 pagesCH03

    Comptes pour une société dormante établis au 31 déc. 2009

    9 pagesAA

    Modification des coordonnées de l'administrateur John William Burton le 11 août 2010

    2 pagesCH01

    Déclaration annuelle jusqu'au 01 juin 2010 avec liste complète des actionnaires

    7 pagesAR01

    Nomination de Rachel Jacobs en tant qu'administrateur

    2 pagesAP01

    Nomination de Gareth Richard Wright en tant qu'administrateur

    2 pagesAP01

    Modification des coordonnées du secrétaire Miss Julie Louise Wilson le 02 déc. 2009

    1 pagesCH03

    Modification des coordonnées de l'administrateur Mark Henry Kerswell le 02 déc. 2009

    2 pagesCH01

    Modification des coordonnées de l'administrateur Peter Stephen Rigby le 01 déc. 2009

    2 pagesCH01

    Modification des coordonnées de l'administrateur Adam Christopher Walker le 27 nov. 2009

    2 pagesCH01

    Comptes établis au 31 déc. 2008

    5 pagesAA

    legacy

    2 pages288a

    legacy

    4 pages363a

    legacy

    1 pages288c

    Comptes établis au 31 déc. 2007

    5 pagesAA

    legacy

    4 pages363a

    legacy

    1 pages288a

    Qui sont les dirigeants de BARHAM PHOTOGRAPHIC LIMITED ?

    Dirigeants
    NomNommé leDate de démissionRôleAdresseIdentification de la sociétéPays de résidenceNationalitéDate de naissanceProfessionNuméro
    WOOLLARD, Julie Louise
    37/41 Mortimer Street
    W1T 3JH London
    Mortimer House
    England
    Secrétaire
    37/41 Mortimer Street
    W1T 3JH London
    Mortimer House
    England
    British139159370002
    BURTON, John William
    Mortimer House
    37-41 Mortimer Street
    W1T 3JH London
    Administrateur
    Mortimer House
    37-41 Mortimer Street
    W1T 3JH London
    United KingdomBritish113684810001
    JACOBS, Rachel Elizabeth
    37/41 Mortimer Street
    W1T 3JH London
    Mortimer House
    England
    Administrateur
    37/41 Mortimer Street
    W1T 3JH London
    Mortimer House
    England
    United KingdomBritish92334500004
    KERSWELL, Mark Henry
    37/41 Mortimer Street
    W1T 3JH London
    Mortimer House
    England
    Administrateur
    37/41 Mortimer Street
    W1T 3JH London
    Mortimer House
    England
    EnglandBritish82609620003
    RIGBY, Peter Stephen
    37/41 Mortimer Street
    W1T 3JH London
    Mortimer House
    England
    Administrateur
    37/41 Mortimer Street
    W1T 3JH London
    Mortimer House
    England
    SwitzerlandBritish69164290007
    WALKER, Adam Christopher
    37/41 Mortimer Street
    W1T 3JH London
    Mortimer House
    England
    Administrateur
    37/41 Mortimer Street
    W1T 3JH London
    Mortimer House
    England
    SwitzerlandBritish129368430002
    WRIGHT, Gareth Richard
    37/41 Mortimer Street
    W1T 3JH London
    Mortimer House
    England
    Administrateur
    37/41 Mortimer Street
    W1T 3JH London
    Mortimer House
    England
    United KingdomBritish131115190001
    CALLABY, Andrea Mary
    5 Thornton Drive
    CO4 5WB Colchester
    Essex
    Secrétaire
    5 Thornton Drive
    CO4 5WB Colchester
    Essex
    British70352690002
    HAYWARD, Pearl Catherine
    60 Idmiston Square
    KT4 7SY Worcester Park
    Surrey
    Secrétaire
    60 Idmiston Square
    KT4 7SY Worcester Park
    Surrey
    British61319730001
    LODGE, David William
    19 Windermere Drive
    CM7 8UB Braintree
    Essex
    Secrétaire
    19 Windermere Drive
    CM7 8UB Braintree
    Essex
    British10640040001
    PEACH, Inez Mary
    Silverwood Station Road
    Semley
    SP7 9AH Shaftesbury
    Dorset
    Secrétaire
    Silverwood Station Road
    Semley
    SP7 9AH Shaftesbury
    Dorset
    British9976010001
    RICHMOND, Sonia Anna
    8 Viscount Gardens
    KT14 6HE Byfleet
    Surrey
    Secrétaire
    8 Viscount Gardens
    KT14 6HE Byfleet
    Surrey
    British118535490002
    WHITE, Teresa Catherine
    2 Cuckoo Dene
    W7 3DP London
    Secrétaire
    2 Cuckoo Dene
    W7 3DP London
    British65724350001
    WITHERS, John Martin
    High Trees Farm
    2 Lexden Road West Bergholt
    CO6 3BT Colchester
    Essex
    Secrétaire
    High Trees Farm
    2 Lexden Road West Bergholt
    CO6 3BT Colchester
    Essex
    British41682250002
    CROPPER, Anthony Graham
    Meadow House
    Moules Lane Hadstock
    CB21 4PD Cambridge
    Cambridgeshire
    Administrateur
    Meadow House
    Moules Lane Hadstock
    CB21 4PD Cambridge
    Cambridgeshire
    EnglandBritish8664640001
    FOYE, Anthony Martin
    Lynwood
    White Lane
    RG26 5TN Hannington
    Hampshire
    Administrateur
    Lynwood
    White Lane
    RG26 5TN Hannington
    Hampshire
    United KingdomBritish99515780001
    GILBERTSON, David Stuart
    Casa Maria
    Spaniard's End Hampstead
    NW3 7JG London
    Administrateur
    Casa Maria
    Spaniard's End Hampstead
    NW3 7JG London
    United KingdomBritish10921820004
    WILKINSON, James Henry
    2 The Nursery
    Sutton Courtenay
    OX14 4UA Abingdon
    Oxfordshire
    Administrateur
    2 The Nursery
    Sutton Courtenay
    OX14 4UA Abingdon
    Oxfordshire
    United KingdomBritish56006210002
    WITHERS, John Martin
    High Trees Farm
    2 Lexden Road West Bergholt
    CO6 3BT Colchester
    Essex
    Administrateur
    High Trees Farm
    2 Lexden Road West Bergholt
    CO6 3BT Colchester
    Essex
    British41682250002
    WYLES, Rhona Irene
    43 Blomfield Road
    W9 2PF London
    Administrateur
    43 Blomfield Road
    W9 2PF London
    British51215380001

    BARHAM PHOTOGRAPHIC LIMITED a-t-elle des charges ?

    Charges
    ClassificationDatesStatutDétails
    Letter of set off
    Créé le 28 mai 1985
    Livré le 13 juin 1985
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company and/or all or any or the other companies named therein to the chargee
    Brèves mentions
    All the property referred to in the joint company letter of set-off dated 28 may 1985 to which the following companies are party:- finger print graphics limited barham group P.L.C geoff axtell associates limited, smedley mc alpine limited, clive antony properties limited, barham photographic limited, nicholas stracey (UK) limited.
    Personnes ayant droit
    • Hill Samuel & Co. LTD
    Transactions
    • 13 juin 1985Enregistrement d'une charge
    Letter of set off
    Créé le 14 nov. 1984
    Livré le 28 nov. 1984
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee
    Brèves mentions
    All the property referred to in the joint company letter of set off dated 14/11/84 to which the following companies are party barham photographic LTD: barham group PLC: agency estate investments LTD: geof axtell associates LTD: smedley mc alpine LTD: nicholas stacey (UK) LTD: clive anthony properties LTD.
    Personnes ayant droit
    • Barham Photographic Limited
    Transactions
    • 28 nov. 1984Enregistrement d'une charge
    Letter of set off
    Créé le 19 oct. 1983
    Livré le 27 oct. 1983
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee
    Brèves mentions
    Credit balances.
    Personnes ayant droit
    • Hill Samuel & Co. LTD
    Transactions
    • 27 oct. 1983Enregistrement d'une charge
    Debenture
    Créé le 10 mars 1983
    Livré le 17 mars 1983
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Fixed and floating charge over the :- undertaking and all property and assets present and future including goodwill, book debts & uncalled capital.. Together with fixed and moveable plant machinery fixtures implements and utensils.
    Personnes ayant droit
    • Hill Samuel & Co Limited
    Transactions
    • 17 mars 1983Enregistrement d'une charge
    Fixed and floating charge
    Créé le 10 févr. 1983
    Livré le 16 févr. 1983
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Fixed & floating charge undertaking and all property and assets present and future including book debts, uncalled capital.
    Personnes ayant droit
    • Midland Bank PLC
    Transactions
    • 16 févr. 1983Enregistrement d'une charge

    Source de données

    • Companies House du Royaume-Uni
      Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers.
    • Licence: CC0