ESTATES & GENERAL LIMITED

  • Vue d'ensemble
  • Résumé
  • Objet social
  • Adresse
  • Dénominations sociales précédentes
  • Comptes
  • Dépôts
  • Dirigeants
  • Charges
  • Insolvabilité
  • Source de données
  • Vue d'ensemble

    Nom de la sociétéESTATES & GENERAL LIMITED
    Statut de la sociétéDissoute
    Forme juridiqueSociété à responsabilité limitée
    Numéro de société 00050072
    JuridictionAngleterre/Pays de Galles
    Date de création
    Date de cessation d'activité

    Résumé

    A des PSCs super sécurisésNon
    A des chargesOui
    A un historique d'insolvabilitéOui
    Le siège social est contestéNon

    Quel est l'objet de ESTATES & GENERAL LIMITED ?

    • (7011) /

    Où se situe ESTATES & GENERAL LIMITED ?

    Adresse du siège social
    BEGBIES TRAYNOR (CENTRAL) LLP
    31st Floor 40 Bank Street
    E14 5NR London
    Adresse du siège social non livrableNon

    Quels étaient les noms précédents de ESTATES & GENERAL LIMITED ?

    Dénominations sociales précédentes
    Nom de la sociétéDeJusqu'au
    ESTATES & GENERAL PLC18 juin 199018 juin 1990
    ESTATES & GENERAL INVESTMENTS PLC14 juil. 198714 juil. 1987
    ESTATES AND GENERAL INVESTMENTS PLC11 nov. 189611 nov. 1896

    Quels sont les derniers comptes de ESTATES & GENERAL LIMITED ?

    Derniers comptes
    Derniers comptes arrêtés au31 mars 2009

    Quels sont les derniers dépôts pour ESTATES & GENERAL LIMITED ?

    Dépôts
    DateDescriptionDocumentType

    Gazette finale dissoute à la suite d'une liquidation

    1 pagesGAZ2

    Retour de la réunion finale dans une liquidation volontaire des créanciers

    20 pagesLIQ14

    Cessation de la nomination de Maurice Moses Benady en tant que directeur le 10 oct. 2021

    1 pagesTM01

    Déclaration des reçus et paiements des liquidateurs jusqu'à 20 janv. 2021

    19 pagesLIQ03

    Déclaration des reçus et paiements des liquidateurs jusqu'à 20 janv. 2020

    19 pagesLIQ03

    Déclaration des reçus et paiements des liquidateurs jusqu'à 20 janv. 2019

    22 pagesLIQ03

    Résumé des recettes et paiements du récepteur jusqu'au 07 févr. 2018

    2 pages3.6

    Déclaration des reçus et paiements des liquidateurs jusqu'à 20 janv. 2018

    22 pagesLIQ03

    Cessation de la nomination de F & C Reit (Corporate Services) Limited en tant que secrétaire le 08 août 2016

    2 pagesTM02

    Résumé des recettes et paiements du récepteur jusqu'au 07 févr. 2017

    2 pages3.6

    Déclaration des reçus et paiements des liquidateurs jusqu'à 20 janv. 2017

    19 pages4.68

    Résumé des recettes et paiements du récepteur jusqu'au 07 févr. 2016

    2 pages3.6

    Déclaration des reçus et paiements des liquidateurs jusqu'à 20 janv. 2016

    19 pages4.68

    Résumé des recettes et paiements du récepteur jusqu'au 07 févr. 2015

    2 pages3.6

    Résumé des recettes et paiements du récepteur jusqu'au 07 févr. 2014

    2 pages3.6

    Déclaration des reçus et paiements des liquidateurs jusqu'à 20 janv. 2015

    18 pages4.68

    Changement d'adresse du siège social de Hill House 1 Little New Street London EC4A 3TR à 31St Floor 40 Bank Street London E14 5NR le 26 sept. 2014

    2 pagesAD01

    Nomination d'un administrateur judiciaire ou d'un gérant

    4 pagesRM01

    Avis de cessation d'activité en tant qu'administrateur judiciaire ou gérant

    4 pagesRM02

    Résumé des recettes et paiements du récepteur jusqu'au 07 févr. 2014

    2 pages3.6

    Déclaration des reçus et paiements des liquidateurs jusqu'à 20 janv. 2014

    19 pages4.68

    Résumé des recettes et paiements du récepteur jusqu'au 07 févr. 2014

    2 pages3.6

    Déclaration des reçus et paiements des liquidateurs jusqu'à 20 janv. 2013

    22 pages4.68

    Résumé des recettes et paiements du récepteur jusqu'au 07 févr. 2013

    2 pages3.6

    Résumé des recettes et paiements du récepteur jusqu'au 07 févr. 2012

    3 pages3.6

    Qui sont les dirigeants de ESTATES & GENERAL LIMITED ?

    Dirigeants
    NomNommé leDate de démissionRôleAdresseIdentification de la sociétéPays de résidenceNationalitéDate de naissanceProfessionNuméro
    WHITE, Christopher George
    Line Wall Road
    FOREIGN Gibraltar
    57/63
    Gibraltar
    Administrateur
    Line Wall Road
    FOREIGN Gibraltar
    57/63
    Gibraltar
    GibraltarBritish80132540001
    TRAFALGAR OFFICERS LIMITED
    5 Wigmore Street
    W1U 1PB London
    3rd Floor
    Administrateur
    5 Wigmore Street
    W1U 1PB London
    3rd Floor
    Type d'identificationSociété à responsabilité limitée du Royaume-Uni
    Numéro d'enregistrement6745658
    135316290001
    CULL, David Geoffrey Maurice
    8 Centennial Court
    High Street
    WD3 1AW Rickmansworth
    Hertfordshire
    Secrétaire
    8 Centennial Court
    High Street
    WD3 1AW Rickmansworth
    Hertfordshire
    British84076630001
    HOLLAND, Philip John
    61 Badgers Gate
    LU6 2BF Dunstable
    Bedfordshire
    Secrétaire
    61 Badgers Gate
    LU6 2BF Dunstable
    Bedfordshire
    British163838050001
    JACOBS, Adrian Mark
    13 Beaufort Gardens
    Hendon
    NW4 3QN London
    Secrétaire
    13 Beaufort Gardens
    Hendon
    NW4 3QN London
    British59392140001
    F&C REIT (CORPORATE SERVICES) LIMITED
    Wigmore Street
    W1U 1PB London
    5
    United Kingdom
    Secrétaire
    Wigmore Street
    W1U 1PB London
    5
    United Kingdom
    Type d'identificationEEE
    Numéro d'enregistrement3143222
    79571870006
    ANAHORY, Moshe Jaacov
    608 Eurotowers
    Europort
    Gibraltar
    Administrateur
    608 Eurotowers
    Europort
    Gibraltar
    United KingdomBritish88548180001
    BENADY, Maurice Moses
    57/63 Line Wall Road
    Gibraltar
    Administrateur
    57/63 Line Wall Road
    Gibraltar
    GibraltarBritish69435160001
    BENADY, Maurice Moses
    Bishop Rapallo's Ramp
    Gibraltar
    1b
    Administrateur
    Bishop Rapallo's Ramp
    Gibraltar
    1b
    GibraltarBritish69435160001
    BLOOMFIELD, David William
    Hillcroft
    The Drive Harefield Place
    UB10 8AQ Ickenham
    Middlesex
    Administrateur
    Hillcroft
    The Drive Harefield Place
    UB10 8AQ Ickenham
    Middlesex
    British7927670001
    CLEGG, Barry Stuart
    The Gate House
    18a Ducks Hill Road
    HA6 2NR Northwood
    Middlesex
    Administrateur
    The Gate House
    18a Ducks Hill Road
    HA6 2NR Northwood
    Middlesex
    United KingdomBritish11296610002
    CULL, David Geoffrey Maurice
    8 Centennial Court
    High Street
    WD3 1AW Rickmansworth
    Hertfordshire
    Administrateur
    8 Centennial Court
    High Street
    WD3 1AW Rickmansworth
    Hertfordshire
    British84076630001
    DOSSETT, Roger John
    Charlecote
    Harewood Road
    HP8 4UA Chalfont St Giles
    Buckinghamshire
    Administrateur
    Charlecote
    Harewood Road
    HP8 4UA Chalfont St Giles
    Buckinghamshire
    EnglandBritish116927100001
    HOLLAND, Philip John
    61 Badgers Gate
    LU6 2BF Dunstable
    Bedfordshire
    Administrateur
    61 Badgers Gate
    LU6 2BF Dunstable
    Bedfordshire
    EnglandBritish163838050001
    LLOYD, David Griffith
    Edenbridge House
    TN8 6SJ Edenbridge
    Kent
    Administrateur
    Edenbridge House
    TN8 6SJ Edenbridge
    Kent
    British40639900001
    MCGRATH, Kevin David
    19 Elm Avenue
    W5 3XA London
    Administrateur
    19 Elm Avenue
    W5 3XA London
    EnglandBritish83872490002
    PROWTING, Peter Brian
    Old Farm House
    SL3 6HU Fulmer
    Buckinghamshire
    Administrateur
    Old Farm House
    SL3 6HU Fulmer
    Buckinghamshire
    United KingdomBritish11296620003
    SHEPPARD, Martin Paul
    53 Etchingham Park Road
    N3 2EB London
    Administrateur
    53 Etchingham Park Road
    N3 2EB London
    United KingdomBritish127658820001
    SMITH, Ivor
    3 Shirehall Lane
    NW4 2PE London
    Administrateur
    3 Shirehall Lane
    NW4 2PE London
    United KingdomBritish21120940002
    WHITE, Christopher George
    9
    4 Naval Hospital Hill
    Gibraltar
    Administrateur
    9
    4 Naval Hospital Hill
    Gibraltar
    British99490560001
    WILSON, Thomas Frederick
    Myton House Manor Fields
    Putney Heath Putney
    SW15 3NJ London
    Administrateur
    Myton House Manor Fields
    Putney Heath Putney
    SW15 3NJ London
    British35556920001
    REIT (CORPORATE SERVICES) LIMITED
    5 Wigmore Street
    W1U 1PB London
    Administrateur
    5 Wigmore Street
    W1U 1PB London
    79571870001
    REIT(CORPORATE DIRECTORS) LIMITED
    5 Wigmore Street
    W1U 1PB London
    Administrateur
    5 Wigmore Street
    W1U 1PB London
    74030120002

    ESTATES & GENERAL LIMITED a-t-elle des charges ?

    Charges
    ClassificationDatesStatutDétails
    Eleventh supplemental trust deed
    Créé le 15 août 2006
    Livré le 30 août 2006
    En cours
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    L/H land and buildings k/a tontines hanley stoke on trent t/n SF414169 together with all buildings and erections and fixtures and fittings and fixed plant and machinery for the time being thereon belonging to it and all improvements and additions thereto subject to and with the benefit of all leases underleases tenancies agreements for lease rights covenants and conditions affecting the same but otherwise free from encumberances. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Capita Irg Trustees Limited
    Transactions
    • 30 août 2006Enregistrement d'une charge (395)
    Ninth supplemental trust
    Créé le 01 déc. 2005
    Livré le 02 déc. 2005
    En cours
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    First specific security the capital sum of £13,750,000 and the investments. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Capita Irg Trustees Limited
    Transactions
    • 02 déc. 2005Enregistrement d'une charge (395)
    Debenture
    Créé le 15 sept. 2004
    Livré le 29 sept. 2004
    En cours
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the chargor to any finance party on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    By way of fixed charge all of the chargor's rights to and title and interest from time to time in the real properties specified in part iii of schedule 2. by way of floating charge (I) the whole of its assets, present and future and (ii) the whole of its assets situated in scotland.. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Hypo Real Estate Bank International (The "Security Trustee")
    Transactions
    • 29 sept. 2004Enregistrement d'une charge (395)
    Sixth supplemental trust deed
    Créé le 18 févr. 2003
    Livré le 25 févr. 2003
    Partiellement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    £3,500,000 and the investments from time to time representing the same.
    Personnes ayant droit
    • Axa Insurance PLC
    Transactions
    • 25 févr. 2003Enregistrement d'une charge (395)
    • 10 mai 2004Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Deed of charge
    Créé le 01 sept. 2000
    Livré le 05 sept. 2000
    Partiellement satisfaite
    Montant garanti
    The principal of and interest on the £3,000,000 12.4% first mortgage debenture stock 2008 and the £18,000,000 11.25% first mortgage debenture stock of estates & general PLC and all other monies intended to be secured by the deed and deeds supplemental thereto
    Brèves mentions
    F/H land at lower end chorleywood t/n HD190157 together with all buildings and erections fixtures and fittings fixed plant and machinery and all improvements and additions thereto.
    Personnes ayant droit
    • Axa Insurance PLC
    Transactions
    • 05 sept. 2000Enregistrement d'une charge (395)
    • 10 mai 2004Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Supplemental debenture
    Créé le 24 août 1998
    Livré le 25 août 1998
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee as security trustee for the secured parties (as defined in the composite guarantee and mortgage debenture), the payment and discharge of which are the subject of covenants, undertakings, guarnatees, and agreements contained in the composite guarantee and mortgage debenture and the supplemental debenture
    Brèves mentions
    (A) all moneys whether principal or interest owing now and/or from time to time on the security of the legal mortgage dated 24TH september 1991 between (1) ka-ar construction limited and (2) estates & general PLC ("the mortgage") and the benefit of the mortgage (unless the mortgage was effected by demise or sub-demise) and any other securities at any time held by the mortgagor for the mortgage debt to hold to the security trustee absolutely subject to the proviso for redemption contained in the supplemental debenture;. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • National Westminster Bank PLC
    Transactions
    • 25 août 1998Enregistrement d'une charge (395)
    • 10 mai 2004Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Deed of release and substitution
    Créé le 23 déc. 1997
    Livré le 08 janv. 1998
    En cours
    Montant garanti
    The principal of and interest on the £3,000,000 12.4 per cent. First mortgage debenture stock 2008 and on the £18,000,000 11.25 per cent. First mortgage debenture stock 2018 of estates & general PLC and all other moneys intended to be secured by the above deed and deeds dated 21.12.83, 23.8.85, 10.9.85, 14.5.86, 27.4.87, 28.4.87, 22.2.89, 26.6.91, 12.7.91, 11.11.91, 15.1.93, 10.8.93, 13.8.93, 15.9.93, 3.3.95, 23.6.95 and 26.11.97 to which it is supplemental
    Brèves mentions
    Freehold 25 to 35 (odd numbers) castle way, southampton title number hp 101820; leasehold the tontines shopping centre hanley title number sf 286975; freehold manfield park guildford road cranleigh title number sy 488061; freehold land at lower end chorleywood title number hd 190157; freehold 69/70 high street, thame title number on 59401; freehold property at prebendal court oxford road aylesbury buckinghamshire and all buildings, erections, fixtures, fittings, fixed plant and machinery, all improvements, additions, benefit of all leases, underleases, tenancies, agreements for lease, rights, covenants, and conditions.
    Personnes ayant droit
    • Guardian Royal Exchange Assurance PLC
    Transactions
    • 08 janv. 1998Enregistrement d'une charge (395)
    • 28 mars 2002Déclaration que tout ou partie de la propriété d'une charge flottante a été libérée (403b)
    • 10 mai 2004Déclaration que tout ou partie de la propriété d'une charge flottante a été libérée (403b)
    Letter of pledge
    Créé le 23 janv. 1997
    Livré le 06 févr. 1997
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Undertaking and all property and assets present and future including uncalled capital. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transactions
    • 06 févr. 1997Enregistrement d'une charge (395)
    • 02 juil. 1998Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Fourth supplemental trust deed
    Créé le 15 sept. 1993
    Livré le 24 sept. 1993
    En cours
    Montant garanti
    £3,000,000 12.4% first mortgage debenture stock 2008 and the £18,000,000 11.25% first mortgage debenture stock 2018 of estates & general PLC and all other moneys intended to be secured by the above deed and the existing deeds (as defined)
    Brèves mentions
    See form 395. undertaking and all property and assets present and future including uncalled capital.
    Personnes ayant droit
    • Guardian Royal Exchange Assurance PLC
    Transactions
    • 24 sept. 1993Enregistrement d'une charge (395)
    • 14 déc. 1996Déclaration que tout ou partie de la propriété d'une charge flottante a été libérée (403b)
    • 210 févr. 2011Nomination d'un administrateur ou d'un gestionnaire (LQ01)
    • 210 juin 2014Avis de cessation d'exercer en tant qu'administrateur ou gestionnaire (RM02)
    • 210 juin 2014Nomination d'un administrateur ou d'un gestionnaire (RM01)
      • Numéro de dossier 2
    Composite guarantee and mortgage debenture
    Créé le 04 août 1992
    Livré le 19 août 1992
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the debenture and the security constituted thereby
    Brèves mentions
    (For full details of charge see form 395 and contd sheets for full details). Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personnes ayant droit
    • National Westminster Bank PLC as Security Trustee for Itself as a Secured Party and for the Banks (All as Defined)
    Transactions
    • 19 août 1992Enregistrement d'une charge (395)
    • 28 mars 2002Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Legal charge
    Créé le 30 juil. 1992
    Livré le 14 août 1992
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee pursuant to the charge
    Brèves mentions
    Prebendal court, oxford road, aylesbury, bucks.
    Personnes ayant droit
    • Commerzbank Ag
    Transactions
    • 14 août 1992Enregistrement d'une charge (395)
    • 28 mars 2002Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Sub-mortgage
    Créé le 07 févr. 1992
    Livré le 11 févr. 1992
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from crosstyle PLC to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    17 high street, thame t/n-DN126205.
    Personnes ayant droit
    • Lloyds Bank PLC
    Transactions
    • 11 févr. 1992Enregistrement d'une charge (395)
    • 14 déc. 1996Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Sub-mortgage
    Créé le 07 févr. 1992
    Livré le 11 févr. 1992
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from crosstyle PLC to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    40 lower icknield way, chinnor t/n-ON112789.
    Personnes ayant droit
    • Lloyds Bank PLC
    Transactions
    • 11 févr. 1992Enregistrement d'une charge (395)
    • 28 mars 2002Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Sub-mortgae
    Créé le 07 févr. 1992
    Livré le 11 févr. 1992
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from crosstyle PLC to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    "Troutbeck", 31 wyatts road, choleywood, t/n-HD184877.
    Personnes ayant droit
    • Lloyds Bank PLC
    Transactions
    • 11 févr. 1992Enregistrement d'une charge (395)
    • 28 mars 2002Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Sub-mortgage
    Créé le 07 févr. 1992
    Livré le 11 févr. 1992
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from crosstyle PLC to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    10/12 temple end, high wycombe t/n-BM123266.
    Personnes ayant droit
    • Lloyds Bank PLC
    Transactions
    • 11 févr. 1992Enregistrement d'une charge (395)
    • 28 mars 2002Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Sub-mortgage
    Créé le 07 févr. 1992
    Livré le 11 févr. 1992
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from crosstyle PLC to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Unit 1, triangle business park, wendover road, stock mandeville, buckinghamshire.
    Personnes ayant droit
    • Lloyds Bank PLC
    Transactions
    • 11 févr. 1992Enregistrement d'une charge (395)
    • 10 juin 1995Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Subcharge
    Créé le 24 déc. 1991
    Livré le 31 déc. 1991
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    40 lower icknield way chinnor oxfordshire t/n-ON112789.
    Personnes ayant droit
    • Lloyds Bank PLC
    Transactions
    • 31 déc. 1991Enregistrement d'une charge (395)
    • 10 juin 1995Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Subcharge
    Créé le 24 déc. 1991
    Livré le 31 déc. 1991
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    17 high street, thame oxfordshire t/n ON126205.
    Personnes ayant droit
    • Lloyds Bank PLC
    Transactions
    • 31 déc. 1991Enregistrement d'une charge (395)
    • 10 juin 1995Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Subcharge
    Créé le 24 déc. 1991
    Livré le 31 déc. 1991
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Property k/a "troutbeck", 31 wyatts road chorleywood hertfordshire t/n-HD184877.
    Personnes ayant droit
    • Lloyds Bank PLC
    Transactions
    • 31 déc. 1991Enregistrement d'une charge (395)
    • 10 juin 1995Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Subcharge
    Créé le 24 déc. 1991
    Livré le 31 déc. 1991
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    10-12 temple end, high wycombe, buckinghamshire t/n-BM123266.
    Personnes ayant droit
    • Lloyds Bank PLC
    Transactions
    • 31 déc. 1991Enregistrement d'une charge (395)
    • 10 juin 1995Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Deed of release & substitution
    Créé le 12 juil. 1991
    Livré le 16 juil. 1991
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee
    Brèves mentions
    £1,200,000 & the investments from time to time.
    Personnes ayant droit
    • Guardian Royal Exchange Assuarance PLC
    Transactions
    • 16 juil. 1991Enregistrement d'une charge
    • 10 juin 1995Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Deed of release & substitution
    Créé le 26 juin 1991
    Livré le 04 juil. 1991
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee
    Brèves mentions
    £1,104,000 & the investments for the timebeing.
    Personnes ayant droit
    • Guardian Royal Exchange Assuarance PLC
    Transactions
    • 04 juil. 1991Enregistrement d'une charge
    • 10 juin 1995Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Letter confirming deposit of deeds by way of equitable mortgage
    Créé le 02 nov. 1990
    Livré le 08 nov. 1990
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of this charge
    Brèves mentions
    Prebendal court, oxford road, alesbury, buckinghamshire.
    Personnes ayant droit
    • Commerzbank A.G
    Transactions
    • 08 nov. 1990Enregistrement d'une charge
    • 22 août 1992Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Equitable charge without written instrument
    Créé le 14 févr. 1990
    Livré le 02 mars 1990
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee pursuant to a letter dated 14/2/90
    Brèves mentions
    1) fund lying to teh south-west of sunderland avenue bowerhill melksham wilkshire title no wt 72820 2) all that estate right title and interest as is owned by by county & surburbon properties limited in the land at outmarsh railway farm semington trowbridge wiltshire.
    Personnes ayant droit
    • Midland Bank PLC
    Transactions
    • 02 mars 1990Enregistrement d'une charge
    • 10 juin 1995Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    General charge
    Créé le 08 nov. 1989
    Livré le 20 nov. 1989
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Specific equitable charge ovoer all the company's estates or interests in any f/h or l/h property now or at any time belonging to or charged to the company and/or the proceedsd of sale thereof.
    Personnes ayant droit
    • National Westminster Bank PLC
    Transactions
    • 20 nov. 1989Enregistrement d'une charge
    • 15 févr. 1992Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)

    ESTATES & GENERAL LIMITED a-t-elle des procédures d'insolvabilité ?

    Numéro de dossierDatesTypePraticiensAutre
    1
    DateType
    21 janv. 2011Commencement of winding up
    26 juin 2022Dissolved on
    Creditors voluntary liquidation
    NomRôleAdresseNommé leCessé le
    Kirstie Jane Provan
    32 Cornhill
    EC3V 3BT London
    practitioner
    32 Cornhill
    EC3V 3BT London
    Mark Robert Fry
    Begbies Traynor Central Llp
    32 Cornhill
    EC3V 3BT London
    practitioner
    Begbies Traynor Central Llp
    32 Cornhill
    EC3V 3BT London
    2Administrative receiver appointed
    NomRôleAdresseNommé leCessé le
    Nicholas Guy Edwards
    Deloitte Llp Po Box 810 66 Shoe Lane
    EC4A 3WA London
    receiver manager
    Deloitte Llp Po Box 810 66 Shoe Lane
    EC4A 3WA London
    Louise Mary Brittain
    Po Box 810 66 Shoe Lane
    EC4A 3WA London
    receiver manager
    Po Box 810 66 Shoe Lane
    EC4A 3WA London
    Lee Antony Manning
    Athene Place 66 Shoe Lane
    EC4A 3BQ London
    administrative receiver
    Athene Place 66 Shoe Lane
    EC4A 3BQ London

    Source de données

    • Companies House du Royaume-Uni
      Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers.
    • Licence: CC0