TRAFALGAR HOUSE FINANCE LTD

  • Vue d'ensemble
  • Résumé
  • Objet social
  • Adresse
  • Dénominations sociales précédentes
  • Comptes
  • Déclaration de confirmation
  • Bilan annuel
  • Dépôts
  • Dirigeants
  • Charges
  • Insolvabilité
  • Source de données
  • Vue d'ensemble

    Nom de la sociétéTRAFALGAR HOUSE FINANCE LTD
    Statut de la sociétéLiquidation
    Forme juridiqueSociété à responsabilité limitée
    Numéro de société 00055100
    JuridictionAngleterre/Pays de Galles
    Date de création

    Résumé

    A des PSCs super sécurisésNon
    A des chargesOui
    A un historique d'insolvabilitéOui
    Le siège social est contestéNon

    Quel est l'objet de TRAFALGAR HOUSE FINANCE LTD ?

    • Intermédiation financière n.c.a. (64999) / Activités financières et d'assurance

    Où se situe TRAFALGAR HOUSE FINANCE LTD ?

    Adresse du siège social
    Forvis Mazars Llp
    30 Old Bailey
    EC4M 7AU London
    Adresse du siège social non livrableNon

    Quels étaient les noms précédents de TRAFALGAR HOUSE FINANCE LTD ?

    Dénominations sociales précédentes
    Nom de la sociétéDeJusqu'au
    TRAFALGAR HOUSE GROUP FINANCE PLC04 juil. 198604 juil. 1986
    CITY AND WEST END PROPERTIES,LIMITED03 déc. 189703 déc. 1897

    Quels sont les derniers comptes de TRAFALGAR HOUSE FINANCE LTD ?

    En retardOui
    Prochains comptes
    Fin de la prochaine période comptable le31 déc. 2013
    Date d'échéance des prochains comptes30 sept. 2014
    Derniers comptes
    Derniers comptes arrêtés au31 déc. 2012

    Quel est le statut de la dernière déclaration de confirmation pour TRAFALGAR HOUSE FINANCE LTD ?

    En retardOui
    Dernière déclaration de confirmation établie jusqu'au02 avr. 2017
    Date d'échéance de la prochaine déclaration de confirmation16 avr. 2017
    En retardOui

    Quel est le statut du dernier bilan annuel pour TRAFALGAR HOUSE FINANCE LTD ?

    Bilan annuel
    Dernier bilan annuel
    En retardOui

    Quels sont les derniers dépôts pour TRAFALGAR HOUSE FINANCE LTD ?

    Dépôts
    DateDescriptionDocumentType

    Déclaration des reçus et paiements des liquidateurs jusqu'à 10 déc. 2025

    30 pagesLIQ03

    Déclaration des reçus et paiements des liquidateurs jusqu'à 10 déc. 2024

    13 pagesLIQ03

    Changement d'adresse du siège social de 30 Old Bailey London EC4M 7AU à Forvis Mazars Llp 30 Old Bailey London EC4M 7AU le 26 juil. 2024

    3 pagesAD01

    Déclaration des reçus et paiements des liquidateurs jusqu'à 10 déc. 2023

    12 pagesLIQ03

    Déclaration des reçus et paiements des liquidateurs jusqu'à 10 déc. 2022

    11 pagesLIQ03

    Changement d'adresse du siège social de Tower Bridge House St Katharines Way London E1W 1DD à 30 Old Bailey London EC4M 7AU le 11 mai 2022

    2 pagesAD01

    Nomination d'un liquidateur volontaire

    3 pages600

    Révocation du liquidateur par ordonnance du tribunal

    16 pagesLIQ10

    Déclaration des reçus et paiements des liquidateurs jusqu'à 10 déc. 2021

    10 pagesLIQ03

    Déclaration des reçus et paiements des liquidateurs jusqu'à 10 déc. 2020

    10 pagesLIQ03

    Déclaration des reçus et paiements des liquidateurs jusqu'à 10 déc. 2019

    11 pagesLIQ03

    Déclaration des reçus et paiements des liquidateurs jusqu'à 10 déc. 2018

    15 pagesLIQ03

    Déclaration des reçus et paiements des liquidateurs jusqu'à 10 déc. 2017

    14 pagesLIQ03

    Déclaration des reçus et paiements des liquidateurs jusqu'à 10 déc. 2016

    11 pages4.68

    Ordonnance du tribunal d'insolvabilité

    Court order INSOLVENCY:re block transfer replacement of liq
    28 pagesLIQ MISC OC

    Nomination d'un liquidateur volontaire

    2 pages600

    Avis de cessation d'agir en tant que liquidateur volontaire

    1 pages4.40

    Déclaration des reçus et paiements des liquidateurs jusqu'à 10 déc. 2015

    7 pages4.68

    Nomination d'un liquidateur volontaire

    2 pages600

    Ordonnance du tribunal d'insolvabilité

    Court order INSOLVENCY:replacement of liquidator
    10 pagesLIQ MISC OC

    Avis de cessation d'agir en tant que liquidateur volontaire

    1 pages4.40

    Changement d'adresse du siège social de Surrey House 36-44 High Street Redhill Surrey RH1 1RH à Tower Bridge House St Katharines Way London E1W 1DD le 22 déc. 2014

    1 pagesAD01

    Déclaration des affaires avec le formulaire 4.19 attaché

    6 pages4.20

    Nomination d'un liquidateur volontaire

    1 pages600

    Résolutions

    Resolutions
    1 pagesRESOLUTIONS
    Résolutions
    CatégorieDateDescriptionType
    liquidation

    Résolution extraordinaire pour la liquidation au 11 déc. 2014

    LRESEX

    Qui sont les dirigeants de TRAFALGAR HOUSE FINANCE LTD ?

    Dirigeants
    NomNommé leDate de démissionRôleAdresseIdentification de la sociétéPays de résidenceNationalitéDate de naissanceProfessionNuméro
    LAYCOCK, Rufus
    30 Old Bailey
    EC4M 7AU London
    Forvis Mazars Llp
    Secrétaire
    30 Old Bailey
    EC4M 7AU London
    Forvis Mazars Llp
    British7584610001
    LAYCOCK, Rufus
    30 Old Bailey
    EC4M 7AU London
    Forvis Mazars Llp
    Administrateur
    30 Old Bailey
    EC4M 7AU London
    Forvis Mazars Llp
    United KingdomBritish7584610002
    NILSEN, Runar
    30 Old Bailey
    EC4M 7AU London
    Forvis Mazars Llp
    Administrateur
    30 Old Bailey
    EC4M 7AU London
    Forvis Mazars Llp
    Norwegian102391880002
    PEATE, Roland Duncan
    87 Bennetts Way
    Shirley
    CR0 8AG Croydon
    Surrey
    Secrétaire
    87 Bennetts Way
    Shirley
    CR0 8AG Croydon
    Surrey
    British7628800001
    ANSDELL, John Reginald Wardhaugh
    17 Randolph Avenue
    W9 1BH London
    Administrateur
    17 Randolph Avenue
    W9 1BH London
    British5094500001
    CHARLTON, John Michael
    Dunstone
    5 Broomfield Ride
    KT22 0LR Oxshott
    Surrey
    Administrateur
    Dunstone
    5 Broomfield Ride
    KT22 0LR Oxshott
    Surrey
    EnglandBritish73081460001
    COOMBS, Thomas Brian
    22 Glebe Hyrst
    Sanderstead
    CR2 9JE South Croydon
    Surrey
    Administrateur
    22 Glebe Hyrst
    Sanderstead
    CR2 9JE South Croydon
    Surrey
    British8207220001
    FARSTAD, Atle
    2 Burges Grove
    SW13 8BG London
    Administrateur
    2 Burges Grove
    SW13 8BG London
    Norwegian50057960002
    FOSSE, Finn Erik
    5 Orchard Lane
    SW20 0SE London
    Administrateur
    5 Orchard Lane
    SW20 0SE London
    Norwegian118721520001
    FOSTER, Michael George
    Hazeldene Chalet Close
    HP4 3NA Berkhamsted
    Hertfordshire
    Administrateur
    Hazeldene Chalet Close
    HP4 3NA Berkhamsted
    Hertfordshire
    British44786890001
    FOWLER, Ian
    32 Newton Road
    W2 5LT London
    Administrateur
    32 Newton Road
    W2 5LT London
    British41294100001
    GAWLER, David
    76 Park Road
    TW12 1HP Hampton Hill
    Middlesex
    Administrateur
    76 Park Road
    TW12 1HP Hampton Hill
    Middlesex
    United KingdomSouth African167282630001
    GRANT-DUFF, Andrew Martin
    43 Budgen Drive
    The Frenches
    RH1 2QB Redhill
    Surrey
    Administrateur
    43 Budgen Drive
    The Frenches
    RH1 2QB Redhill
    Surrey
    British27431010001
    HEGGELUND, Jan Magne
    126 Silverdale Avenue
    KT12 1EH Walton On Thames
    Surrey
    Administrateur
    126 Silverdale Avenue
    KT12 1EH Walton On Thames
    Surrey
    British67742180002
    KJAERVIK, Jan Bjorn
    Kastellbukken 13b
    FOREIGN Oslo
    1162
    Norway
    Administrateur
    Kastellbukken 13b
    FOREIGN Oslo
    1162
    Norway
    Norwegian85020310001
    MCLUSKIE, William Grindlay
    17 Pinfield Drive
    Barnt Green
    B45 8XA Birmingham
    West Midlands
    Administrateur
    17 Pinfield Drive
    Barnt Green
    B45 8XA Birmingham
    West Midlands
    British25437700001
    MISUND, Anders
    12 Palace Garden Mews
    W8 London
    Administrateur
    12 Palace Garden Mews
    W8 London
    Norwegian105847420002
    MUSGRAVE, Ian Crossley
    52 Spencer Close
    Regents Park Road
    N3 3TY London
    Administrateur
    52 Spencer Close
    Regents Park Road
    N3 3TY London
    British19349240001
    RILEY, John Edward
    46 Meadow Rise
    Blackmore
    CM4 0QY Ingatestone
    Essex
    Administrateur
    46 Meadow Rise
    Blackmore
    CM4 0QY Ingatestone
    Essex
    British27431020001
    ROQUE PEREIRA, Marcelo
    273 Ladbroke Grove
    W10 6HF London
    Basement Flat
    Administrateur
    273 Ladbroke Grove
    W10 6HF London
    Basement Flat
    United KingdomPortuguese134678420003
    ROSS, John
    32 Woodchester Park
    Knotty Green
    HP9 2TU Beaconsfield
    Buckinghamshire
    Administrateur
    32 Woodchester Park
    Knotty Green
    HP9 2TU Beaconsfield
    Buckinghamshire
    British40603910001
    ROSS, Stuart
    15 Mckay Road
    SW20 0HT London
    Administrateur
    15 Mckay Road
    SW20 0HT London
    EnglandBritish20168110001
    SHASHA, John David
    16 Queensmill Road
    SW6 6JS London
    Administrateur
    16 Queensmill Road
    SW6 6JS London
    British8207240001
    SHIELDS, Geoffrey Brian
    74 Doneraile Street
    SW6 6EP London
    Administrateur
    74 Doneraile Street
    SW6 6EP London
    EnglandBritish27431030002
    SIVERTSEN, Ole Kristian
    48 Ashley Park Avenue
    KT12 1ES Walton On Thames
    Surrey
    Administrateur
    48 Ashley Park Avenue
    KT12 1ES Walton On Thames
    Surrey
    Norwegian78676780001
    SVANEVIK, Orjan
    Baldersgate 10
    FOREIGN Oslo
    0263
    Norway
    Administrateur
    Baldersgate 10
    FOREIGN Oslo
    0263
    Norway
    Norwegian96318550001
    WESTLIE, Trond
    Ruglandveien 30
    FOREIGN N-1358 Jar
    Norway
    Administrateur
    Ruglandveien 30
    FOREIGN N-1358 Jar
    Norway
    Norwegian80796320001
    WOODS, Roanld Ernest
    All Seasons House
    Sterlings Field
    SL6 9PG Cookham Dean
    Berkshire
    Administrateur
    All Seasons House
    Sterlings Field
    SL6 9PG Cookham Dean
    Berkshire
    British82090400001

    TRAFALGAR HOUSE FINANCE LTD a-t-elle des charges ?

    Charges
    ClassificationDatesStatutDétails
    A sixth supplemental trust deed dated 15TH november 2000 between the company, kvaerner PLC (the "issuer" ) and the law debenture trust corporation P.L.C.
    Créé le 15 nov. 2000
    Livré le 16 nov. 2000
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All obligations of kvaerner PLC (as issuer) to the chargee under or pursuant to the subsisting trust deeds and the supplemental trust deed present or future, actual or contingent including the payment of principal of and interest on the outstanding stock and all other monies covenanted to be paid by the issuer to the chargee under the subsisting trust deeds and supplemental trust deeds
    Brèves mentions
    All the company's right title benefit and interest in the initial amount of £6,622,945.67 and the deposit being the credit balance on any account to which all or any part of the initial amount may be credited from time to time (or any renewal or redesignation thereof) and all rights benefits and proceeds in respect thereof.
    Personnes ayant droit
    • The Law Debenture Corporation (As Trustee)
    Transactions
    • 16 nov. 2000Enregistrement d'une charge (395)
    • 21 août 2001Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    An eighth supplemental trust deed dated 15TH november 2000 between the company, kvaerner PLC (the "issuer" ) and the law debenture trust corporation P.L.C.
    Créé le 15 nov. 2000
    Livré le 16 nov. 2000
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All obligations of kvaerner PLC (as issuer) to the chargee under or pursuant to the subsisting trust deeds and the supplemental trust deed present or future, actual or contingent including the payment of principal of and interest on the outstanding stock and all other monies covenanted to be paid by the issuer to the chargee in respect of the external bonds under the subsisting trust deeds and supplemental trust deeds
    Brèves mentions
    All the company's right title benefit and interest in the initial amount of £1,227,746.54 and the deposit being the credit balance on any account to which all or any part of the initial amount may be credited from time to time (or any renewal or redesignation thereof) and all rights benefits and proceeds in respect thereof.
    Personnes ayant droit
    • The Law Debenture Corporation (As Trustee)
    Transactions
    • 16 nov. 2000Enregistrement d'une charge (395)
    • 21 août 2001Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    A sixth supplemental trust deed dated 15TH november 2000 between the company, kvaerner PLC (the "issuer" ) and the law debenture trust corporation P.L.C.
    Créé le 15 nov. 2000
    Livré le 16 nov. 2000
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All obligations of kvaerner PLC (as issuer) to the chargee under or pursuant to the subsisting trust deeds and the supplemental trust deed present or future, actual or contingent including the payment of principal of and interest on the outstanding stock and all other monies covenanted to be paid by the issuer to the chargee in respect of the external bonds under the subsisting trust deeds and supplemental trust deeds
    Brèves mentions
    All the company's right title benefit and interest in the initial amount of £5,879,034.33 and the deposit being the credit balance on any account to which all or any part of the initial amount may be credited from time to time (or any renewal or redesignation thereof) and all rights benefits and proceeds in respect thereof.
    Personnes ayant droit
    • The Law Debenture Corporation (As Trustee)
    Transactions
    • 16 nov. 2000Enregistrement d'une charge (395)
    • 16 janv. 2002Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    A fourth supplemental trust deed dated 15TH november 2000 between the company, kvaerner PLC (the "issuer" ) and the law debenture trust corporation P.L.C.
    Créé le 15 nov. 2000
    Livré le 16 nov. 2000
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All obligations of kvaerner PLC (as issuer) to the chargee under or pursuant to the subsisting trust deeds and the supplemental trust deed present or future, actual or contingent including the payment of principal of and interest on the external bonds and all other monies covenanted to be paid by the issuer to the chargee in respect of the external bonds under the subsisting trust deeds and supplemental trust deeds excluding any obligations of the issuer in respect of payment of principal and interest on the kvaerner bonds
    Brèves mentions
    All the company's right title benefit and interest in and to the initial amount of £12,736,708.88 and the deposit being the credit balance on any account to which all or any of part of the initial deposit may be credited from time to time (and any renewal or redesignation thereof) and all rights benefits and proceeds in respect thereof.
    Personnes ayant droit
    • The Law Debenture Trust Corporation (As Trustee)
    Transactions
    • 16 nov. 2000Enregistrement d'une charge (395)
    • 21 août 2001Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Legal charge
    Créé le 15 janv. 1982
    Livré le 28 janv. 1982
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company and/or trafalgar house limited to the chargee on any account whatsoever pursuant to a facility letter dated 23.3.78
    Brèves mentions
    L/Hold bush lane housse, 80, cannon street, london EC4 title no ngl 337827.
    Personnes ayant droit
    • Barclays Bank PLC
    Transactions
    • 28 janv. 1982Enregistrement d'une charge
    Mortgage
    Créé le 05 mars 1952
    Livré le 18 mars 1952
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    £90,000
    Brèves mentions
    1-18 station buildings new bridge stree t london.
    Personnes ayant droit
    • North British Ad Mercantile Insurance Company Limited
    Transactions
    • 18 mars 1952Enregistrement d'une charge

    TRAFALGAR HOUSE FINANCE LTD a-t-elle des procédures d'insolvabilité ?

    Numéro de dossierDatesTypePraticiensAutre
    1
    DateType
    11 déc. 2014Commencement of winding up
    Creditors voluntary liquidation
    NomRôleAdresseNommé leCessé le
    Adam Harris
    Tower Bridge House St Katherines Way
    E1W 1DD London
    practitioner
    Tower Bridge House St Katherines Way
    E1W 1DD London
    Guy Robert Thomas Hollander
    Tower Bridge House St Katharine S Way
    E1W 1DD London
    practitioner
    Tower Bridge House St Katharine S Way
    E1W 1DD London
    Michael James Wellard
    Tower Bridge House St Katharines Way
    E1W 1DD London
    practitioner
    Tower Bridge House St Katharines Way
    E1W 1DD London
    Roderick John Weston
    Mazars Llp Tower Bridge House
    St Katharines Way
    E1W 1DD London
    practitioner
    Mazars Llp Tower Bridge House
    St Katharines Way
    E1W 1DD London
    Neil John Mather
    Tower Bridge House St Katharines Way
    E1W 1DD London
    practitioner
    Tower Bridge House St Katharines Way
    E1W 1DD London

    Source de données

    • Companies House du Royaume-Uni
      Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers.
    • Licence: CC0