TRAFALGAR HOUSE FINANCE LTD
Vue d'ensemble
| Nom de la société | TRAFALGAR HOUSE FINANCE LTD |
|---|---|
| Statut de la société | Liquidation |
| Forme juridique | Société à responsabilité limitée |
| Numéro de société | 00055100 |
| Juridiction | Angleterre/Pays de Galles |
| Date de création |
Résumé
| A des PSCs super sécurisés | Non |
|---|---|
| A des charges | Oui |
| A un historique d'insolvabilité | Oui |
| Le siège social est contesté | Non |
Où se situe TRAFALGAR HOUSE FINANCE LTD ?
| Adresse du siège social | Forvis Mazars Llp 30 Old Bailey EC4M 7AU London |
|---|---|
| Adresse du siège social non livrable | Non |
Quels sont les derniers comptes de TRAFALGAR HOUSE FINANCE LTD ?
| En retard | Oui |
|---|---|
| Prochains comptes | |
| Fin de la prochaine période comptable le | 31 déc. 2013 |
| Date d'échéance des prochains comptes | 30 sept. 2014 |
| Derniers comptes | |
| Derniers comptes arrêtés au | 31 déc. 2012 |
Quel est le statut de la dernière déclaration de confirmation pour TRAFALGAR HOUSE FINANCE LTD ?
| En retard | Oui |
|---|---|
| Dernière déclaration de confirmation établie jusqu'au | 02 avr. 2017 |
| Date d'échéance de la prochaine déclaration de confirmation | 16 avr. 2017 |
| En retard | Oui |
Quel est le statut du dernier bilan annuel pour TRAFALGAR HOUSE FINANCE LTD ?
| Bilan annuel |
|
|---|
Quels sont les derniers dépôts pour TRAFALGAR HOUSE FINANCE LTD ?
| Date | Description | Document | Type | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Déclaration des reçus et paiements des liquidateurs jusqu'à 10 déc. 2025 | 30 pages | LIQ03 | ||||||||||
Déclaration des reçus et paiements des liquidateurs jusqu'à 10 déc. 2024 | 13 pages | LIQ03 | ||||||||||
Changement d'adresse du siège social de 30 Old Bailey London EC4M 7AU à Forvis Mazars Llp 30 Old Bailey London EC4M 7AU le 26 juil. 2024 | 3 pages | AD01 | ||||||||||
Déclaration des reçus et paiements des liquidateurs jusqu'à 10 déc. 2023 | 12 pages | LIQ03 | ||||||||||
Déclaration des reçus et paiements des liquidateurs jusqu'à 10 déc. 2022 | 11 pages | LIQ03 | ||||||||||
Changement d'adresse du siège social de Tower Bridge House St Katharines Way London E1W 1DD à 30 Old Bailey London EC4M 7AU le 11 mai 2022 | 2 pages | AD01 | ||||||||||
Nomination d'un liquidateur volontaire | 3 pages | 600 | ||||||||||
Révocation du liquidateur par ordonnance du tribunal | 16 pages | LIQ10 | ||||||||||
Déclaration des reçus et paiements des liquidateurs jusqu'à 10 déc. 2021 | 10 pages | LIQ03 | ||||||||||
Déclaration des reçus et paiements des liquidateurs jusqu'à 10 déc. 2020 | 10 pages | LIQ03 | ||||||||||
Déclaration des reçus et paiements des liquidateurs jusqu'à 10 déc. 2019 | 11 pages | LIQ03 | ||||||||||
Déclaration des reçus et paiements des liquidateurs jusqu'à 10 déc. 2018 | 15 pages | LIQ03 | ||||||||||
Déclaration des reçus et paiements des liquidateurs jusqu'à 10 déc. 2017 | 14 pages | LIQ03 | ||||||||||
Déclaration des reçus et paiements des liquidateurs jusqu'à 10 déc. 2016 | 11 pages | 4.68 | ||||||||||
Ordonnance du tribunal d'insolvabilité Court order INSOLVENCY:re block transfer replacement of liq | 28 pages | LIQ MISC OC | ||||||||||
Nomination d'un liquidateur volontaire | 2 pages | 600 | ||||||||||
Avis de cessation d'agir en tant que liquidateur volontaire | 1 pages | 4.40 | ||||||||||
Déclaration des reçus et paiements des liquidateurs jusqu'à 10 déc. 2015 | 7 pages | 4.68 | ||||||||||
Nomination d'un liquidateur volontaire | 2 pages | 600 | ||||||||||
Ordonnance du tribunal d'insolvabilité Court order INSOLVENCY:replacement of liquidator | 10 pages | LIQ MISC OC | ||||||||||
Avis de cessation d'agir en tant que liquidateur volontaire | 1 pages | 4.40 | ||||||||||
Changement d'adresse du siège social de Surrey House 36-44 High Street Redhill Surrey RH1 1RH à Tower Bridge House St Katharines Way London E1W 1DD le 22 déc. 2014 | 1 pages | AD01 | ||||||||||
Déclaration des affaires avec le formulaire 4.19 attaché | 6 pages | 4.20 | ||||||||||
Nomination d'un liquidateur volontaire | 1 pages | 600 | ||||||||||
Résolutions Resolutions | 1 pages | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
Qui sont les dirigeants de TRAFALGAR HOUSE FINANCE LTD ?
| Nom | Nommé le | Date de démission | Rôle | Adresse | Identification de la société | Pays de résidence | Nationalité | Date de naissance | Profession | Numéro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LAYCOCK, Rufus | Secrétaire | 30 Old Bailey EC4M 7AU London Forvis Mazars Llp | British | 7584610001 | ||||||
| LAYCOCK, Rufus | Administrateur | 30 Old Bailey EC4M 7AU London Forvis Mazars Llp | United Kingdom | British | 7584610002 | |||||
| NILSEN, Runar | Administrateur | 30 Old Bailey EC4M 7AU London Forvis Mazars Llp | Norwegian | 102391880002 | ||||||
| PEATE, Roland Duncan | Secrétaire | 87 Bennetts Way Shirley CR0 8AG Croydon Surrey | British | 7628800001 | ||||||
| ANSDELL, John Reginald Wardhaugh | Administrateur | 17 Randolph Avenue W9 1BH London | British | 5094500001 | ||||||
| CHARLTON, John Michael | Administrateur | Dunstone 5 Broomfield Ride KT22 0LR Oxshott Surrey | England | British | 73081460001 | |||||
| COOMBS, Thomas Brian | Administrateur | 22 Glebe Hyrst Sanderstead CR2 9JE South Croydon Surrey | British | 8207220001 | ||||||
| FARSTAD, Atle | Administrateur | 2 Burges Grove SW13 8BG London | Norwegian | 50057960002 | ||||||
| FOSSE, Finn Erik | Administrateur | 5 Orchard Lane SW20 0SE London | Norwegian | 118721520001 | ||||||
| FOSTER, Michael George | Administrateur | Hazeldene Chalet Close HP4 3NA Berkhamsted Hertfordshire | British | 44786890001 | ||||||
| FOWLER, Ian | Administrateur | 32 Newton Road W2 5LT London | British | 41294100001 | ||||||
| GAWLER, David | Administrateur | 76 Park Road TW12 1HP Hampton Hill Middlesex | United Kingdom | South African | 167282630001 | |||||
| GRANT-DUFF, Andrew Martin | Administrateur | 43 Budgen Drive The Frenches RH1 2QB Redhill Surrey | British | 27431010001 | ||||||
| HEGGELUND, Jan Magne | Administrateur | 126 Silverdale Avenue KT12 1EH Walton On Thames Surrey | British | 67742180002 | ||||||
| KJAERVIK, Jan Bjorn | Administrateur | Kastellbukken 13b FOREIGN Oslo 1162 Norway | Norwegian | 85020310001 | ||||||
| MCLUSKIE, William Grindlay | Administrateur | 17 Pinfield Drive Barnt Green B45 8XA Birmingham West Midlands | British | 25437700001 | ||||||
| MISUND, Anders | Administrateur | 12 Palace Garden Mews W8 London | Norwegian | 105847420002 | ||||||
| MUSGRAVE, Ian Crossley | Administrateur | 52 Spencer Close Regents Park Road N3 3TY London | British | 19349240001 | ||||||
| RILEY, John Edward | Administrateur | 46 Meadow Rise Blackmore CM4 0QY Ingatestone Essex | British | 27431020001 | ||||||
| ROQUE PEREIRA, Marcelo | Administrateur | 273 Ladbroke Grove W10 6HF London Basement Flat | United Kingdom | Portuguese | 134678420003 | |||||
| ROSS, John | Administrateur | 32 Woodchester Park Knotty Green HP9 2TU Beaconsfield Buckinghamshire | British | 40603910001 | ||||||
| ROSS, Stuart | Administrateur | 15 Mckay Road SW20 0HT London | England | British | 20168110001 | |||||
| SHASHA, John David | Administrateur | 16 Queensmill Road SW6 6JS London | British | 8207240001 | ||||||
| SHIELDS, Geoffrey Brian | Administrateur | 74 Doneraile Street SW6 6EP London | England | British | 27431030002 | |||||
| SIVERTSEN, Ole Kristian | Administrateur | 48 Ashley Park Avenue KT12 1ES Walton On Thames Surrey | Norwegian | 78676780001 | ||||||
| SVANEVIK, Orjan | Administrateur | Baldersgate 10 FOREIGN Oslo 0263 Norway | Norwegian | 96318550001 | ||||||
| WESTLIE, Trond | Administrateur | Ruglandveien 30 FOREIGN N-1358 Jar Norway | Norwegian | 80796320001 | ||||||
| WOODS, Roanld Ernest | Administrateur | All Seasons House Sterlings Field SL6 9PG Cookham Dean Berkshire | British | 82090400001 |
TRAFALGAR HOUSE FINANCE LTD a-t-elle des charges ?
| Classification | Dates | Statut | Détails | |
|---|---|---|---|---|
| A sixth supplemental trust deed dated 15TH november 2000 between the company, kvaerner PLC (the "issuer" ) and the law debenture trust corporation P.L.C. | Créé le 15 nov. 2000 Livré le 16 nov. 2000 | Totalement satisfaite | Montant garanti All obligations of kvaerner PLC (as issuer) to the chargee under or pursuant to the subsisting trust deeds and the supplemental trust deed present or future, actual or contingent including the payment of principal of and interest on the outstanding stock and all other monies covenanted to be paid by the issuer to the chargee under the subsisting trust deeds and supplemental trust deeds | |
Brèves mentions All the company's right title benefit and interest in the initial amount of £6,622,945.67 and the deposit being the credit balance on any account to which all or any part of the initial amount may be credited from time to time (or any renewal or redesignation thereof) and all rights benefits and proceeds in respect thereof. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
| An eighth supplemental trust deed dated 15TH november 2000 between the company, kvaerner PLC (the "issuer" ) and the law debenture trust corporation P.L.C. | Créé le 15 nov. 2000 Livré le 16 nov. 2000 | Totalement satisfaite | Montant garanti All obligations of kvaerner PLC (as issuer) to the chargee under or pursuant to the subsisting trust deeds and the supplemental trust deed present or future, actual or contingent including the payment of principal of and interest on the outstanding stock and all other monies covenanted to be paid by the issuer to the chargee in respect of the external bonds under the subsisting trust deeds and supplemental trust deeds | |
Brèves mentions All the company's right title benefit and interest in the initial amount of £1,227,746.54 and the deposit being the credit balance on any account to which all or any part of the initial amount may be credited from time to time (or any renewal or redesignation thereof) and all rights benefits and proceeds in respect thereof. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
| A sixth supplemental trust deed dated 15TH november 2000 between the company, kvaerner PLC (the "issuer" ) and the law debenture trust corporation P.L.C. | Créé le 15 nov. 2000 Livré le 16 nov. 2000 | Totalement satisfaite | Montant garanti All obligations of kvaerner PLC (as issuer) to the chargee under or pursuant to the subsisting trust deeds and the supplemental trust deed present or future, actual or contingent including the payment of principal of and interest on the outstanding stock and all other monies covenanted to be paid by the issuer to the chargee in respect of the external bonds under the subsisting trust deeds and supplemental trust deeds | |
Brèves mentions All the company's right title benefit and interest in the initial amount of £5,879,034.33 and the deposit being the credit balance on any account to which all or any part of the initial amount may be credited from time to time (or any renewal or redesignation thereof) and all rights benefits and proceeds in respect thereof. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
| A fourth supplemental trust deed dated 15TH november 2000 between the company, kvaerner PLC (the "issuer" ) and the law debenture trust corporation P.L.C. | Créé le 15 nov. 2000 Livré le 16 nov. 2000 | Totalement satisfaite | Montant garanti All obligations of kvaerner PLC (as issuer) to the chargee under or pursuant to the subsisting trust deeds and the supplemental trust deed present or future, actual or contingent including the payment of principal of and interest on the external bonds and all other monies covenanted to be paid by the issuer to the chargee in respect of the external bonds under the subsisting trust deeds and supplemental trust deeds excluding any obligations of the issuer in respect of payment of principal and interest on the kvaerner bonds | |
Brèves mentions All the company's right title benefit and interest in and to the initial amount of £12,736,708.88 and the deposit being the credit balance on any account to which all or any of part of the initial deposit may be credited from time to time (and any renewal or redesignation thereof) and all rights benefits and proceeds in respect thereof. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
| Legal charge | Créé le 15 janv. 1982 Livré le 28 janv. 1982 | Totalement satisfaite | Montant garanti All monies due or to become due from the company and/or trafalgar house limited to the chargee on any account whatsoever pursuant to a facility letter dated 23.3.78 | |
Brèves mentions L/Hold bush lane housse, 80, cannon street, london EC4 title no ngl 337827. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
| Mortgage | Créé le 05 mars 1952 Livré le 18 mars 1952 | Totalement satisfaite | Montant garanti £90,000 | |
Brèves mentions 1-18 station buildings new bridge stree t london. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
TRAFALGAR HOUSE FINANCE LTD a-t-elle des procédures d'insolvabilité ?
| Numéro de dossier | Dates | Type | Praticiens | Autre | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
| Creditors voluntary liquidation |
|
Source de données
- Companies House du Royaume-Uni
Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers. - Licence: CC0