WOOLLEN AND COMPANY,LIMITED

  • Vue d'ensemble
  • Résumé
  • Objet social
  • Adresse
  • Comptes
  • Dépôts
  • Dirigeants
  • Déclarations des personnes ayant un contrôle significatif
  • Charges
  • Source de données
  • Vue d'ensemble

    Nom de la sociétéWOOLLEN AND COMPANY,LIMITED
    Statut de la sociétéDissoute
    Forme juridiqueSociété à responsabilité limitée
    Numéro de société 00055238
    JuridictionAngleterre/Pays de Galles
    Date de création
    Date de cessation d'activité

    Résumé

    A des PSCs super sécurisésNon
    A des chargesOui
    A un historique d'insolvabilitéNon
    Le siège social est contestéNon

    Quel est l'objet de WOOLLEN AND COMPANY,LIMITED ?

    • Autres activités de services n.c.a. (96090) / Autres activités de services

    Où se situe WOOLLEN AND COMPANY,LIMITED ?

    Adresse du siège social
    1 Angel Square
    M60 0AG Manchester
    Adresse du siège social non livrableNon

    Quels sont les derniers comptes de WOOLLEN AND COMPANY,LIMITED ?

    Derniers comptes
    Derniers comptes arrêtés au06 janv. 2018

    Quels sont les derniers dépôts pour WOOLLEN AND COMPANY,LIMITED ?

    Dépôts
    DateDescriptionDocumentType

    Bulletin officiel final dissous par radiation volontaire

    1 pagesGAZ2(A)

    Premier avis au Bulletin officiel pour la radiation volontaire

    1 pagesGAZ1(A)

    Demande de radiation de la société du registre du commerce

    1 pagesDS01

    Déclaration de confirmation établie le 31 juil. 2019 avec mises à jour

    4 pagesCS01

    Cessation de la nomination de Cws (No.1) Limited en tant que directeur le 12 juil. 2019

    1 pagesTM01

    Nomination de Jonathan Michael Wormald en tant qu'administrateur le 12 juil. 2019

    2 pagesAP01

    legacy

    1 pagesSH20

    État du capital au 09 janv. 2019

    • Capital: GBP 100.00
    3 pagesSH19

    legacy

    1 pagesCAP-SS

    Résolutions

    Resolutions
    3 pagesRESOLUTIONS
    Résolutions
    CatégorieDateDescriptionType
    capital

    Résolution de réduction du capital social émis

    RES06

    Déclaration de confirmation établie le 31 juil. 2018 sans mise à jour

    3 pagesCS01

    Comptes pour une société dormante établis au 06 janv. 2018

    4 pagesAA

    Comptes pour une société dormante établis au 11 janv. 2017

    4 pagesAA

    Déclaration de confirmation établie le 31 juil. 2017 sans mise à jour

    3 pagesCS01

    Comptes pour une société dormante établis au 11 janv. 2016

    4 pagesAA

    Déclaration de confirmation établie le 31 juil. 2016 avec mises à jour

    5 pagesCS01

    Nomination de Mr David Roberts en tant qu'administrateur le 01 avr. 2016

    2 pagesAP01

    Cessation de la nomination de Steven Clive Bailey en tant que directeur le 01 avr. 2016

    1 pagesTM01

    Déclaration annuelle jusqu'au 31 juil. 2015 avec liste complète des actionnaires

    5 pagesAR01
    Dépôts associés
    CatégorieDateDescriptionType
    capital06 août 2015

    État du capital au 06 août 2015

    • Capital: GBP 30,000
    SH01

    Comptes pour une société dormante établis au 11 janv. 2015

    3 pagesAA

    Comptes pour une société dormante établis au 02 janv. 2014

    3 pagesAA

    Période comptable actuelle prolongée du 02 janv. 2015 au 11 janv. 2015

    1 pagesAA01

    Déclaration annuelle jusqu'au 31 juil. 2014 avec liste complète des actionnaires

    5 pagesAR01
    Dépôts associés
    CatégorieDateDescriptionType
    capital28 août 2014

    État du capital au 28 août 2014

    • Capital: GBP 30,000
    SH01

    Déclaration annuelle jusqu'au 16 avr. 2014 avec liste complète des actionnaires

    5 pagesAR01
    Dépôts associés
    CatégorieDateDescriptionType
    capital24 avr. 2014

    État du capital au 24 avr. 2014

    • Capital: GBP 30,000
    SH01

    Modification des coordonnées de l'administrateur Mr Steven Clive Bailey le 27 févr. 2014

    2 pagesCH01

    Qui sont les dirigeants de WOOLLEN AND COMPANY,LIMITED ?

    Dirigeants
    NomNommé leDate de démissionRôleAdresseIdentification de la sociétéPays de résidenceNationalitéDate de naissanceProfessionNuméro
    SELLERS, Caroline Jane
    Angel Square
    M60 0AG Manchester
    1
    United Kingdom
    Secrétaire
    Angel Square
    M60 0AG Manchester
    1
    United Kingdom
    150062600001
    ROBERTS, David Francis
    Angel Square
    M60 0AG Manchester
    1
    United Kingdom
    Administrateur
    Angel Square
    M60 0AG Manchester
    1
    United Kingdom
    United KingdomBritish200852560001
    WORMALD, Jonathan Michael
    Angel Square
    M60 0AG Manchester
    1
    United Kingdom
    Administrateur
    Angel Square
    M60 0AG Manchester
    1
    United Kingdom
    EnglandBritish201020490001
    ELDRIDGE, Katherine Elizabeth
    5 Stanley Avenue
    Hazel Grove
    SK7 4ED Stockport
    Secrétaire
    5 Stanley Avenue
    Hazel Grove
    SK7 4ED Stockport
    British110230860001
    FRENCH, John Leslie
    23 Sicey Lane
    S5 0RR Sheffield
    South Yorkshire
    Secrétaire
    23 Sicey Lane
    S5 0RR Sheffield
    South Yorkshire
    British103190910001
    HOWARTH, Michael
    Underhill Road
    Barlborough
    S43 4UX Chesterfield
    2
    Derbyshire
    Secrétaire
    Underhill Road
    Barlborough
    S43 4UX Chesterfield
    2
    Derbyshire
    British61681710001
    WARBURTON, Joan
    571 Wordsworth Avenue
    S5 9JF Sheffield
    South Yorkshire
    Secrétaire
    571 Wordsworth Avenue
    S5 9JF Sheffield
    South Yorkshire
    British26416610001
    WHITHAM, John Edward
    45 Rivelin Park Crescent
    S6 5GF Sheffield
    South Yorkshire
    Secrétaire
    45 Rivelin Park Crescent
    S6 5GF Sheffield
    South Yorkshire
    British101985790001
    UCL SECRETARY LIMITED
    United Co Operatives Limited
    Sandbrook Park Sandbrook Way
    OL11 1RY Rochdale
    Lancashire
    Secrétaire
    United Co Operatives Limited
    Sandbrook Park Sandbrook Way
    OL11 1RY Rochdale
    Lancashire
    111685670001
    BAILEY, Steven Clive
    Angel Square
    M60 0AG Manchester
    1
    United Kingdom
    Administrateur
    Angel Square
    M60 0AG Manchester
    1
    United Kingdom
    United KingdomBritish95753690002
    DAVIDSON, Colin Campbell
    256 Dobbin Hill
    S11 7JG Sheffield
    South Yorkshire
    Administrateur
    256 Dobbin Hill
    S11 7JG Sheffield
    South Yorkshire
    British3907100001
    FRENCH, John Leslie
    23 Sicey Lane
    S5 0RR Sheffield
    South Yorkshire
    Administrateur
    23 Sicey Lane
    S5 0RR Sheffield
    South Yorkshire
    British103190910001
    HOWARTH, Michael
    Underhill Road
    Barlborough
    S43 4UX Chesterfield
    2
    Derbyshire
    Administrateur
    Underhill Road
    Barlborough
    S43 4UX Chesterfield
    2
    Derbyshire
    EnglandBritish61681710001
    HUMES, Stephen
    5th Floor, New Century House
    Corporation Street
    M60 4ES Manchester
    C/O Governance Department
    United Kingdom
    Administrateur
    5th Floor, New Century House
    Corporation Street
    M60 4ES Manchester
    C/O Governance Department
    United Kingdom
    United KingdomBritish84087790001
    HURRELL, Timothy
    5th Floor, New Century House
    Corporation Street
    M60 4ES Manchester
    C/O Governance Department
    United Kingdom
    Administrateur
    5th Floor, New Century House
    Corporation Street
    M60 4ES Manchester
    C/O Governance Department
    United Kingdom
    United KingdomBritish99724260001
    KERSHAW, Clifford Harold
    83 Riverdale Road
    S10 3FE Sheffield
    South Yorkshire
    Administrateur
    83 Riverdale Road
    S10 3FE Sheffield
    South Yorkshire
    British3907110001
    KERSHAW, Jessie
    Highlands Farm
    Northill
    SG18 9AW Biggleswade
    Bedfordshire
    Administrateur
    Highlands Farm
    Northill
    SG18 9AW Biggleswade
    Bedfordshire
    British26416620002
    KERSHAW, Paul
    14 Clark Grove
    Stannington
    S6 6AY Sheffield
    Administrateur
    14 Clark Grove
    Stannington
    S6 6AY Sheffield
    British49702830002
    MCCRACKEN, Philip Guy
    The Bothy
    Bere Court Farm Pangbourne
    RG8 8HT Reading
    Berkshire
    Administrateur
    The Bothy
    Bere Court Farm Pangbourne
    RG8 8HT Reading
    Berkshire
    United KingdomBritish106997230001
    SILVER, Steven Russell
    Farr Royd House
    72 Sun Lane
    LS29 7LT Burley In Wharfedale
    West Yorkshire
    Administrateur
    Farr Royd House
    72 Sun Lane
    LS29 7LT Burley In Wharfedale
    West Yorkshire
    EnglandBritish182256460001
    WHITHAM, John Edward
    45 Rivelin Park Crescent
    S6 5GF Sheffield
    South Yorkshire
    Administrateur
    45 Rivelin Park Crescent
    S6 5GF Sheffield
    South Yorkshire
    British101985790001
    CWS (NO.1) LIMITED
    Corporation Street
    M60 4ES Manchester
    New Century House
    United Kingdom
    Administrateur
    Corporation Street
    M60 4ES Manchester
    New Century House
    United Kingdom
    Type d'identificationEEE
    Numéro d'enregistrement1925625
    130695310001
    UCL DIRECTOR 1 LIMITED
    United Co-Operatives Limited
    Sandbrook Park
    OL11 1RY Rochdale
    Administrateur
    United Co-Operatives Limited
    Sandbrook Park
    OL11 1RY Rochdale
    110868260001

    Quelles sont les dernières déclarations sur les personnes ayant un contrôle significatif pour WOOLLEN AND COMPANY,LIMITED ?

    Déclarations des personnes ayant un contrôle significatif
    Notifié leCessé leDéclaration
    31 juil. 2016La société sait ou a des raisons de croire qu'aucune personne enregistrable ou entité juridique pertinente enregistrable n'est liée à la société.

    WOOLLEN AND COMPANY,LIMITED a-t-elle des charges ?

    Charges
    ClassificationDatesStatutDétails
    Legal charge
    Créé le 28 mai 2004
    Livré le 12 juin 2004
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    £30,000.00 due or to become due from the company to the chargee
    Brèves mentions
    F/H property being 19 love street sheffield & f/h land and buildings on the north side of love street sheffield (now known as 2 love st) t/no SYK266430.
    Personnes ayant droit
    • Sheffield Co-Operative Society Limited
    Transactions
    • 12 juin 2004Enregistrement d'une charge (395)
    • 19 févr. 2009Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Legal mortgage
    Créé le 21 juin 1999
    Livré le 01 juil. 1999
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    The f/hold property known as land & buildings on the north side of love street sheffield south yorkshire t/no: SYK266430. And the proceeds of sale thereof floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment and an assignment of the goodwill and connection of any business together with the full benefit of all licences.
    Personnes ayant droit
    • National Westminster Bank PLC
    Transactions
    • 01 juil. 1999Enregistrement d'une charge (395)
    • 14 févr. 2009Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Legal mortgage
    Créé le 28 oct. 1996
    Livré le 01 nov. 1996
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    F/H property k/a 19 love street, sheffield and the proceeds of sale. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment and an assignment of the goodwill and connection of any business together with the full benefit of all licences.
    Personnes ayant droit
    • National Westminster Bank PLC
    Transactions
    • 01 nov. 1996Enregistrement d'une charge (395)
    • 14 févr. 2009Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)

    Source de données

    • Companies House du Royaume-Uni
      Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers.
    • Licence: CC0