HAY HALL TYSELEY LIMITED

  • Vue d'ensemble
  • Résumé
  • Objet social
  • Adresse
  • Dénominations sociales précédentes
  • Comptes
  • Déclaration de confirmation
  • Bilan annuel
  • Dépôts
  • Dirigeants
  • Charges
  • Source de données
  • Vue d'ensemble

    Nom de la sociétéHAY HALL TYSELEY LIMITED
    Statut de la sociétéActive
    Forme juridiqueSociété à responsabilité limitée
    Numéro de société 00062731
    JuridictionAngleterre/Pays de Galles
    Date de création
    Date de cessation d'activité

    Résumé

    A des PSCs super sécurisésNon
    A des chargesOui
    A un historique d'insolvabilitéNon
    Le siège social est contestéNon

    Quel est l'objet de HAY HALL TYSELEY LIMITED ?

    • (7499) /

    Où se situe HAY HALL TYSELEY LIMITED ?

    Adresse du siège social
    34 St Bernards Road
    Solihull
    B92 7BB West Midlands
    Adresse du siège social non livrableNon

    Quels étaient les noms précédents de HAY HALL TYSELEY LIMITED ?

    Dénominations sociales précédentes
    Nom de la sociétéDeJusqu'au
    HOLLOW EXTRUSIONS LIMITED19 sept. 199019 sept. 1990
    TI HOLLOW EXTRUSIONS LIMITED23 oct. 198523 oct. 1985
    TI HELLIWELLS LIMITED31 déc. 197731 déc. 1977
    HELLIWELLS LIMITED26 juin 189926 juin 1899

    Quels sont les derniers comptes de HAY HALL TYSELEY LIMITED ?

    En retardOui
    Prochains comptes
    Fin de la prochaine période comptable le31 déc. 2009
    Date d'échéance des prochains comptes30 sept. 2010
    Derniers comptes
    Derniers comptes arrêtés au31 déc. 2008

    Quel est le statut de la dernière déclaration de confirmation pour HAY HALL TYSELEY LIMITED ?

    En retardOui
    Dernière déclaration de confirmation établie jusqu'au14 avr. 2017
    Date d'échéance de la prochaine déclaration de confirmation28 avr. 2017
    En retardOui

    Quel est le statut du dernier bilan annuel pour HAY HALL TYSELEY LIMITED ?

    Bilan annuel
    Dernier bilan annuel
    En retardOui

    Quels sont les derniers dépôts pour HAY HALL TYSELEY LIMITED ?

    Dépôts
    DateDescriptionDocumentType

    Restauration par ordonnance du tribunal

    3 pagesAC92

    Bulletin officiel final dissous par radiation d'office

    1 pagesGAZ2

    Premier avis au Bulletin officiel pour la radiation d'office

    1 pagesGAZ1

    La procédure de radiation d'office a été suspendue

    1 pagesDISS16(SOAS)

    Premier avis au Bulletin officiel pour la radiation d'office

    1 pagesGAZ1

    Comptes pour une société dormante établis au 31 déc. 2008

    5 pagesAA

    legacy

    4 pages363a

    legacy

    1 pages288c

    Comptes pour une société dormante établis au 31 déc. 2007

    5 pagesAA

    legacy

    4 pages363a

    Comptes pour une société dormante établis au 31 déc. 2006

    5 pagesAA

    legacy

    3 pages363a

    legacy

    1 pages287

    Comptes annuels établis au 31 déc. 2005

    8 pagesAA

    legacy

    7 pages363s

    legacy

    pages88(2)R

    legacy

    2 pages123

    Résolutions

    Resolutions
    pagesRESOLUTIONS
    Résolutions
    CatégorieDateDescriptionType
    capital

    Résolution de modification des droits ou de la dénomination des actions

    RES12

    Résolutions

    Resolutions
    pagesRESOLUTIONS
    Résolutions
    CatégorieDateDescriptionType
    capital

    Résolution d'attribution de valeurs mobilières

    RES10

    Résolutions

    Resolutions
    pagesRESOLUTIONS
    Résolutions
    CatégorieDateDescriptionType
    capital

    Résolution d'augmentation du capital social autorisé

    RES04

    legacy

    2 pages403a

    legacy

    2 pages403a

    Comptes annuels établis au 31 déc. 2004

    8 pagesAA

    legacy

    7 pages363s

    Comptes annuels établis au 31 déc. 2003

    8 pagesAA

    Qui sont les dirigeants de HAY HALL TYSELEY LIMITED ?

    Dirigeants
    NomNommé leDate de démissionRôleAdresseIdentification de la sociétéPays de résidenceNationalitéDate de naissanceProfessionNuméro
    BALDREY, Philip Nigel
    34 Saint Bernards Road
    B92 7BB Solihull
    West Midlands
    Secrétaire
    34 Saint Bernards Road
    B92 7BB Solihull
    West Midlands
    British44039650003
    BALDREY, Philip Nigel
    34 Saint Bernards Road
    B92 7BB Solihull
    West Midlands
    Administrateur
    34 Saint Bernards Road
    B92 7BB Solihull
    West Midlands
    EnglandBritishDirector44039650003
    BURDETT, Roger Leonard
    The Common
    Colley Moor
    CV7 8AR Coventry
    Fir Tree Farm
    Warwickshire
    Administrateur
    The Common
    Colley Moor
    CV7 8AR Coventry
    Fir Tree Farm
    Warwickshire
    United KingdomBritishGroup Chief Executiv163337290001
    MCCABE, Karl Desmond
    51 Whitford Drive
    Monkspath
    B90 4YG Solihull
    West Midlands
    Secrétaire
    51 Whitford Drive
    Monkspath
    B90 4YG Solihull
    West Midlands
    BritishCompany Secretary87220830001
    POWELL, Christopher Thomas
    3 Bracebridge Close
    Balsall Common
    CV7 7QJ Coventry
    West Midlands
    Secrétaire
    3 Bracebridge Close
    Balsall Common
    CV7 7QJ Coventry
    West Midlands
    British8679850001
    BISHOP, Reginald William
    Parkside Park Road
    Stevington
    MK43 7QG Bedford
    Administrateur
    Parkside Park Road
    Stevington
    MK43 7QG Bedford
    BritishChairman41546740001
    EDWARDS, Robert John
    3 The Chantries
    Chantry Heath Lane
    CV8 3DS Stoneleigh
    Coventry
    Administrateur
    3 The Chantries
    Chantry Heath Lane
    CV8 3DS Stoneleigh
    Coventry
    BritishManufacturing Director28107080002
    FISHER, Michael Whiteley
    30 Croftdown Road
    B17 8RB Birmingham
    West Midlands
    Administrateur
    30 Croftdown Road
    B17 8RB Birmingham
    West Midlands
    BritishMarketing Director39032430001
    HAYES, Michael Hugh
    Wenlock Mounthooly
    TD8 6TJ Jedburgh
    Roxburghshire
    Administrateur
    Wenlock Mounthooly
    TD8 6TJ Jedburgh
    Roxburghshire
    ScotlandBritishChairman50729030001
    ISAAC, Nicholas Charles Robert
    Rivermead House
    Aston Cantlow
    B95 6JP Henley-In-Arden
    Administrateur
    Rivermead House
    Aston Cantlow
    B95 6JP Henley-In-Arden
    EnglandBritishManaging Director111494760001
    ORWIN, John Alfred
    15 Abbey Close
    B49 5QW Alcester
    Warwickshire
    Administrateur
    15 Abbey Close
    B49 5QW Alcester
    Warwickshire
    BritishDirector68286230001
    POWELL, Christopher Thomas
    3 Bracebridge Close
    Balsall Common
    CV7 7QJ Coventry
    West Midlands
    Administrateur
    3 Bracebridge Close
    Balsall Common
    CV7 7QJ Coventry
    West Midlands
    BritishManaging Director8679850001
    RODGER, David Anthony Hugh
    Oaktrees
    Pinley Green
    CV35 8LU Claverdon
    Warwickshire
    Administrateur
    Oaktrees
    Pinley Green
    CV35 8LU Claverdon
    Warwickshire
    BritishDirector89739630001
    THOMAS, Clive Ronald, Dr
    14 Roebuck Park
    B49 5EF Alcester
    Warwickshire
    Administrateur
    14 Roebuck Park
    B49 5EF Alcester
    Warwickshire
    United KingdomBritishManaging Director32892100002

    HAY HALL TYSELEY LIMITED a-t-elle des charges ?

    Charges
    ClassificationDatesStatutDétails
    Composite debenture
    Créé le 30 janv. 1996
    Livré le 13 févr. 1996
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of or in connection with any of the mezzanine loan agreements dated the same date as the debenture, the guarantee and indemnity dated 30TH january 1996, the debenture, and any other other guarantee, indemnity or security documents or trust arrangement
    Brèves mentions
    Trademark-"polidraw" trademark no.-1396145 Status-06 expiry date-28TH august 1997. see the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Mithras Investment Trust PLC as Agent for Itself and the Other Secured Parties (As Defined)
    Transactions
    • 13 févr. 1996Enregistrement d'une charge (395)
    • 27 janv. 2006Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Debenture
    Créé le 30 janv. 1996
    Livré le 12 févr. 1996
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee under or in connection with any of the financing documents (as defined in the credit agreement)
    Brèves mentions
    Trademark-"polidraw", trademark no.-1396145, Status-class O6, expiry date-28TH august 1997. fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • The Governor and the Company of the Bank of Scotland as Security Trustee (As Defined)
    Transactions
    • 12 févr. 1996Enregistrement d'une charge (395)
    • 16 févr. 2006Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)

    Source de données

    • Companies House du Royaume-Uni
      Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers.
    • Licence: CC0