JOHN BARRAS & CO LIMITED

  • Vue d'ensemble
  • Résumé
  • Objet social
  • Adresse
  • Dénominations sociales précédentes
  • Comptes
  • Dépôts
  • Dirigeants
  • Personnes ayant un contrôle significatif
  • Charges
  • Insolvabilité
  • Source de données
  • Vue d'ensemble

    Nom de la sociétéJOHN BARRAS & CO LIMITED
    Statut de la sociétéDissoute
    Forme juridiqueSociété à responsabilité limitée
    Numéro de société 00068144
    JuridictionAngleterre/Pays de Galles
    Date de création
    Date de cessation d'activité

    Résumé

    A des PSCs super sécurisésNon
    A des chargesOui
    A un historique d'insolvabilitéOui
    Le siège social est contestéNon

    Quel est l'objet de JOHN BARRAS & CO LIMITED ?

    • Société non marchande non marchande (74990) / Activités spécialisées, scientifiques et techniques

    Où se situe JOHN BARRAS & CO LIMITED ?

    Adresse du siège social
    Resolve Partners Limited 22 York Buildings
    John Adam Street
    WC2N 6JU London
    Adresse du siège social non livrableNon

    Quels étaient les noms précédents de JOHN BARRAS & CO LIMITED ?

    Dénominations sociales précédentes
    Nom de la sociétéDeJusqu'au
    CLEVELAND PLACE NOMINEE COMPANY (NO.4) LIMITED22 oct. 199322 oct. 1993
    GRAND METROPOLITAN NOMINEE COMPANY (NO.7) LIMITED28 mai 199128 mai 1991
    WATNEY COMBE REID (ALTON) LIMITED08 déc. 190008 déc. 1900

    Quels sont les derniers comptes de JOHN BARRAS & CO LIMITED ?

    Derniers comptes
    Derniers comptes arrêtés au22 août 2015

    Quels sont les derniers dépôts pour JOHN BARRAS & CO LIMITED ?

    Dépôts
    DateDescriptionDocumentType

    Déclaration de biens vacants

    1 pagesBONA

    Gazette finale dissoute à la suite d'une liquidation

    1 pagesGAZ2

    Retour de la réunion finale dans une liquidation volontaire des membres

    10 pagesLIQ13

    Déclaration des reçus et paiements des liquidateurs jusqu'à 11 janv. 2018

    9 pagesLIQ03

    Changement d'adresse du siège social de Resolve Partners Limited 48 Warwick Street London W1B 5NL à Resolve Partners Limited 22 York Buildings John Adam Street London WC2N 6JU le 12 sept. 2017

    2 pagesAD01

    Déclaration de confirmation établie le 07 mars 2017 avec mises à jour

    5 pagesCS01

    Changement d'adresse du siège social de Westgate Brewery Bury St Edmunds Suffolk IP33 1QT United Kingdom à Resolve Partners Limited 48 Warwick Street London W1B 5NL le 10 févr. 2017

    2 pagesAD01

    Nomination d'un liquidateur volontaire

    1 pages600

    Résolutions

    Resolutions
    2 pagesRESOLUTIONS
    Résolutions
    CatégorieDateDescriptionType
    liquidation

    Résolution spéciale pour la liquidation au 12 janv. 2017

    LRESSP

    Déclaration de solvabilité

    9 pages4.70

    Nomination de Lindsay Anne Keswick en tant que secrétaire le 25 avr. 2016

    2 pagesAP03

    Cessation de la nomination de Claire Susan Stewart en tant que secrétaire le 25 avr. 2016

    1 pagesTM02

    Changement d'adresse du siège social de Sunrise House Ninth Avenue Burton upon Trent Staffordshire DE14 3JZ à Westgate Brewery Bury St Edmunds Suffolk IP33 1QT le 07 mars 2016

    1 pagesAD01

    Déclaration annuelle jusqu'au 02 mars 2016 avec liste complète des actionnaires

    3 pagesAR01
    Dépôts associés
    CatégorieDateDescriptionType
    capital02 mars 2016

    État du capital au 02 mars 2016

    • Capital: GBP 100,070
    SH01

    Comptes pour une société dormante établis au 22 août 2015

    3 pagesAA

    Cessation de la nomination de Jonathan Robert Langford en tant que directeur le 26 janv. 2016

    1 pagesTM01

    Cessation de la nomination de Daryl Antony Kelly en tant que directeur le 26 janv. 2016

    1 pagesTM01

    Cessation de la nomination de Lucy Jane Bell en tant que directeur le 26 janv. 2016

    1 pagesTM01

    Nomination de Kirk Dyson Davis en tant qu'administrateur le 21 déc. 2015

    2 pagesAP01

    Cessation de la nomination de Henry Jones en tant que secrétaire le 04 déc. 2015

    1 pagesTM02

    Période comptable actuelle raccourcie du 24 août 2016 au 30 avr. 2016

    1 pagesAA01

    Cessation de la nomination de Patrick James Gallagher en tant que directeur le 23 juin 2015

    1 pagesTM01

    Déclaration annuelle jusqu'au 02 mars 2015 avec liste complète des actionnaires

    7 pagesAR01
    Dépôts associés
    CatégorieDateDescriptionType
    capital02 mars 2015

    État du capital au 02 mars 2015

    • Capital: GBP 100,070
    SH01

    Comptes pour une société dormante établis au 23 août 2014

    3 pagesAA

    Déclaration annuelle jusqu'au 02 mars 2014 avec liste complète des actionnaires

    7 pagesAR01
    Dépôts associés
    CatégorieDateDescriptionType
    capital03 mars 2014

    État du capital au 03 mars 2014

    • Capital: GBP 100,070
    SH01

    Qui sont les dirigeants de JOHN BARRAS & CO LIMITED ?

    Dirigeants
    NomNommé leDate de démissionRôleAdresseIdentification de la sociétéPays de résidenceNationalitéDate de naissanceProfessionNuméro
    KESWICK, Lindsay Anne
    22 York Buildings
    John Adam Street
    WC2N 6JU London
    Resolve Partners Limited
    Secrétaire
    22 York Buildings
    John Adam Street
    WC2N 6JU London
    Resolve Partners Limited
    207523690001
    DAVIS, Kirk Dyson
    Ninth Avenue
    DE14 3JZ Burton Upon Trent
    Sunrise House
    Staffordshire
    United Kingdom
    Administrateur
    Ninth Avenue
    DE14 3JZ Burton Upon Trent
    Sunrise House
    Staffordshire
    United Kingdom
    United KingdomBritish158484730001
    ADAMS, Susanne Margaret
    Azalea
    167 High Street Northchurch
    HP4 3QT Berkhamsted
    Hertfordshire
    Secrétaire
    Azalea
    167 High Street Northchurch
    HP4 3QT Berkhamsted
    Hertfordshire
    British28738400002
    CUTHBERTSON, Colin
    5 Hill Gardens
    LE16 9EB Market Harborough
    Leicestershire
    Secrétaire
    5 Hill Gardens
    LE16 9EB Market Harborough
    Leicestershire
    British26369940001
    HOMER, Neville Rex
    Caberfeidh 12 Forth Street
    EH39 4HY North Berwick
    East Lothian
    Secrétaire
    Caberfeidh 12 Forth Street
    EH39 4HY North Berwick
    East Lothian
    British895960001
    HOMER, Neville Rex
    Caberfeidh 12 Forth Street
    EH39 4HY North Berwick
    East Lothian
    Secrétaire
    Caberfeidh 12 Forth Street
    EH39 4HY North Berwick
    East Lothian
    British895960001
    JONES, Henry
    Ninth Avenue
    DE14 3JZ Burton Upon Trent
    Sunrise House
    Staffordshire
    United Kingdom
    Secrétaire
    Ninth Avenue
    DE14 3JZ Burton Upon Trent
    Sunrise House
    Staffordshire
    United Kingdom
    180592220001
    KENDALL, Timothy James
    31 Canterbury Close
    Erdington
    B23 7QL Birmingham
    West Midlands
    Secrétaire
    31 Canterbury Close
    Erdington
    B23 7QL Birmingham
    West Midlands
    British117397470002
    RUDD, Susan Clare
    Ninth Avenue
    DE14 3JZ Burton Upon Trent
    Sunrise House
    Staffordshire
    United Kingdom
    Secrétaire
    Ninth Avenue
    DE14 3JZ Burton Upon Trent
    Sunrise House
    Staffordshire
    United Kingdom
    172445970001
    RUDD, Susan Clare
    17 Thacker Drive
    WS13 6NS Lichfield
    Staffordshire
    Secrétaire
    17 Thacker Drive
    WS13 6NS Lichfield
    Staffordshire
    British81789210004
    STEVENS, Mark
    5 Lyon Drive
    Murieston
    EH54 9HF Livingston
    West Lothian
    Secrétaire
    5 Lyon Drive
    Murieston
    EH54 9HF Livingston
    West Lothian
    British80951870001
    STEWART, Claire Susan
    Ninth Avenue
    DE14 3JZ Burton Upon Trent
    Sunrise House
    Staffordshire
    United Kingdom
    Secrétaire
    Ninth Avenue
    DE14 3JZ Burton Upon Trent
    Sunrise House
    Staffordshire
    United Kingdom
    181022010001
    STEWART, Claire Susan
    Ninth Avenue
    DE14 3JZ Burton Upon Trent
    Sunrise House
    Staffordshire
    United Kingdom
    Secrétaire
    Ninth Avenue
    DE14 3JZ Burton Upon Trent
    Sunrise House
    Staffordshire
    United Kingdom
    Other130369890001
    WALMSLEY, Derek Kerr
    High Street
    Pavenham
    MK43 7NJ Bedford
    Walnut Barn
    Bedfordshire
    Secrétaire
    High Street
    Pavenham
    MK43 7NJ Bedford
    Walnut Barn
    Bedfordshire
    British135181230001
    BASHFORTH, Edward Michael
    Second Avenue
    DE14 2WF Burton Upon Trent
    Jubilee House
    Staffordshire
    United Kingdom
    Administrateur
    Second Avenue
    DE14 2WF Burton Upon Trent
    Jubilee House
    Staffordshire
    United Kingdom
    United KingdomBritish131551840002
    BELL, Lucy Jane
    Ninth Avenue
    DE14 3JZ Burton Upon Trent
    Sunrise House
    Staffordshire
    United Kingdom
    Administrateur
    Ninth Avenue
    DE14 3JZ Burton Upon Trent
    Sunrise House
    Staffordshire
    United Kingdom
    United KingdomBritish164754670001
    BUBB, Stewart Edmund Conyers
    Clare Cottage
    42 Lammas Lane
    KT10 8PD Esher
    Surrey
    Administrateur
    Clare Cottage
    42 Lammas Lane
    KT10 8PD Esher
    Surrey
    British36779040001
    CUMMING, Johanna Louise
    18 Prospect Quay
    98 Point Pleasant
    SW18 1PR London
    Administrateur
    18 Prospect Quay
    98 Point Pleasant
    SW18 1PR London
    United KingdomBritish111108910001
    DANDO, Stephen Peter
    Second Avenue
    DE14 2WF Burton Upon Trent
    Jubilee House
    Staffordshire
    United Kingdom
    Administrateur
    Second Avenue
    DE14 2WF Burton Upon Trent
    Jubilee House
    Staffordshire
    United Kingdom
    United KingdomBritish152083750001
    DUTTON, Philip
    Second Avenue
    DE14 2WF Burton Upon Trent
    Jubilee House
    Staffordshire
    United Kingdom
    Administrateur
    Second Avenue
    DE14 2WF Burton Upon Trent
    Jubilee House
    Staffordshire
    United Kingdom
    United KingdomBritish141395280001
    GALLAGHER, Patrick James
    Ninth Avenue
    DE14 3JZ Burton Upon Trent
    Sunrise House
    Staffordshire
    United Kingdom
    Administrateur
    Ninth Avenue
    DE14 3JZ Burton Upon Trent
    Sunrise House
    Staffordshire
    United Kingdom
    EnglandBritish205366190001
    GODWIN-BRATT, Robert James
    Ninth Avenue
    DE14 3JZ Burton Upon Trent
    Sunrise House
    Staffordshire
    United Kingdom
    Administrateur
    Ninth Avenue
    DE14 3JZ Burton Upon Trent
    Sunrise House
    Staffordshire
    United Kingdom
    United KingdomBritish170184800001
    HOMER, Neville Rex
    Caberfeidh 12 Forth Street
    EH39 4HY North Berwick
    East Lothian
    Administrateur
    Caberfeidh 12 Forth Street
    EH39 4HY North Berwick
    East Lothian
    British895960001
    HOMER, Neville Rex
    Caberfeidh 12 Forth Street
    EH39 4HY North Berwick
    East Lothian
    Administrateur
    Caberfeidh 12 Forth Street
    EH39 4HY North Berwick
    East Lothian
    British895960001
    JONES, Karen Elisabeth Dind
    Paddock House
    9 Spencer Park Wandsworth
    SW18 2SX London
    Administrateur
    Paddock House
    9 Spencer Park Wandsworth
    SW18 2SX London
    United KingdomBritish47793260007
    KELLY, Daryl Antony
    Ninth Avenue
    DE14 3JZ Burton Upon Trent
    Sunrise House
    Staffordshire
    United Kingdom
    Administrateur
    Ninth Avenue
    DE14 3JZ Burton Upon Trent
    Sunrise House
    Staffordshire
    United Kingdom
    United KingdomBritish86246470001
    KNIGHT, Andrew Ronald
    89 Main Street
    DE13 7ED Alrewas
    Staffordshire
    Administrateur
    89 Main Street
    DE13 7ED Alrewas
    Staffordshire
    British81555100002
    LANGFORD, Jonathan Robert
    Ninth Avenue
    DE14 3JZ Burton Upon Trent
    Sunrise House
    Staffordshire
    United Kingdom
    Administrateur
    Ninth Avenue
    DE14 3JZ Burton Upon Trent
    Sunrise House
    Staffordshire
    United Kingdom
    United KingdomBritish135408140001
    MARGERRISON, Russell John
    Ninth Avenue
    DE14 3JZ Burton Upon Trent
    Sunrise House
    Staffordshire
    United Kingdom
    Administrateur
    Ninth Avenue
    DE14 3JZ Burton Upon Trent
    Sunrise House
    Staffordshire
    United Kingdom
    EnglandBritish170590800001
    MCDONALD, Robert James
    46 Wentworth Drive
    WS14 9HN Lichfield
    Staffordshire
    Administrateur
    46 Wentworth Drive
    WS14 9HN Lichfield
    Staffordshire
    British42019620001
    MILLER, Louise
    13 Traquair Park West
    EH12 7AN Edinburgh
    Midlothian
    Administrateur
    13 Traquair Park West
    EH12 7AN Edinburgh
    Midlothian
    British63895470001
    MYDDELTON, Roger Hugh
    21 Lawford Road
    NW5 2LH London
    Administrateur
    21 Lawford Road
    NW5 2LH London
    British399500001
    PEAREY, Michael John
    The Lodge
    EH32 0RE Aberlady
    East Lothian
    Administrateur
    The Lodge
    EH32 0RE Aberlady
    East Lothian
    British46305030001
    PEAREY, Michael John
    The Lodge
    EH32 0RE Aberlady
    East Lothian
    Administrateur
    The Lodge
    EH32 0RE Aberlady
    East Lothian
    British46305030001
    PRESTON, Neil David
    Second Avenue
    DE14 2WF Burton Upon Trent
    Jubilee House
    Staffordshire
    United Kingdom
    Administrateur
    Second Avenue
    DE14 2WF Burton Upon Trent
    Jubilee House
    Staffordshire
    United Kingdom
    United KingdomBritish63043630002

    Qui sont les personnes ayant un contrôle significatif sur JOHN BARRAS & CO LIMITED ?

    Personnes ayant un contrôle significatif
    NomNotifié leAdresseCessé
    IP33 1QT Bury St Edmunds
    Westgate Brewery
    Suffolk
    United Kingdom
    06 avr. 2016
    IP33 1QT Bury St Edmunds
    Westgate Brewery
    Suffolk
    United Kingdom
    Non
    Forme juridiqueLimited By Shares
    Pays d'enregistrementEngland And Wales
    Autorité légaleUnited Kingdom (England And Wales)
    Lieu d'enregistrementCompanies House
    Numéro d'enregistrement57987
    Nature du contrôle
    • La personne détient, directement ou indirectement, plus de 75 % des actions de la société.
    • La personne détient, directement ou indirectement, plus de 75 % des droits de vote dans la société.
    • La personne détient, directement ou indirectement, le droit de nommer ou de révoquer une majorité des membres du conseil d'administration de la société.

    JOHN BARRAS & CO LIMITED a-t-elle des charges ?

    Charges
    ClassificationDatesStatutDétails
    Security agreement
    Créé le 15 déc. 2003
    Livré le 31 déc. 2003
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from each obligor to any finance party under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • The Royal Bank of Scotland PLC (The Facility Agent) as Agent and Trustee for the Financeparties
    Transactions
    • 31 déc. 2003Enregistrement d'une charge (395)
    • 09 déc. 2004Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Twelfth supplemental trust deed
    Créé le 30 sept. 1985
    Livré le 07 oct. 1985
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    £1288988 debenture stock of watney mann & truman holdings PLC comprising of £349595 5% redeemable debenture stock 2000, £24 3200 6 1/2% redeemable debenture stock 1988/93 & £696193 7 3/4% redeemable debenture stock 1988/93 & all other monies intended to be secured by a trust deed dated 4/2/62 & deeds supplemental thereto
    Brèves mentions
    First floating charge. Undertaking and all property and assets present and future including uncalled capital.
    Personnes ayant droit
    • Alliance Assurance Company Limited
    Transactions
    • 07 oct. 1985Enregistrement d'une charge
    • 23 sept. 2003Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Trust deed
    Créé le 24 mai 1983
    Livré le 25 mai 1983
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    £50,000,000 12 1/8% redeemable debenture stock 2008 of watney hanne truman holdings PLC and for further securing all monies due or to become due from watney mann & truman holdings PLC to the chargee under the terms of a trust deed dated 7/2/62 and deeds supplemental thereto
    Brèves mentions
    Undertaking and all property and assets present and future including uncalled capital.
    Personnes ayant droit
    • Alliance Assurance Company Limited
    Transactions
    • 25 mai 1983Enregistrement d'une charge
    • 23 sept. 2003Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Trust deed
    Créé le 28 juil. 1970
    Livré le 12 août 1970
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    Securing debenture stock of watney mann LTD amounting to £53,127,463 including £45,627,463 secured by a trust deed dated 7.2.62 & deeds supplemental
    Brèves mentions
    First floating charge on. Undertaking and all property and assets present and future including uncalled capital.
    Personnes ayant droit
    • Baring Brothers & Co LTD
    Transactions
    • 12 août 1970Enregistrement d'une charge
    • 23 sept. 2003Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    31.7.67 trust deed
    Créé le 31 juil. 1967
    Livré le 31 juil. 1967
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    Trust deed securing debenture stock of watney mann LTD amouning to £45,627,463 inclusive of £35,627,463 secured by trust deed dated 7.2.62 & deeds suppl thereto.
    Brèves mentions
    First floating charge on. Undertaking and all property and assets present and future including uncalled capital.
    Personnes ayant droit
    • Baring Bros & Co LTD
    Transactions
    • 31 juil. 1967Enregistrement d'une charge
    • 23 sept. 2003Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Equitable charge
    Créé le 08 mai 1967
    Livré le 26 mai 1967
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    For securing debenture stock of watney mann LTD amounting to £10,000,000.
    Brèves mentions
    First floating charge on. Undertaking and all property and assets present and future including uncalled capital.
    Personnes ayant droit
    • Baring Bros & Co LTD
    Transactions
    • 26 mai 1967Enregistrement d'une charge
    • 23 sept. 2003Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Trust deed
    Créé le 26 juil. 1965
    Livré le 28 juil. 1965
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    £7,500,000 debenture stock of watney mann LTD.
    Brèves mentions
    Floating charge undertaking and all assets present and future including uncalled capital.
    Personnes ayant droit
    • Baring Brother LTD
    Transactions
    • 28 juil. 1965Enregistrement d'une charge
    • 23 sept. 2003Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Trust deed
    Créé le 26 mars 1965
    Livré le 06 avr. 1965
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    £1.347.268 debenture stock of watney mann LTD
    Brèves mentions
    Floating charge undertaking and all assets present and future including uncalled capital.
    Personnes ayant droit
    • Baring Brothers & Co LTD
    Transactions
    • 06 avr. 1965Enregistrement d'une charge
    • 23 sept. 2003Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Trust deed
    Créé le 22 janv. 1964
    Livré le 23 janv. 1964
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    For securing £8,000,000 debenture stock of watney mann limited.
    Brèves mentions
    (See doc 128 for details). Undertaking and all property and assets present and future including uncalled capital.
    Personnes ayant droit
    • Baring Brothers & Co LTD
    Transactions
    • 23 janv. 1964Enregistrement d'une charge
    Trust deed
    Créé le 08 févr. 1962
    Livré le 08 févr. 1962
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    For further securing debenture stock amounting to £5,000,000 of watney mann LTD
    Brèves mentions
    Undertaking and all assets present and future including uncalled capital.
    Personnes ayant droit
    • Baring Brothes & Co LTD
    Transactions
    • 08 févr. 1962Enregistrement d'une charge
    • 23 sept. 2003Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Trust deed
    Créé le 07 févr. 1962
    Livré le 07 févr. 1962
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    For further securing £13,780,195 debenture stock of watney mann LTD together with a premium in respect of £7,363,992 of 10 per cent in the event of voluntary liquidation of watney mann LTD.
    Brèves mentions
    Undertaking and all assets present and future including uncalled capital.
    Personnes ayant droit
    • Baring Brothers & Co LTD
    Transactions
    • 07 févr. 1962Enregistrement d'une charge

    JOHN BARRAS & CO LIMITED a-t-elle des procédures d'insolvabilité ?

    Numéro de dossierDatesTypePraticiensAutre
    1
    DateType
    12 janv. 2017Commencement of winding up
    15 avr. 2019Dissolved on
    Members voluntary liquidation
    NomRôleAdresseNommé leCessé le
    Simon Harris
    48 Warwick Street
    W1B 5NL London
    practitioner
    48 Warwick Street
    W1B 5NL London
    Ben David Woodthorpe
    48 Warwick Street
    W1B 5NL London
    practitioner
    48 Warwick Street
    W1B 5NL London

    Source de données

    • Companies House du Royaume-Uni
      Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers.
    • Licence: CC0