ASSL (REALISATIONS) LIMITED

  • Vue d'ensemble
  • Résumé
  • Objet social
  • Adresse
  • Dénominations sociales précédentes
  • Comptes
  • Bilan annuel
  • Dépôts
  • Dirigeants
  • Charges
  • Insolvabilité
  • Source de données
  • Vue d'ensemble

    Nom de la sociétéASSL (REALISATIONS) LIMITED
    Statut de la sociétéDissoute
    Forme juridiqueSociété à responsabilité limitée
    Numéro de société 00068757
    JuridictionAngleterre/Pays de Galles
    Date de création
    Date de cessation d'activité

    Résumé

    A des PSCs super sécurisésNon
    A des chargesOui
    A un historique d'insolvabilitéOui
    Le siège social est contestéNon

    Quel est l'objet de ASSL (REALISATIONS) LIMITED ?

    • (1730) /
    • (2222) /
    • (5141) /

    Où se situe ASSL (REALISATIONS) LIMITED ?

    Adresse du siège social
    8 Salisbury Square
    London
    EC4Y 8BB
    Adresse du siège social non livrableNon

    Quels étaient les noms précédents de ASSL (REALISATIONS) LIMITED ?

    Dénominations sociales précédentes
    Nom de la sociétéDeJusqu'au
    ARTHUR SANDERSON & SONS,LIMITED 27 déc. 190027 déc. 1900

    Quels sont les derniers comptes de ASSL (REALISATIONS) LIMITED ?

    Derniers comptes
    Derniers comptes arrêtés au31 déc. 2001

    Quel est le statut du dernier bilan annuel pour ASSL (REALISATIONS) LIMITED ?

    Bilan annuel
    Dernier bilan annuel

    Quels sont les derniers dépôts pour ASSL (REALISATIONS) LIMITED ?

    Dépôts
    DateDescriptionDocumentType

    Bulletin officiel final dissous par radiation d'office

    1 pagesGAZ2

    Premier avis au Bulletin officiel pour la radiation d'office

    1 pagesGAZ1

    Restauration par ordonnance du tribunal

    3 pagesAC92

    legacy

    1 pagesLIQ

    Retour de la réunion finale dans une liquidation volontaire des créanciers

    4 pages4.72

    Déclaration des reçus et paiements des liquidateurs

    5 pages4.68

    Déclaration des reçus et paiements des liquidateurs

    5 pages4.68

    Déclaration des reçus et paiements des liquidateurs

    6 pages4.68

    Déclaration des reçus et paiements des liquidateurs

    5 pages4.68

    Résumé des recettes et paiements du récepteur

    2 pages3.6

    legacy

    1 pages405(2)

    Résumé des recettes et paiements du récepteur

    2 pages3.6

    Déclaration des reçus et paiements des liquidateurs

    6 pages4.68

    Déclaration des reçus et paiements des liquidateurs

    5 pages4.68

    Résumé des recettes et paiements du récepteur

    5 pages3.6

    legacy

    1 pages287

    Déclaration des affaires

    23 pages4.20

    Avis de constitution du Comité de liquidation

    2 pages4.48

    Résolutions

    Resolutions
    1 pagesRESOLUTIONS
    Résolutions
    CatégorieDateDescriptionType
    liquidation

    Résolution extraordinaire pour la liquidation

    LRESEX

    Nomination d'un liquidateur volontaire

    1 pages600

    Divers

    Stat of affairs with f 3.10
    20 pagesMISC

    Rapport du séquestre administratif

    13 pages3.10

    legacy

    1 pages287

    Certificat de changement de nom

    Company name changed arthur sanderson & sons,LIMITED\certificate issued on 09/09/03
    2 pagesCERTNM

    legacy

    1 pages288b

    Qui sont les dirigeants de ASSL (REALISATIONS) LIMITED ?

    Dirigeants
    NomNommé leDate de démissionRôleAdresseIdentification de la sociétéPays de résidenceNationalitéDate de naissanceProfessionNuméro
    CORDINGLEY, Judith Anne
    North Green
    The Green, Datchet
    SL3 9JH Slough
    Berkshire
    Administrateur
    North Green
    The Green, Datchet
    SL3 9JH Slough
    Berkshire
    BritishMarketing71377530001
    MCLEAN, John Nigel Major
    Atholl House Church Lane Worplesdon
    GU3 3RU Guildford
    Surrey
    Administrateur
    Atholl House Church Lane Worplesdon
    GU3 3RU Guildford
    Surrey
    United KingdomBritishChartered Accountant1993760001
    WHITFIELD, Steven William
    Avenue House Cottage
    The Green West Drayton
    UB7 7PW Uxbridge
    Middlesex
    Administrateur
    Avenue House Cottage
    The Green West Drayton
    UB7 7PW Uxbridge
    Middlesex
    BritishOperations Director83081090001
    ANDERSON, James Croall Morris
    48 Foxdell Way
    Chalfont St Peter
    SL9 0PN Gerrards Cross
    Buckinghamshire
    Secrétaire
    48 Foxdell Way
    Chalfont St Peter
    SL9 0PN Gerrards Cross
    Buckinghamshire
    British55185960001
    CHILD, Peter Francis
    34 College Road
    SL6 6AT Maidenhead
    Berkshire
    Secrétaire
    34 College Road
    SL6 6AT Maidenhead
    Berkshire
    British10634940001
    DIX, Alan Nigel
    Rowan House Longwater Lane
    Finchampstead
    RG40 4NX Wokingham
    Berkshire
    Secrétaire
    Rowan House Longwater Lane
    Finchampstead
    RG40 4NX Wokingham
    Berkshire
    BritishAccountant56734530002
    DIX, Alan Nigel
    Rowan House Longwater Lane
    Finchampstead
    RG40 4NX Wokingham
    Berkshire
    Secrétaire
    Rowan House Longwater Lane
    Finchampstead
    RG40 4NX Wokingham
    Berkshire
    BritishAccountant56734530002
    SABINE, Mark
    5 Wiggett Grove
    RG42 4DY Binfield
    Berkshire
    Secrétaire
    5 Wiggett Grove
    RG42 4DY Binfield
    Berkshire
    British94365720001
    COWLING, John Philip
    22 World End Lane
    HP22 5SB Weston Turville
    Buckinghamshire
    Administrateur
    22 World End Lane
    HP22 5SB Weston Turville
    Buckinghamshire
    BritishCompany Director33072010001
    DIX, Alan Nigel
    Rowan House Longwater Lane
    Finchampstead
    RG40 4NX Wokingham
    Berkshire
    Administrateur
    Rowan House Longwater Lane
    Finchampstead
    RG40 4NX Wokingham
    Berkshire
    EnglandBritishAccountant56734530002
    FOX, Michael Leonard
    New Place
    Whiteleaf
    HP27 0LY Princes Risborough
    Buckinghamshire
    Administrateur
    New Place
    Whiteleaf
    HP27 0LY Princes Risborough
    Buckinghamshire
    EnglandBritishCompany Director39339680001
    KANE, Richard Anthony
    Lakelands
    Furzen Lane
    RH12 3AP Ellens Green
    West Sussex
    Administrateur
    Lakelands
    Furzen Lane
    RH12 3AP Ellens Green
    West Sussex
    BritishCompany Director43532520001
    PARRY, Michael Andrew
    Fieldsend
    Horseshoes Lane
    OX10 6LB Benson
    Oxfordshire
    Administrateur
    Fieldsend
    Horseshoes Lane
    OX10 6LB Benson
    Oxfordshire
    BritishCommercial Design76753730001
    PARRY, Michael Andrew
    Fieldsend
    Horseshoes Lane
    OX10 6LB Benson
    Oxfordshire
    Administrateur
    Fieldsend
    Horseshoes Lane
    OX10 6LB Benson
    Oxfordshire
    BritishCompany Director76753730001
    ROEF, Petrus Adrianus Wilhelmus
    Villapark 8
    5667 Hv Geldrop
    FOREIGN
    The Netherlands
    Administrateur
    Villapark 8
    5667 Hv Geldrop
    FOREIGN
    The Netherlands
    DutchCompany Director20291130001
    TAYLOR, Alastair Lee
    Limber
    Top Park
    SL9 7PW Gerrards Cross
    Buckinghamshire
    Administrateur
    Limber
    Top Park
    SL9 7PW Gerrards Cross
    Buckinghamshire
    BritishCompany Director936970002
    VALKENAARS, Cornelius Johannes
    Elsdonk 12 5708 Ac
    Helmond
    Holland
    Administrateur
    Elsdonk 12 5708 Ac
    Helmond
    Holland
    DutchCompany Director33512930001
    VAN DER ELST, Jacobus Francois
    Horst 14
    Helmond Nl-5707gx
    The Netherlands
    Administrateur
    Horst 14
    Helmond Nl-5707gx
    The Netherlands
    DutchCompany Director45876170001
    VAN OIJEN, Johannes Gerardus Marie
    Nieuwerf 2
    5951 CA Belfeld
    The Netherlands
    Administrateur
    Nieuwerf 2
    5951 CA Belfeld
    The Netherlands
    DutchCompany Director43437810002

    ASSL (REALISATIONS) LIMITED a-t-elle des charges ?

    Charges
    ClassificationDatesStatutDétails
    Bond over company shares
    Créé le 26 avr. 2001
    Livré le 01 mai 2001
    En cours
    Montant garanti
    The amount of seven million pounds sterling and all interest and other monies due or to become due to the chargee
    Brèves mentions
    30,000 shares with a face value of 100 francs each in arthur sanderson & sons (france) sarl.
    Personnes ayant droit
    • Burdale Financial Limited
    Transactions
    • 01 mai 2001Enregistrement d'une charge (395)
    Rent deposit deed
    Créé le 30 mars 2001
    Livré le 03 avr. 2001
    En cours
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee under a lease of even date
    Brèves mentions
    First fixed charge over £62,000 plus additional monies to be paid by the company from time to time being the equivalent of six months rent payable under the lease dated 30/3/2001.
    Personnes ayant droit
    • Fisher Land (Chelsea) Limited
    Transactions
    • 03 avr. 2001Enregistrement d'une charge (395)
    Deed of debenture
    Créé le 19 mars 2001
    Livré le 20 mars 2001
    En cours
    Montant garanti
    All obligations and liabilities of each obligor to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Specific property charged f/h land and buildings k/a the scotshaw brocar paper mill branch road darwen blackburn lancashire LA521871. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Burdale Financial Limited
    Transactions
    • 20 mars 2001Enregistrement d'une charge (395)
    • 19 août 2003Nomination d'un administrateur ou d'un gestionnaire (405 (1))
    • 21 nov. 2005Avis de cessation d'exercer en tant qu'administrateur ou gestionnaire (405 (2))
      • Numéro de dossier 1
    Rent deposit deed
    Créé le 29 sept. 2000
    Livré le 05 oct. 2000
    En cours
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the deed and the lease of even date defined therein
    Brèves mentions
    £52,689 together with any interest thereon standing to the credit of the account as defined in the rent deposit deed.
    Personnes ayant droit
    • Dewhurst Dent PLC
    Transactions
    • 05 oct. 2000Enregistrement d'une charge (395)
    Mortgage
    Créé le 07 juin 1995
    Livré le 26 juin 1995
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    2 new rapier weaving machines type HTVS4/j ser no's 35391 35392 2 electronic jacquards ser no's F025850929 - F25750929.
    Personnes ayant droit
    • Nws Bank PLC
    Transactions
    • 26 juin 1995Enregistrement d'une charge (395)
    • 28 avr. 2000Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Mortgage debenture
    Créé le 05 déc. 1990
    Livré le 12 déc. 1990
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    A charge by way of legal mortgage over the under mentioned property and the proceeds of sale thereof: 100 acres oxford road, uxbridge mddsx t/no. Bm 110852 and leasehold land t/no. Bm 85799. a specific equitable charge over all freehold and leasehold properties and/or the proceeds of sale thereof fixed and floating charges over undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts and the benefits of any licences.
    Personnes ayant droit
    • National Westminster Bank PLC
    Transactions
    • 12 déc. 1990Enregistrement d'une charge
    • 15 févr. 1993Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)

    ASSL (REALISATIONS) LIMITED a-t-elle des procédures d'insolvabilité ?

    Numéro de dossierDatesTypePraticiensAutre
    1
    DateType
    19 mars 2001Instrument date
    Administrative receiver appointed
    NomRôleAdresseNommé leCessé le
    Neville Barry Kahn
    180 The Strand
    London
    Wc2r 1bl
    practitioner
    180 The Strand
    London
    Wc2r 1bl
    Nicholas Guy Edwards
    Deloitte & Touche
    180 Strand
    WC2R 1WL London
    practitioner
    Deloitte & Touche
    180 Strand
    WC2R 1WL London
    2
    DateType
    20 nov. 2003Commencement of winding up
    05 févr. 2008Dissolved on
    Creditors voluntary liquidation
    NomRôleAdresseNommé leCessé le
    Finbarr O'Connell
    Kpmg Corporate Recovery
    P O Box 695
    EC4Y 8BB 8 Salisbury Square
    London
    practitioner
    Kpmg Corporate Recovery
    P O Box 695
    EC4Y 8BB 8 Salisbury Square
    London
    Richard John Hill
    Kpmg Llp
    100 Temple Street
    BS1 6AG Bristol
    practitioner
    Kpmg Llp
    100 Temple Street
    BS1 6AG Bristol

    Source de données

    • Companies House du Royaume-Uni
      Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers.
    • Licence: CC0