RICHARD SANKEY & SON LIMITED
Vue d'ensemble
Nom de la société | RICHARD SANKEY & SON LIMITED |
---|---|
Statut de la société | Dissoute |
Forme juridique | Société à responsabilité limitée |
Numéro de société | 00074856 |
Juridiction | Angleterre/Pays de Galles |
Date de création | |
Date de cessation d'activité |
Résumé
A des PSCs super sécurisés | Non |
---|---|
A des charges | Oui |
A un historique d'insolvabilité | Oui |
Le siège social est contesté | Non |
Où se situe RICHARD SANKEY & SON LIMITED ?
Adresse du siège social | Kpmg Llp One Snowhill Snow Hill Queensway B4 6GH Birmingham West Midlands |
---|---|
Adresse du siège social non livrable | Non |
Quels sont les derniers comptes de RICHARD SANKEY & SON LIMITED ?
En retard | Oui |
---|---|
Prochains comptes | |
Fin de la prochaine période comptable le | 31 déc. 2014 |
Date d'échéance des prochains comptes | 30 sept. 2015 |
Derniers comptes | |
Derniers comptes arrêtés au | 31 déc. 2013 |
Quels sont les derniers dépôts pour RICHARD SANKEY & SON LIMITED ?
Date | Description | Document | Type | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gazette finale dissoute à la suite d'une liquidation | 1 pages | GAZ2 | ||||||||||
Retour de la réunion finale dans une liquidation volontaire des membres | 6 pages | 4.71 | ||||||||||
Changement d'adresse du siège social de Bennerley Road Bulwell Nottingham Nottinghamshire NG6 8PE à Kpmg Llp One Snowhill Snow Hill Queensway Birmingham West Midlands B4 6GH le 28 nov. 2014 | 2 pages | AD01 | ||||||||||
Nomination d'un liquidateur volontaire | 3 pages | 600 | ||||||||||
Déclaration de solvabilité | 6 pages | 4.70 | ||||||||||
Résolutions Resolutions | RESOLUTIONS | |||||||||||
| ||||||||||||
Cessation de la nomination de Ilkka Tapio Pitkanen en tant que directeur le 12 mai 2014 | 2 pages | TM01 | ||||||||||
Nomination de Max Ernst Alfthan en tant qu'administrateur | 3 pages | AP01 | ||||||||||
Cessation de la nomination de Jutta Karlsson en tant que directeur | 2 pages | TM01 | ||||||||||
Comptes d'exonération totale pour petite entreprise établis au 31 déc. 2013 | 1 pages | AA | ||||||||||
Déclaration annuelle jusqu'au 18 sept. 2013 avec liste complète des actionnaires | 8 pages | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Comptes d'exonération totale pour petite entreprise établis au 31 déc. 2012 | 1 pages | AA | ||||||||||
Modification des coordonnées de l'administrateur Jutta Christina Karlsson le 03 sept. 2013 | 2 pages | CH01 | ||||||||||
Comptes d'exonération totale établis au 31 déc. 2011 | 16 pages | AA | ||||||||||
Nomination de Mr Ilkka Tapio Pitkanen en tant qu'administrateur | 2 pages | AP01 | ||||||||||
Nomination de Mr Axel Goss en tant qu'administrateur | 2 pages | AP01 | ||||||||||
Nomination de Mr John Carlton Grayson en tant qu'administrateur | 2 pages | AP01 | ||||||||||
Cessation de la nomination de Teemu Kangas-Karki en tant que directeur | 1 pages | TM01 | ||||||||||
Déclaration annuelle jusqu'au 18 sept. 2012 avec liste complète des actionnaires | 6 pages | AR01 | ||||||||||
Cessation de la nomination de Andrew Smith en tant que directeur | 1 pages | TM01 | ||||||||||
Modification des coordonnées de l'administrateur Teemu Johannes Kangas-Karki le 20 juin 2012 | 2 pages | CH01 | ||||||||||
Comptes annuels établis au 31 déc. 2010 | 22 pages | AA | ||||||||||
Déclaration annuelle jusqu'au 18 sept. 2011 avec liste complète des actionnaires | 7 pages | AR01 | ||||||||||
Déclaration annuelle jusqu'au 18 sept. 2010 avec liste complète des actionnaires | 7 pages | AR01 | ||||||||||
Les registres ont été transférés au lieu d'inspection enregistré | 1 pages | AD03 | ||||||||||
Qui sont les dirigeants de RICHARD SANKEY & SON LIMITED ?
Nom | Nommé le | Date de démission | Rôle | Adresse | Identification de la société | Pays de résidence | Nationalité | Date de naissance | Profession | Numéro |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HARROLD, Tracy | Secrétaire | Snow Hill Queensway B4 6GH Birmingham Kpmg Llp One Snowhill West Midlands | British | 151795590001 | ||||||
ALFTHAN, Max Ernst | Administrateur | Hameentie 135a PO BOX 130 FI-00561 Helsinki Fiskars Corporation 135a Helsinki Finland | Finland | Finnish | Chief Strategy Officer | 187967630001 | ||||
GOSS, Axel | Administrateur | Konrad-Zose-Platz 8 81829 Munich Fiskars Munich Germany | England | German | President Sales Region Central | 173980350001 | ||||
GRAYSON, John Carlton | Administrateur | Bennerley Road NG6 8PE Bulwell C/O Fiskars Uk Nottinghamshire United Kingdom | United Kingdom | British | Managing Director | 100686150001 | ||||
CHEETHAM, Terence George | Secrétaire | 442 Nuthall Road Aspley NG8 5DQ Nottingham Nottinghamshire | British | 17351160001 | ||||||
KELLY, Peter Joseph | Secrétaire | Pandy Park Aberkenfig CF32 9RE Bridgend 5 Mid Glamorgan | British | 131533800001 | ||||||
TREVES, Vanni Emanuele | Secrétaire | 4 Alwyne Place Canonbury N1 2NL London | British | Solicitor | 24700970003 | |||||
ALLONEN, Heikki | Administrateur | Katajanokanranta 1 B 22 Helsinki FOREIGN 00160 Finland | Finnish | Company Director | 93652260001 | |||||
DENTON, William John | Administrateur | 2175 Serene Circle Brookfield Wisconsin 53045 Usa | American | Director | 73766510001 | |||||
FETHKE, Wayne George | Administrateur | 3017 Woodland Drive Middleton Wisconsin 53562 Usa | Us American | Director President | 62199170002 | |||||
FRASER, Ian Ford | Administrateur | The Bothy Welbeck S80 3LW Worksop Nottinghamshire | British | Director | 17335680002 | |||||
KANGAS-KARKI, Teemu Johannes | Administrateur | 02700 Kauniainen Asematie 41 B Finland | Finnish | President-Fiskars Home Businessarea | 135747690001 | |||||
KARLSSON, Jutta Christina | Administrateur | Hämeentie 135a 00560 Helsinki C/O Fiskars Oyj Abp Finland | Finland | Finnish | Company Director | 196388730001 | ||||
KINT, Francis Jacques Louis, Director | Administrateur | Kastanjeslaan 4 Kraainem 1750 Belgium | Belgium | Belgian | Director | 247828190001 | ||||
LANGENSKIOLD, Bertel Anders | Administrateur | Ulrikagatan 1a Fin 00140 Helsingfors Finland | Finnish | Director | 73765940001 | |||||
MACQUEEN, Ian Malcolm | Administrateur | 82 St Thomas Street BA5 2UZ Wells Somerset | British | Company Director | 27550100001 | |||||
PICCART, Elly Christina Hendrika | Administrateur | Kraainem Kapellelaan 43 1950 Belgium | Belgium | Belgium | Company Director | 148530110001 | ||||
PITKANEN, Ilkka Tapio | Administrateur | Hämeentie 135 A Helsinki Fiskars Oyj Abp 00560 Finland | Finland | Finnish | Cfo | 173980960001 | ||||
PURDIN, James Steven | Administrateur | 899 Katie Lane Oregon Wisconsin 53575 Usa | U.S. American | Director | 105290110001 | |||||
RAUHALA, Juha Vilho | Administrateur | Murtokatu 6 As 1 Fi 04400 Jarvenpaa Finland | Finnish | Company Director | 131344770001 | |||||
RUSSO, Antonio | Administrateur | Avenue De L Horizon 9 FOREIGN Brussels 1150 Belgium | Italian | Company Director | 93652210001 | |||||
SHARPE, John Jeffrey | Administrateur | Rose Cottage Borrow Bread Lane NG14 7GB Bleasby Nottinghamshire | British | Director | 17335690002 | |||||
SMITH, Andrew James | Administrateur | Maendy Ganol Maendy Cowbridge CF71 7TH Vale Of Glamorgan 1 | United Kingdom | British | Managing Director (Uk) | 250874980001 | ||||
STENDAHL, Stig Gunnar | Administrateur | Lohepyrsto 1 E FOREIGN Helsinki 00650 Finland | Finnish | President-Fiskars Oy Ab | 32286710001 | |||||
TREVES, Vanni Emanuele | Administrateur | 4 Alwyne Place Canonbury N1 2NL London | England | British | Solicitor | 24700970003 |
RICHARD SANKEY & SON LIMITED a-t-elle des charges ?
Classification | Dates | Statut | Détails | |
---|---|---|---|---|
Fixed charge | Créé le 16 mars 1994 Livré le 17 mars 1994 | Totalement satisfaite | Montant garanti £100,000.00 due from the company to the chargee | |
Brèves mentions Fixed charge over 1 netstal injection moulding machine model neomat 580/160 mp no 9350112 ser no 9350112 together with accessories. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
Legal charge | Créé le 17 oct. 1990 Livré le 30 oct. 1990 | Totalement satisfaite | Montant garanti All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brèves mentions By way of legal mortgage l/h property on the east side of dabell avenue bulwell, nottingham, nottinghamshire. Title no. Nt 131534 by way of fixed charge all plant machinery implements utensils furniture and equipment. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
Debenture | Créé le 17 juin 1987 Livré le 18 juin 1987 | En cours | Montant garanti All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brèves mentions Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
Fixed and floating charge | Créé le 22 août 1986 Livré le 29 août 1986 | Totalement satisfaite | Montant garanti All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brèves mentions First fixed charge on all book and other debts floating charge on all the. Undertaking and all property and assets present and future including uncalled capital. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
Debenture | Créé le 24 mars 1983 Livré le 08 avr. 1983 | Totalement satisfaite | Montant garanti All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brèves mentions A specific equitable charge over all f/h and l/h properties and/or the proceeds of sale thereof.fixed and floating charges over the undertaking and all other property an assets present and future inc. Goodwill and bookdebts. Legal mortgage over land on the north east side of dabell avenue bulwell also known as 3.89 acres (approx.) of land at dabell avenue freestone drive and bennerley road,blenheim industrial estate,bulwell,nottingham title no:-nt 131534 and /or the proceeds of sale thereof. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
Mortgage | Créé le 05 août 1982 Livré le 12 août 1982 | Totalement satisfaite | Montant garanti All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brèves mentions Land on the north east side of dabell avenue bulwell nottingham title no nt 131534. floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
|
RICHARD SANKEY & SON LIMITED a-t-elle des procédures d'insolvabilité ?
Numéro de dossier | Dates | Type | Praticiens | Autre | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
| Members voluntary liquidation |
|
Source de données
- Companies House du Royaume-Uni
Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers. - Licence: CC0