RELX PLC

  • Vue d'ensemble
  • Résumé
  • Objet social
  • Adresse
  • Dénominations sociales précédentes
  • Comptes
  • Déclaration de confirmation
  • Dépôts
  • Dirigeants
  • Source de données
  • Vue d'ensemble

    Nom de la sociétéRELX PLC
    Statut de la sociétéActive
    Forme juridiqueSociété anonyme cotée en bourse
    Numéro de société 00077536
    JuridictionAngleterre/Pays de Galles
    Date de création

    Résumé

    A des PSCs super sécurisésNon
    A des chargesNon
    A un historique d'insolvabilitéNon
    Le siège social est contestéNon

    Quel est l'objet de RELX PLC ?

    • Édition de livres (58110) / Information et communication
    • Édition de revues grand public et professionnelles (58142) / Information et communication
    • Autres activités d'édition (58190) / Information et communication
    • Autres activités d'édition de logiciels (58290) / Information et communication

    Où se situe RELX PLC ?

    Adresse du siège social
    1-3 Strand
    London
    WC2N 5JR
    Adresse du siège social non livrableNon

    Quels étaient les noms précédents de RELX PLC ?

    Dénominations sociales précédentes
    Nom de la sociétéDeJusqu'au
    REED ELSEVIER PLC19 avr. 200219 avr. 2002
    REED INTERNATIONAL P.L.C.28 mai 190328 mai 1903

    Quels sont les derniers comptes de RELX PLC ?

    En retardNon
    Prochains comptes
    Fin de la prochaine période comptable le31 déc. 2025
    Date d'échéance des prochains comptes30 juin 2026
    Derniers comptes
    Derniers comptes arrêtés au31 déc. 2024

    Quel est le statut de la dernière déclaration de confirmation pour RELX PLC ?

    Dernière déclaration de confirmation établie jusqu'au14 juin 2026
    Date d'échéance de la prochaine déclaration de confirmation28 juin 2026
    Dernière déclaration de confirmation
    Prochaine déclaration de confirmation établie jusqu'au14 juin 2025
    En retardNon

    Quels sont les derniers dépôts pour RELX PLC ?

    Dépôts
    DateDescriptionDocumentType

    État du capital après une attribution d'actions au 28 févr. 2026

    • Capital: GBP 263,996,074.37
    4 pagesSH01

    État du capital après une attribution d'actions au 31 janv. 2026

    • Capital: GBP 263,980,826.96
    4 pagesSH01

    Rachat d'actions propres.

    4 pagesSH03
    Annotations
    DateAnnotation
    05 févr. 2026Clarification HMRC confirmation received that appropriate duty has been paid on this repurchase.

    Rachat d'actions propres. Actions achetées pour le trésor:

    • Capital: GBP 46,162,448.158467
    4 pagesSH03
    Annotations
    DateAnnotation
    05 févr. 2026Clarification HMRC confirmation received that appropriate duty has been paid on this repurchase.

    Rachat d'actions propres. Actions achetées pour le trésor:

    • Capital: GBP 46,209,015.868467
    4 pagesSH03
    Annotations
    DateAnnotation
    05 févr. 2026Clarification HMRC confirmation received that appropriate duty has been paid on this repurchase.

    Rachat d'actions propres. Actions achetées pour le trésor:

    • Capital: GBP 46,287,143.201415
    4 pagesSH03
    Annotations
    DateAnnotation
    05 févr. 2026Clarification HMRC confirmation received that appropriate duty has been paid on this repurchase.

    Rachat d'actions propres. Actions achetées pour le trésor:

    • Capital: GBP 46,310,621.991015
    4 pagesSH03
    Annotations
    DateAnnotation
    05 févr. 2026Clarification HMRC confirmation received that appropriate duty has been paid on this repurchase.

    Rachat d'actions propres. Actions achetées pour le trésor:

    • Capital: GBP 46,400,805.234795
    4 pagesSH03
    Annotations
    DateAnnotation
    05 févr. 2026Clarification HMRC confirmation received that appropriate duty has been paid on this repurchase.

    Rachat d'actions propres. Actions achetées pour le trésor:

    • Capital: GBP 46,635,465.051543
    4 pagesSH03
    Annotations
    DateAnnotation
    05 févr. 2026Clarification HMRC confirmation received that appropriate duty has been paid on this repurchase.

    Rachat d'actions propres. Actions achetées pour le trésor:

    • Capital: GBP 46,855,797.319587
    4 pagesSH03
    Annotations
    DateAnnotation
    05 févr. 2026Clarification HMRC confirmation received that appropriate duty has been paid on this repurchase.

    État du capital après une attribution d'actions au 31 déc. 2025

    • Capital: GBP 263,963,863.25
    4 pagesSH01

    État du capital après une attribution d'actions au 30 nov. 2025

    • Capital: GBP 27,189,492,140
    4 pagesSH01

    État du capital au 04 déc. 2025

    • Capital: GBP 263,953,191.77
    4 pagesSH05

    Rachat d'actions propres. Actions achetées pour le trésor:

    • Capital: GBP 46,081,532.105571
    4 pagesSH03
    Annotations
    DateAnnotation
    17 déc. 2025Clarification HMRC confirmation received that appropriate duty has been paid on this repurchase.

    État du capital après une attribution d'actions au 31 oct. 2025

    • Capital: GBP 271,882,252.04
    4 pagesSH01

    Rachat d'actions propres. Actions achetées pour le trésor:

    • Capital: GBP 53,661,157.263039
    4 pagesSH03
    Annotations
    DateAnnotation
    14 nov. 2025Clarification HMRC confirmation received that appropriate duty has been paid on this transaction.

    Rachat d'actions propres. Actions achetées pour le trésor:

    • Capital: GBP 53,750,157.903579
    4 pagesSH03
    Annotations
    DateAnnotation
    14 nov. 2025Clarification HMRC confirmation received that appropriate duty has been paid on this transaction.

    Rachat d'actions propres. Actions achetées pour le trésor:

    • Capital: GBP 53,839,158.110931
    4 pagesSH03
    Annotations
    DateAnnotation
    14 nov. 2025Clarification HMRC confirmation received that appropriate duty has been paid on this transaction.

    Rachat d'actions propres. Actions achetées pour le trésor:

    • Capital: GBP 53,925,195.745551
    4 pagesSH03

    Rachat d'actions propres. Actions achetées pour le trésor:

    • Capital: GBP 53,994,054.876843
    4 pagesSH03

    État du capital après une attribution d'actions au 30 sept. 2025

    • Capital: GBP 271,825,166.02
    4 pagesSH01

    État du capital après une attribution d'actions au 31 août 2025

    • Capital: GBP 271,812,446.27
    4 pagesSH01

    Modification des coordonnées de l'administrateur Mrs June Yee Felix le 14 sept. 2025

    2 pagesCH01

    État du capital après une attribution d'actions au 31 juil. 2025

    • Capital: GBP 271,797,341.53
    4 pagesSH01

    Rachat d'actions propres. Actions achetées pour le trésor:

    • Capital: GBP 52,579,508.342043
    4 pagesSH03
    Annotations
    DateAnnotation
    04 août 2025Clarification HMRC confirmation received that appropriate duty has been paid on this repurchase

    Qui sont les dirigeants de RELX PLC ?

    Dirigeants
    NomNommé leDate de démissionRôleAdresseIdentification de la sociétéPays de résidenceNationalitéDate de naissanceProfessionNuméro
    UDOW, Henry Adam
    Strand
    WC2N 5JR London
    1-3
    United Kingdom
    Secrétaire
    Strand
    WC2N 5JR London
    1-3
    United Kingdom
    161878910001
    COX, Alistair Richard
    1-3 Strand
    London
    WC2N 5JR
    Administrateur
    1-3 Strand
    London
    WC2N 5JR
    United KingdomBritish308641510001
    ENGSTROM, Erik
    Strand
    WC2N 5JR London
    1-3
    United Kingdom
    Administrateur
    Strand
    WC2N 5JR London
    1-3
    United Kingdom
    EnglandSwedish100146250002
    FELIX, June Yee
    Strand
    WC2N 5JR London
    1-3
    United Kingdom
    Administrateur
    Strand
    WC2N 5JR London
    1-3
    United Kingdom
    United StatesAmerican200884330002
    HALFORD, Andrew Nigel
    1-3 Strand
    London
    WC2N 5JR
    Administrateur
    1-3 Strand
    London
    WC2N 5JR
    United KingdomBritish335394280001
    HOGG, Charlotte Mary
    Strand
    WC2N 5JR London
    1-3
    United Kingdom
    Administrateur
    Strand
    WC2N 5JR London
    1-3
    United Kingdom
    United KingdomBritish,American233664850004
    LUFF, Nicholas Lawrence
    Strand
    WC2N 5JR London
    1-3
    United Kingdom
    Administrateur
    Strand
    WC2N 5JR London
    1-3
    United Kingdom
    United KingdomBritish190866500001
    SUKAWATY, Andrew John
    Strand
    WC2N 5JR London
    1-3
    United Kingdom
    Administrateur
    Strand
    WC2N 5JR London
    1-3
    United Kingdom
    United StatesAmerican258131490001
    TETTEROO, Bianca Elisabeth Maria
    1-3 Strand
    London
    WC2N 5JR
    Administrateur
    1-3 Strand
    London
    WC2N 5JR
    NetherlandsDutch327080180002
    WALKER, Paul Ashton
    Strand
    WC2N 5JR London
    1-3
    United Kingdom
    Administrateur
    Strand
    WC2N 5JR London
    1-3
    United Kingdom
    United KingdomBritish19807800003
    WOOD, Suzanne
    Strand
    WC2N 5JR London
    1-3
    United Kingdom
    Administrateur
    Strand
    WC2N 5JR London
    1-3
    United Kingdom
    United StatesAmerican170649810003
    BAKER, Richard Gordon
    Highbank House 19 The Street
    West Horsley
    KT24 6BA Leatherhead
    Surrey
    Secrétaire
    Highbank House 19 The Street
    West Horsley
    KT24 6BA Leatherhead
    Surrey
    British63744750001
    COWDEN, Stephen John
    13 Weybridge Park
    KT13 8SL Weybridge
    Mareeba Lodge
    Surrey
    United Kingdom
    Secrétaire
    13 Weybridge Park
    KT13 8SL Weybridge
    Mareeba Lodge
    Surrey
    United Kingdom
    British510780002
    RADCLIFFE, Willoughby Mark St John
    14 The Orchard
    Bedford Park
    W4 1JX London
    Secrétaire
    14 The Orchard
    Bedford Park
    W4 1JX London
    British32447610001
    RICHARDSON, Karen Diana
    Lakeview
    53 Woodside
    SW19 7AF London
    Secrétaire
    Lakeview
    53 Woodside
    SW19 7AF London
    British38091040001
    ARMOUR, Mark Henry
    Strand
    WC2N 5JR London
    1-3
    United Kingdom
    Administrateur
    Strand
    WC2N 5JR London
    1-3
    United Kingdom
    United KingdomBritish58001830003
    BODMAN, Richard Stockwell
    4930 Loughboro Road
    Washington
    Dc 20016
    Usa
    Administrateur
    4930 Loughboro Road
    Washington
    Dc 20016
    Usa
    American47997010001
    BROCK, John Franklin
    Jesus Eiklaan 119
    B-3080 Tervuren
    Belgium
    Administrateur
    Jesus Eiklaan 119
    B-3080 Tervuren
    Belgium
    American46194530003
    BRUGGINK, Herman
    Ravensweerdsweg 20
    7213 Dx Gorssel
    FOREIGN The Netherlands
    Administrateur
    Ravensweerdsweg 20
    7213 Dx Gorssel
    FOREIGN The Netherlands
    Dutch43120890001
    DAVIS, Crispin Henry Lamert, Sir
    1-3 Strand
    WC2N 5JR London
    Administrateur
    1-3 Strand
    WC2N 5JR London
    British141318830002
    DAVIS, Peter John, Sir
    20 Chester Row
    SW1W 9JH London
    Administrateur
    20 Chester Row
    SW1W 9JH London
    British11848680002
    ELLIOT, Mark Wynne
    Strand
    WC2N 5JR London
    1-3
    United Kingdom
    Administrateur
    Strand
    WC2N 5JR London
    1-3
    United Kingdom
    UsaAmerican90417400008
    GREENER, Anthony Armitage, Sir
    26 Hamilton House
    Vicarage Gate
    W8 4HL London
    Administrateur
    26 Hamilton House
    Vicarage Gate
    W8 4HL London
    United KingdomBritish52841020001
    HAANK, Derk
    Pasplein 6
    Doetinchem
    7001 Gc
    Netherlands
    Administrateur
    Pasplein 6
    Doetinchem
    7001 Gc
    Netherlands
    NetherlandsDutch141928080001
    HABGOOD, Anthony John, Sir
    Strand
    WC2N 5JR London
    1-3
    England
    Administrateur
    Strand
    WC2N 5JR London
    1-3
    England
    United KingdomBritish28340960009
    HAMLYN, Paul Bertrand Wolfgang, Lord
    64 Old Church Street
    Chelsea
    SW3 6EP London
    Administrateur
    64 Old Church Street
    Chelsea
    SW3 6EP London
    British1968440001
    HAUSER, Wolfhart Gunnar
    Strand
    WC2N 5JR London
    1-3
    United Kingdom
    Administrateur
    Strand
    WC2N 5JR London
    1-3
    United Kingdom
    GermanyGerman178073150004
    HENNAH, Adrian
    Strand
    WC2N 5JR London
    1-3
    United Kingdom
    Administrateur
    Strand
    WC2N 5JR London
    1-3
    United Kingdom
    United KingdomBritish159774620001
    HOMMEN, Johannes Henricus Maria
    Hondsbergselaan 14
    5062 Js Oisterwijk
    The Netherlands
    Administrateur
    Hondsbergselaan 14
    5062 Js Oisterwijk
    The Netherlands
    Dutch104893940001
    HOOK, Lisa Ann
    Strand
    WC2N 5JR London
    1-3
    United Kingdom
    Administrateur
    Strand
    WC2N 5JR London
    1-3
    United Kingdom
    United StatesAmerican113503930003
    IRVINE, Ian Alexander Noble
    14 Tregunter Road
    SW10 9LR London
    Administrateur
    14 Tregunter Road
    SW10 9LR London
    British53758680001
    KRAKOFF, Robert
    257 Commonwealth Avenue 5
    Boston
    02116 Massachusetts
    Usa
    Administrateur
    257 Commonwealth Avenue 5
    Boston
    02116 Massachusetts
    Usa
    Us50889450001
    LEWINTON, Christopher, Sir
    Downs House
    Letcombe Bassett
    OX12 9LW Wantage
    Oxfordshire
    Administrateur
    Downs House
    Letcombe Bassett
    OX12 9LW Wantage
    Oxfordshire
    EnglandBritish15298750001
    MACLEOD, Robert James
    Strand
    WC2N 5JR London
    1-3
    United Kingdom
    Administrateur
    Strand
    WC2N 5JR London
    1-3
    United Kingdom
    United KingdomBritish90186680002
    MELLON, John Benedict
    Apartment 40 Dundee Court
    73 Wapping High Street
    E1 9YG London
    Administrateur
    Apartment 40 Dundee Court
    73 Wapping High Street
    E1 9YG London
    British35523050003

    Source de données

    • Companies House du Royaume-Uni
      Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers.
    • Licence: CC0