DB DELAWARE HOLDINGS (UK) LIMITED

DB DELAWARE HOLDINGS (UK) LIMITED

  • Vue d'ensemble
  • Résumé
  • Objet social
  • Adresse
  • Dénominations sociales précédentes
  • Comptes
  • Dépôts
  • Dirigeants
  • Charges
  • Insolvabilité
  • Source de données
  • Vue d'ensemble

    Nom de la sociétéDB DELAWARE HOLDINGS (UK) LIMITED
    Statut de la sociétéDissoute
    Forme juridiqueSociété à responsabilité limitée
    Numéro de société 00090708
    JuridictionAngleterre/Pays de Galles
    Date de création
    Date de cessation d'activité

    Résumé

    A des PSCs super sécurisésNon
    A des chargesOui
    A un historique d'insolvabilitéOui
    Le siège social est contestéNon

    Quel est l'objet de DB DELAWARE HOLDINGS (UK) LIMITED ?

    • Activités des sièges sociaux (70100) / Activités spécialisées, scientifiques et techniques

    Où se situe DB DELAWARE HOLDINGS (UK) LIMITED ?

    Adresse du siège social
    15 Canada Square
    E14 5GL London
    Adresse du siège social non livrableNon

    Quels étaient les noms précédents de DB DELAWARE HOLDINGS (UK) LIMITED ?

    Dénominations sociales précédentes
    Nom de la sociétéDeJusqu'au
    BANKERS TRUST HOLDINGS (U.K.) LIMITED31 déc. 197631 déc. 1976
    RODO INVESTMENT TRUST LIMITED06 nov. 190606 nov. 1906

    Quels sont les derniers comptes de DB DELAWARE HOLDINGS (UK) LIMITED ?

    Derniers comptes
    Derniers comptes arrêtés au31 déc. 2015

    Quels sont les derniers dépôts pour DB DELAWARE HOLDINGS (UK) LIMITED ?

    Dépôts
    DateDescriptionDocumentType

    Gazette finale dissoute à la suite d'une liquidation

    1 pagesGAZ2

    Retour de la réunion finale dans une liquidation volontaire des membres

    6 pagesLIQ13

    Déclaration des reçus et paiements des liquidateurs jusqu'à 26 oct. 2017

    6 pagesLIQ03

    Changement d'adresse du siège social de Winchester House 1 Great Winchester Street London EC2N 2DB à 15 Canada Square London E14 5GL le 18 nov. 2016

    2 pagesAD01

    Nomination d'un liquidateur volontaire

    2 pages600

    Déclaration de solvabilité

    3 pages4.70

    Résolutions

    Resolutions
    1 pagesRESOLUTIONS
    Résolutions
    CatégorieDateDescriptionType
    liquidation

    Résolution spéciale pour la liquidation au 27 oct. 2016

    LRESSP

    Comptes annuels établis au 31 déc. 2015

    13 pagesAA

    legacy

    2 pagesSH20

    État du capital au 11 août 2016

    • Capital: USD 100
    5 pagesSH19

    legacy

    2 pagesCAP-SS

    Résolutions

    Resolutions
    2 pagesRESOLUTIONS
    Résolutions
    CatégorieDateDescriptionType
    capital

    Résolution de réduction du capital social émis

    RES06

    Déclaration annuelle jusqu'au 31 janv. 2016 avec liste complète des actionnaires

    5 pagesAR01
    Dépôts associés
    CatégorieDateDescriptionType
    capital10 févr. 2016

    État du capital au 10 févr. 2016

    • Capital: USD 10,000,000
    SH01

    Nomination de Mr Robin Smith en tant que secrétaire le 14 août 2015

    2 pagesAP03

    Cessation de la nomination de Adam Paul Rutherford en tant que secrétaire le 14 août 2015

    1 pagesTM02

    Comptes annuels établis au 31 déc. 2014

    11 pagesAA

    Déclaration annuelle jusqu'au 31 janv. 2015 avec liste complète des actionnaires

    5 pagesAR01
    Dépôts associés
    CatégorieDateDescriptionType
    capital23 févr. 2015

    État du capital au 23 févr. 2015

    • Capital: USD 10,000,000
    SH01

    Comptes annuels établis au 31 déc. 2013

    14 pagesAA

    Divers

    S.519 companies act 2006
    1 pagesMISC

    Divers

    Section 519
    1 pagesMISC

    Déclaration annuelle jusqu'au 31 janv. 2014 avec liste complète des actionnaires

    5 pagesAR01
    Dépôts associés
    CatégorieDateDescriptionType
    capital27 févr. 2014

    État du capital au 27 févr. 2014

    • Capital: USD 10,000,000
    SH01

    Modification des coordonnées de l'administrateur Mr David Kenyon Thomas le 24 févr. 2014

    2 pagesCH01

    Comptes annuels établis au 31 déc. 2012

    12 pagesAA

    Déclaration annuelle jusqu'au 31 janv. 2013 avec liste complète des actionnaires

    7 pagesAR01

    État du capital au 04 déc. 2012

    • Capital: USD 10,000,000
    4 pagesSH19

    Qui sont les dirigeants de DB DELAWARE HOLDINGS (UK) LIMITED ?

    Dirigeants
    NomNommé leDate de démissionRôleAdresseIdentification de la sociétéPays de résidenceNationalitéDate de naissanceProfessionNuméro
    SMITH, Robin
    1 Great Winchester Street
    EC2N 2DB London
    Winchester House
    United Kingdom
    Secrétaire
    1 Great Winchester Street
    EC2N 2DB London
    Winchester House
    United Kingdom
    202537790001
    CRAIG, Benedict
    1 Great Winchester Street
    EC2N 2DB London
    Winchester House
    United Kingdom
    Administrateur
    1 Great Winchester Street
    EC2N 2DB London
    Winchester House
    United Kingdom
    United KingdomBritish154692820001
    THOMAS, David Kenyon
    1 Great Winchester Street
    EC2N 2DB London
    Winchester House
    England
    England
    Administrateur
    1 Great Winchester Street
    EC2N 2DB London
    Winchester House
    England
    England
    United KingdomBritish59397060006
    BACKHOUSE, Claire Fiona
    71 Stradella Road
    Herne Hill
    SE24 9HL London
    Secrétaire
    71 Stradella Road
    Herne Hill
    SE24 9HL London
    Bvitish14574570005
    CLARK, Giles Sebastian
    20 Barton Road
    W14 9HD London
    Secrétaire
    20 Barton Road
    W14 9HD London
    British38517290001
    PELLOW, Ian Anthony
    6 Meadowside
    Tilehurst
    RG31 5QE Reading
    Berkshire
    Secrétaire
    6 Meadowside
    Tilehurst
    RG31 5QE Reading
    Berkshire
    British33098310002
    RUTHERFORD, Adam Paul
    1 Great Winchester Street
    EC2N 2DB London
    Winchester House
    Secrétaire
    1 Great Winchester Street
    EC2N 2DB London
    Winchester House
    British70451850004
    BERRY, John Charles
    12 Leacroft Avenue
    SW12 8NF Balham
    London
    Administrateur
    12 Leacroft Avenue
    SW12 8NF Balham
    London
    New Zealander56358020004
    BLASE, Steven Wim
    26 Coleherne Court
    The Little Boltons
    SW5 0DL London
    Administrateur
    26 Coleherne Court
    The Little Boltons
    SW5 0DL London
    Dutch56358060001
    BURKE, Peter Robert
    11 Belvedere Grove
    Wimbledon
    SW19 7RQ London
    Administrateur
    11 Belvedere Grove
    Wimbledon
    SW19 7RQ London
    UkBritish106485040001
    COOK, Brian Ronald
    19 Hither Chantlers
    Langton Green
    TN3 0BL Tunbridge Wells
    Kent
    Administrateur
    19 Hither Chantlers
    Langton Green
    TN3 0BL Tunbridge Wells
    Kent
    EnglandBritish1667230001
    CROSS, James Stephen
    44 Romney Drive
    BR1 2TE Bromley
    Kent
    Administrateur
    44 Romney Drive
    BR1 2TE Bromley
    Kent
    EnglandBritish31485080001
    DE BALMANN, Christian Marie Yves
    8 Randolph Road
    Maida Vale
    W9 London
    Administrateur
    8 Randolph Road
    Maida Vale
    W9 London
    French American36586340001
    ELY, David Charles
    47 Yester Road
    BR7 5HN Chislehurst
    Kent
    Administrateur
    47 Yester Road
    BR7 5HN Chislehurst
    Kent
    EnglandEnglish7859080001
    FLETCHER, Geoffrey Martin
    27 Doneraile Street
    SW6 6EL London
    Administrateur
    27 Doneraile Street
    SW6 6EL London
    British14865930001
    GRAHAM, Andrew Mcculloch
    Chandlers Lower Ham Road
    Elstead
    GU8 6HQ Godalming
    Surrey
    Administrateur
    Chandlers Lower Ham Road
    Elstead
    GU8 6HQ Godalming
    Surrey
    British47027390001
    HALE, Matthew John
    10 Pelham Square
    BN1 4ET Brighton
    East Sussex
    Administrateur
    10 Pelham Square
    BN1 4ET Brighton
    East Sussex
    British82905890001
    HARRISON, Nicholas Dudley
    105 Tattenham Cres
    KT18 5NY Epsom Downs
    Surrey
    Administrateur
    105 Tattenham Cres
    KT18 5NY Epsom Downs
    Surrey
    British141445840001
    KEEN, David Dorian Oliver
    1 Great Winchester Street
    EC2N 2DB London
    Winchester House
    Administrateur
    1 Great Winchester Street
    EC2N 2DB London
    Winchester House
    PhilippinesBritish77637490003
    MACFARLANE, Stuart Edward
    6 Lynmouth Road
    East Finchley
    N2 9LS London
    Administrateur
    6 Lynmouth Road
    East Finchley
    N2 9LS London
    Australian125721120002
    MCGIDDY, Mark Andrew
    Great Winchester Street
    EC2N 2DB London
    Winchester House 1
    Administrateur
    Great Winchester Street
    EC2N 2DB London
    Winchester House 1
    Australian114990900003
    QUANE, Thomas Michael
    New Holme 20 Mizen Way
    KT11 2RH Cobham
    Surrey
    Administrateur
    New Holme 20 Mizen Way
    KT11 2RH Cobham
    Surrey
    American60019800002
    RAMSAY, Alan Stuart
    49 Pickwick Road
    Dulwich Village
    SE21 7JN London
    Administrateur
    49 Pickwick Road
    Dulwich Village
    SE21 7JN London
    British58474830001
    SIVANITHY, Rajanbabu
    1 Great Winchester Street
    EC2N 2DB London
    Winchester House
    Administrateur
    1 Great Winchester Street
    EC2N 2DB London
    Winchester House
    United KingdomBritish63268810003
    VASUDEVA, Nicholas Shashi
    57 Linden Gardens
    W2 4HJ London
    Flat 1
    Administrateur
    57 Linden Gardens
    W2 4HJ London
    Flat 1
    British/Australian79508880002

    DB DELAWARE HOLDINGS (UK) LIMITED a-t-elle des charges ?

    Charges
    ClassificationDatesStatutDétails
    Deed of agreement
    Créé le 08 avr. 1998
    Livré le 27 avr. 1998
    En cours
    Montant garanti
    The claims of senior creditors (as defined) to the extent that,in the case of each senior creditor,such senior creditor's claim is not satisfied out of other resources of the borrower
    Brèves mentions
    The undertakings and agreements of the lender in clause 7.3 of the agreement. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • All Senior Creditors
    Transactions
    • 27 avr. 1998Enregistrement d'une charge (395)
    Deed of agreement
    Créé le 08 avr. 1998
    Livré le 27 avr. 1998
    En cours
    Montant garanti
    The claims of senior creditors (as defined) to the extent that,in the case of each senior creditor (as defined),such senior creditor's claim is not satisfied out of other resources of the borrower
    Brèves mentions
    Any amounts credited to the lender in contravention of clause 7.3.2 of the agreement.
    Personnes ayant droit
    • All Senior Creditors
    Transactions
    • 27 avr. 1998Enregistrement d'une charge (395)
    Deed of agreement
    Créé le 29 déc. 1995
    Livré le 03 janv. 1996
    En cours
    Montant garanti
    The claims of senior creditors (as defined) to the extent that,in the case of each senior creditor,such senior creditor's claim is not satisfied out of other resources of the the company (the "borrower")
    Brèves mentions
    The undertakings and agreements of the lender in clause 7.3 of the agreement. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • All Senior Creditors(As Defined)
    Transactions
    • 03 janv. 1996Enregistrement d'une charge (395)
    Deed of agreement
    Créé le 29 déc. 1995
    Livré le 03 janv. 1996
    En cours
    Montant garanti
    The claims of senior creditors (as defined) to the extent that,in the case of each senior creditor,such senior creditor's claim is not satisfied out of other resources of bankers trust international PLC (the "borrower")
    Brèves mentions
    Any amounts credited to the lender in contravention of the provisions of clause 7.3.2 of the agreement or as a result of a breach by the borrower of clause 7.2. see the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • All Senior Creditors
    Transactions
    • 03 janv. 1996Enregistrement d'une charge (395)
    Deed of agreement
    Créé le 25 juin 1992
    Livré le 27 juin 1992
    En cours
    Montant garanti
    For securing amounts owing to creditors of bankers trust international PLC (the borrower) not being subordinated creditors (as defined) or trustees for subordinated creditors.
    Brèves mentions
    Any amounts payable to and received by the lender under the deed of agreement after the commencement of proceedings for the winding up of the borrower.
    Personnes ayant droit
    • The Creditors (As Defined)
    Transactions
    • 27 juin 1992Enregistrement d'une charge (395)

    DB DELAWARE HOLDINGS (UK) LIMITED a-t-elle des procédures d'insolvabilité ?

    Numéro de dossierDatesTypePraticiensAutre
    1
    DateType
    17 juil. 2018Dissolved on
    27 oct. 2016Commencement of winding up
    Members voluntary liquidation
    NomRôleAdresseNommé leCessé le
    John David Thomas Milsom
    15 Canada Square
    E14 5GL London
    practitioner
    15 Canada Square
    E14 5GL London
    Mark Jeremy Orton
    15 Canada Square
    E14 5GL London
    practitioner
    15 Canada Square
    E14 5GL London

    Source de données

    • Companies House du Royaume-Uni
      Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers.
    • Licence: CC0