HENDRIX BACON UK LIMITED

  • Vue d'ensemble
  • Résumé
  • Objet social
  • Adresse
  • Dénominations sociales précédentes
  • Comptes
  • Bilan annuel
  • Dépôts
  • Dirigeants
  • Charges
  • Insolvabilité
  • Source de données
  • Vue d'ensemble

    Nom de la sociétéHENDRIX BACON UK LIMITED
    Statut de la sociétéDissoute
    Forme juridiqueSociété à responsabilité limitée
    Numéro de société 00091083
    JuridictionAngleterre/Pays de Galles
    Date de création
    Date de cessation d'activité

    Résumé

    A des PSCs super sécurisésNon
    A des chargesOui
    A un historique d'insolvabilitéOui
    Le siège social est contestéNon

    Quel est l'objet de HENDRIX BACON UK LIMITED ?

    • (5139) /

    Où se situe HENDRIX BACON UK LIMITED ?

    Adresse du siège social
    Bank Chambers 1
    Central Avenue
    ME10 4AE Sittingbourne
    Kent
    Adresse du siège social non livrableNon

    Quels étaient les noms précédents de HENDRIX BACON UK LIMITED ?

    Dénominations sociales précédentes
    Nom de la sociétéDeJusqu'au
    BP CLYDE TANKER COMPANY LIMITED 04 déc. 190604 déc. 1906

    Quels sont les derniers comptes de HENDRIX BACON UK LIMITED ?

    Derniers comptes
    Derniers comptes arrêtés au31 déc. 2008

    Quel est le statut du dernier bilan annuel pour HENDRIX BACON UK LIMITED ?

    Bilan annuel
    Dernier bilan annuel

    Quels sont les derniers dépôts pour HENDRIX BACON UK LIMITED ?

    Dépôts
    DateDescriptionDocumentType

    Gazette finale dissoute à la suite d'une liquidation

    1 pagesGAZ2

    Retour de la réunion finale dans une liquidation volontaire des membres

    11 pages4.71

    Déclaration des reçus et paiements des liquidateurs jusqu'à 06 oct. 2013

    13 pages4.68

    Cessation de la nomination de Mawlaw Secretaries Limited en tant que secrétaire le 30 sept. 2013

    2 pagesTM02

    Déclaration des reçus et paiements des liquidateurs jusqu'à 06 oct. 2012

    14 pages4.68

    Les registres ont été transférés au lieu d'inspection enregistré

    1 pagesAD03

    L'adresse d'inspection du registre a été modifiée de Pellipar House 1st Floor 9 Cloak Lane London EC4R 2RU United Kingdom

    1 pagesAD02

    Changement d'adresse du siège social de Syndale Court, Stadium Way Eurolink Business Park Sittingbourne Kent ME10 3SP le 17 janv. 2012

    2 pagesAD01

    Déclaration de solvabilité

    4 pages4.70

    Nomination d'un liquidateur volontaire

    2 pages600

    Résolutions

    Resolutions
    1 pagesRESOLUTIONS
    Résolutions
    CatégorieDateDescriptionType
    liquidation

    Résolution spéciale pour la liquidation

    LRESSP

    Premier avis au Bulletin officiel pour la radiation d'office

    1 pagesGAZ1

    L'adresse d'inspection du registre a été modifiée de 201 Bishopsgate London EC2M 3AF

    1 pagesAD02

    Premier avis au Bulletin officiel pour la radiation d'office

    1 pagesGAZ1

    Déclaration annuelle jusqu'au 01 juil. 2010 avec liste complète des actionnaires

    5 pagesAR01
    Dépôts associés
    CatégorieDateDescriptionType
    capital01 juil. 2010

    État du capital au 01 juil. 2010

    • Capital: GBP 400,000
    SH01

    accounts-with-accounts-type-

    6 pagesAA

    Cessation de la nomination d'un directeur

    1 pagesTM01

    Modification des coordonnées de l'administrateur Antonius Matheus Maria Lammers le 01 oct. 2009

    3 pagesCH01

    Nomination de Mr Louis Antoine Maria Vernaus en tant qu'administrateur

    2 pagesAP01

    L'adresse d'inspection du registre a été modifiée

    2 pagesAD02

    legacy

    3 pages363a

    legacy

    1 pages353

    legacy

    1 pages288c

    legacy

    1 pages288c

    legacy

    1 pages288c

    Qui sont les dirigeants de HENDRIX BACON UK LIMITED ?

    Dirigeants
    NomNommé leDate de démissionRôleAdresseIdentification de la sociétéPays de résidenceNationalitéDate de naissanceProfessionNuméro
    CHRISTIAANSE, Anthony Martin
    3065 Sc Rotterdam
    's-Gravenweg 551
    The Netherlands
    Administrateur
    3065 Sc Rotterdam
    's-Gravenweg 551
    The Netherlands
    Dutch129239540002
    VERNAUS, Louis Antoine Maria
    Bain Square
    Kirkton Campus
    EH54 7DQ Livingston
    7
    United Kingdom
    Administrateur
    Bain Square
    Kirkton Campus
    EH54 7DQ Livingston
    7
    United Kingdom
    NetherlandsDutch146206430001
    DAVISON, Stuart
    12 Speedwell Road
    CT5 3RD Whitstable
    Kent
    Secrétaire
    12 Speedwell Road
    CT5 3RD Whitstable
    Kent
    British123365010001
    EDMONDS, Alan Eric
    Westways 19 Washington Lane
    Euxton
    PR7 6DE Chorley
    Lancashire
    Secrétaire
    Westways 19 Washington Lane
    Euxton
    PR7 6DE Chorley
    Lancashire
    British1202430002
    STRINGER, Michael Gerald William
    The White House Clovelly Road
    CT5 4NR Whitstable
    Kent
    Secrétaire
    The White House Clovelly Road
    CT5 4NR Whitstable
    Kent
    British2093720001
    SUBNEL, Bob
    Bergkwartier 37
    Venray
    5801 Pt
    Netherlands
    Secrétaire
    Bergkwartier 37
    Venray
    5801 Pt
    Netherlands
    Dutch105535470001
    MAWLAW SECRETARIES LIMITED
    Bishopsgate
    EC2M 3AF London
    201
    Secrétaire
    Bishopsgate
    EC2M 3AF London
    201
    39182980003
    ABBITT, Leon Barry
    4 Hartswood Road
    CM14 5AA Brentwood
    Essex
    Administrateur
    4 Hartswood Road
    CM14 5AA Brentwood
    Essex
    EnglandBritish153119640001
    BAKKER, Hendrix
    Vlagberg 12
    Sint Anthonis
    5845ec
    The Netherlands
    Administrateur
    Vlagberg 12
    Sint Anthonis
    5845ec
    The Netherlands
    Dutch42560370001
    BARGEMAN, Gerrit Theodoor
    7 Seagrave Close
    CW9 8UR Northwich
    Cheshire
    Administrateur
    7 Seagrave Close
    CW9 8UR Northwich
    Cheshire
    Dutch92548260001
    BUZZACOTT, Michael Charles
    6 Dalkeith Road
    AL5 5PW Harpenden
    Hertfordshire
    Administrateur
    6 Dalkeith Road
    AL5 5PW Harpenden
    Hertfordshire
    English32087340001
    COLENSO, John
    551 Crewe Road
    Wistaston
    CW2 6PU Crewe
    Cheshire
    Administrateur
    551 Crewe Road
    Wistaston
    CW2 6PU Crewe
    Cheshire
    EnglandBritish77538060001
    HELDENS, Pierre Gerard Joseph Marie
    Stadryk 135
    5403 NH Uden
    The Netherlands
    Administrateur
    Stadryk 135
    5403 NH Uden
    The Netherlands
    Dutch42560650001
    LAMMERS, Antonius Matheus Maria
    7005-7023
    5692 Hb Son En Breugel
    Ekkersrijt
    The Netherlands
    Administrateur
    7005-7023
    5692 Hb Son En Breugel
    Ekkersrijt
    The Netherlands
    Dutch126350570004
    LESTER, Stephen Kingsley
    Roslin Villa
    Ashfield Crescent Ross On Wye
    HR9 5PH Hereford
    Administrateur
    Roslin Villa
    Ashfield Crescent Ross On Wye
    HR9 5PH Hereford
    EnglandBritish96661160001
    PHILLIPS, Perry
    Brookside Bedwells Heath
    Boars Hill
    OX1 5DE Oxford
    Oxfordshire
    Administrateur
    Brookside Bedwells Heath
    Boars Hill
    OX1 5DE Oxford
    Oxfordshire
    British25027510001
    ROELOFS, Johannes Henricus Wilhelmus
    Geslotten Stad 23
    Amersfoort
    3823 Dp
    The Netherlands
    Administrateur
    Geslotten Stad 23
    Amersfoort
    3823 Dp
    The Netherlands
    Dutch74600510001
    SNEPVANGERS, Ronald Sudoviais Johannes Corinelis
    B Manderslaan 56a
    Zundent
    4861 Ek
    Netherlands
    Administrateur
    B Manderslaan 56a
    Zundent
    4861 Ek
    Netherlands
    Dutch121536140001
    STRINGER, Michael Gerald William
    The White House Clovelly Road
    CT5 4NR Whitstable
    Kent
    Administrateur
    The White House Clovelly Road
    CT5 4NR Whitstable
    Kent
    EnglandBritish2093720001
    SUBNEL, Andre Peter Dos
    Bergkwartter 37
    Venray
    5801 Pt
    The Netherlands
    Administrateur
    Bergkwartter 37
    Venray
    5801 Pt
    The Netherlands
    Dutch104745250001
    THURSTON, William
    9a Chapel Road
    PE28 3PU Earith
    Cambridgeshire
    Administrateur
    9a Chapel Road
    PE28 3PU Earith
    Cambridgeshire
    United KingdomBritish71902510002
    VAN DER VEN, Johannes Bastiaan
    Ryenberghof 18
    Dieren
    6952 Hr
    The Netherlands
    Administrateur
    Ryenberghof 18
    Dieren
    6952 Hr
    The Netherlands
    Dutch74155000001
    VAN WEL, Martinus Franciscus Lambertus Marina
    Langenakker 232
    5731KA Mierlo
    Netherlands
    Administrateur
    Langenakker 232
    5731KA Mierlo
    Netherlands
    Dutch44739910001
    VAN WEL, Martinus Franciscus Lambertus Marina
    Langenakker 232
    5731KA Mierlo
    Netherlands
    Administrateur
    Langenakker 232
    5731KA Mierlo
    Netherlands
    Dutch44739910001
    VION FRESH MEAT WEST BV
    Boseind
    10
    5281 Rm Boxtel
    Holland
    Administrateur
    Boseind
    10
    5281 Rm Boxtel
    Holland
    74110400008

    HENDRIX BACON UK LIMITED a-t-elle des charges ?

    Charges
    ClassificationDatesStatutDétails
    Debenture
    Créé le 17 janv. 1996
    Livré le 31 janv. 1996
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from each obligor (as defined) to the lenders under each of the finance documents (as defined)
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Cooperatieve Centrale Raiffeisen-Boerenleenbank B.A. as Agent and Trustee for Itself and Eachof the Lenders (As Defined)
    Transactions
    • 31 janv. 1996Enregistrement d'une charge (395)
    • 10 juin 1999Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Debenture
    Créé le 30 sept. 1994
    Livré le 17 oct. 1994
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company and/or all or any other companies named therein to the chargee under the terms of the senior finance documents and the mezzanine finance documents (the "secured liabilities")
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Union Bank of Switzerlandthe "Security Agent"
    Transactions
    • 17 oct. 1994Enregistrement d'une charge (395)
    • 31 janv. 1996Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)

    HENDRIX BACON UK LIMITED a-t-elle des procédures d'insolvabilité ?

    Numéro de dossierDatesTypePraticiensAutre
    1
    DateType
    25 févr. 2015Dissolved on
    07 oct. 2011Commencement of winding up
    Members voluntary liquidation
    NomRôleAdresseNommé leCessé le
    David Jenner Cork
    Bank Chambers
    1 Central Avenue
    ME10 4AE Sittingbourne
    Kent
    practitioner
    Bank Chambers
    1 Central Avenue
    ME10 4AE Sittingbourne
    Kent

    Source de données

    • Companies House du Royaume-Uni
      Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers.
    • Licence: CC0