GAUCHO GRILL LIMITED

  • Vue d'ensemble
  • Résumé
  • Objet social
  • Adresse
  • Dénominations sociales précédentes
  • Comptes
  • Dépôts
  • Dirigeants
  • Personnes ayant un contrôle significatif
  • Charges
  • Insolvabilité
  • Source de données
  • Vue d'ensemble

    Nom de la sociétéGAUCHO GRILL LIMITED
    Statut de la sociétéDissoute
    Forme juridiqueSociété à responsabilité limitée
    Numéro de société 00093289
    JuridictionAngleterre/Pays de Galles
    Date de création
    Date de cessation d'activité

    Résumé

    A des PSCs super sécurisésNon
    A des chargesOui
    A un historique d'insolvabilitéOui
    Le siège social est contestéNon

    Quel est l'objet de GAUCHO GRILL LIMITED ?

    • Restaurants avec licence (56101) / Hébergement et restauration

    Où se situe GAUCHO GRILL LIMITED ?

    Adresse du siège social
    Four Brindley Place
    Brindley Place
    B1 2HZ Birmingham
    Adresse du siège social non livrableNon

    Quels étaient les noms précédents de GAUCHO GRILL LIMITED ?

    Dénominations sociales précédentes
    Nom de la sociétéDeJusqu'au
    GAUCHO GRILL PLC27 avr. 200127 avr. 2001
    GIOMA RESTAURANTS PLC21 juil. 199821 juil. 1998
    PARAMBE P.L.C.08 mai 190708 mai 1907

    Quels sont les derniers comptes de GAUCHO GRILL LIMITED ?

    Derniers comptes
    Derniers comptes arrêtés au31 déc. 2016

    Quels sont les derniers dépôts pour GAUCHO GRILL LIMITED ?

    Dépôts
    DateDescriptionDocumentType

    Gazette finale dissoute à la suite d'une liquidation

    1 pagesGAZ2

    Avis de transition de l'administration à la dissolution

    18 pagesAM23

    Rapport d'avancement de l'administrateur

    17 pagesAM10

    Avis d'approbation réputée des propositions

    31 pagesAM06

    Déclaration de la proposition de l'administrateur

    31 pagesAM03

    Déclaration des affaires avec le formulaire AM02SOA

    9 pagesAM02

    Changement d'adresse du siège social de Fourth Floor 7-9 Swallow Street London W1B 4DE à Four Brindley Place Brindley Place Birmingham B1 2HZ le 02 août 2018

    2 pagesAD01

    Nomination d'un administrateur

    3 pagesAM01

    Déclaration de confirmation établie le 04 juil. 2018 sans mise à jour

    3 pagesCS01

    Satisfaction de la charge 000932890016 en totalité

    1 pagesMR04

    Statuts

    13 pagesMA

    Résolutions

    Resolutions
    4 pagesRESOLUTIONS
    Résolutions
    CatégorieDateDescriptionType
    capital

    Résolutions

    Documents/facilities agreement/company business 15/06/2018
    RES13
    incorporation

    Résolution de modification des statuts

    RES01

    Inscription de la charge 000932890019, créée le 18 juin 2018

    18 pagesMR01

    Nomination de Mr Oliver James Meakin en tant qu'administrateur le 29 janv. 2018

    2 pagesAP01

    Nomination de Mr Paul Mason en tant qu'administrateur le 09 nov. 2017

    2 pagesAP01

    Cessation de la nomination de Zeev Godik en tant que directeur le 09 nov. 2017

    1 pagesTM01

    Comptes annuels établis au 31 déc. 2016

    14 pagesAA

    Déclaration de confirmation établie le 04 juil. 2017 avec mises à jour

    5 pagesCS01

    Deuxième dépôt pour la cessation de fonctions de Gary Mann en tant qu'administrateur

    5 pagesRP04TM01

    Deuxième dépôt pour la cessation de fonctions de Gary Mann en tant que secrétaire

    5 pagesRP04TM02

    Nomination de Mr Frank Bandura en tant qu'administrateur le 24 févr. 2017

    2 pagesAP01

    Cessation de la nomination de Gary Mann en tant que directeur le 24 févr. 2017

    2 pagesTM01
    Annotations
    DateAnnotation
    03 avr. 2017Clarification A second filed TM01 was registered on 03/04/2017.

    Nomination de Mr Frank Bandura en tant que secrétaire le 24 févr. 2017

    2 pagesAP03

    Cessation de la nomination de Gary Mann en tant que secrétaire le 24 févr. 2017

    2 pagesTM02
    Annotations
    DateAnnotation
    03 avr. 2017Clarification A second filed TM02 was registered on 03/04/2017.

    Comptes annuels établis au 31 déc. 2015

    14 pagesAA

    Qui sont les dirigeants de GAUCHO GRILL LIMITED ?

    Dirigeants
    NomNommé leDate de démissionRôleAdresseIdentification de la sociétéPays de résidenceNationalitéDate de naissanceProfessionNuméro
    BANDURA, Frank
    Brindley Place
    B1 2HZ Birmingham
    Four Brindley Place
    Secrétaire
    Brindley Place
    B1 2HZ Birmingham
    Four Brindley Place
    226381610001
    BANDURA, Frank
    Brindley Place
    B1 2HZ Birmingham
    Four Brindley Place
    Administrateur
    Brindley Place
    B1 2HZ Birmingham
    Four Brindley Place
    EnglandBritish70536440002
    MASON, Paul
    Brindley Place
    B1 2HZ Birmingham
    Four Brindley Place
    Administrateur
    Brindley Place
    B1 2HZ Birmingham
    Four Brindley Place
    United KingdomBritish141310720001
    MEAKIN, Oliver James
    Brindley Place
    B1 2HZ Birmingham
    Four Brindley Place
    Administrateur
    Brindley Place
    B1 2HZ Birmingham
    Four Brindley Place
    EnglandBritish126343920001
    COULTHARD, Simon David
    25 Downs Road
    EN1 1PB Enfield
    Secrétaire
    25 Downs Road
    EN1 1PB Enfield
    British97883290001
    JOHAL, Manjinder
    7 Danes Court
    1 Saint Edmunds Terrace
    NW8 7QR London
    Secrétaire
    7 Danes Court
    1 Saint Edmunds Terrace
    NW8 7QR London
    British80892350001
    MANN, Gary
    Swallow Street
    W1B 4DE London
    Fourth Floor 7-9
    Secrétaire
    Swallow Street
    W1B 4DE London
    Fourth Floor 7-9
    182802060001
    MCLEAN, Charles Robert William
    2 Lilyfields Chase
    Ewhurst
    GU6 7RX Cranleigh
    Secrétaire
    2 Lilyfields Chase
    Ewhurst
    GU6 7RX Cranleigh
    British102833990002
    VAN TONGEREN, Steven
    64 Buckingham Gate
    Flat 4
    SW1E 6AR London
    Secrétaire
    64 Buckingham Gate
    Flat 4
    SW1E 6AR London
    Dutch60695810002
    CANTRADE INVESTMENTS LIMITED
    4 Chiswell Street
    Finsbury Square
    EC1Y 4UP London
    Secrétaire
    4 Chiswell Street
    Finsbury Square
    EC1Y 4UP London
    4852550003
    COULTHARD, Simon David
    25 Downs Road
    EN1 1PB Enfield
    Administrateur
    25 Downs Road
    EN1 1PB Enfield
    British97883290001
    DAVENPORT, David Talbot Henry
    Rectory Park
    TN12 8EH Horsmonden
    Kent
    Administrateur
    Rectory Park
    TN12 8EH Horsmonden
    Kent
    British8945080001
    DAY, Richard Anthony Bingley
    Church Farmhouse Church Road
    Stambourne
    CO9 4NR Halstead
    Essex
    Administrateur
    Church Farmhouse Church Road
    Stambourne
    CO9 4NR Halstead
    Essex
    EnglandBritish14473230003
    GEENEMANS, Siewert Jan
    Wite Singel 33
    Leiden
    Nl 2311
    The Netherlands
    Administrateur
    Wite Singel 33
    Leiden
    Nl 2311
    The Netherlands
    Dutch71831900002
    GODIK, Zeev
    Swallow Street
    W1B 4DE London
    Fourth Floor 7-9
    Administrateur
    Swallow Street
    W1B 4DE London
    Fourth Floor 7-9
    EnglandDutch78064190005
    HORLICK, Nicola Karina Christina
    30 Thurloe Square
    SW7 2SD London
    Administrateur
    30 Thurloe Square
    SW7 2SD London
    British53458480002
    JOHAL, Manjinder
    7 Danes Court
    1 Saint Edmunds Terrace
    NW8 7QR London
    Administrateur
    7 Danes Court
    1 Saint Edmunds Terrace
    NW8 7QR London
    British80892350001
    LEWIS, Leonard Richard
    Ridge End House Marlow Common
    SL7 2QS Marlow
    Buckinghamshire
    Administrateur
    Ridge End House Marlow Common
    SL7 2QS Marlow
    Buckinghamshire
    British35093260001
    MANN, Gary
    Swallow Street
    W1B 4DE London
    Fourth Floor 7-9
    Administrateur
    Swallow Street
    W1B 4DE London
    Fourth Floor 7-9
    EnglandBritish182641140001
    MCLEAN, Charles Robert William
    2 Lilyfields Chase
    Ewhurst
    GU6 7RX Cranleigh
    Administrateur
    2 Lilyfields Chase
    Ewhurst
    GU6 7RX Cranleigh
    EnglandBritish102833990002
    RITCHIE, David Cowan
    48 Dick Place
    EH9 2JB Edinburgh
    Midlothian
    Administrateur
    48 Dick Place
    EH9 2JB Edinburgh
    Midlothian
    ScotlandBritish26865440001
    ROWLATT, James Arthur
    Cut Mill Cottage
    Hinton St Mary
    DT10 1NA Sturminster Newton
    Dorset
    Administrateur
    Cut Mill Cottage
    Hinton St Mary
    DT10 1NA Sturminster Newton
    Dorset
    British36257720001
    STOREY, Donald
    105 Cambridge Gardens
    W10 6JE London
    Administrateur
    105 Cambridge Gardens
    W10 6JE London
    British111399690001
    VAN TONGEREN, Steven
    64 Buckingham Gate
    Flat 4
    SW1E 6AR London
    Administrateur
    64 Buckingham Gate
    Flat 4
    SW1E 6AR London
    Dutch60695810002

    Qui sont les personnes ayant un contrôle significatif sur GAUCHO GRILL LIMITED ?

    Personnes ayant un contrôle significatif
    NomNotifié leAdresseCessé
    Malbec Bidco Limited
    Swallow Street
    W1B 4DE London
    Fourth Floor, 7-9
    England
    06 avr. 2016
    Swallow Street
    W1B 4DE London
    Fourth Floor, 7-9
    England
    Non
    Forme juridiquePrivate Company Limited By Shares
    Pays d'enregistrementEngland
    Autorité légaleEngland And Wales
    Lieu d'enregistrementRegistrar Of Companies For England And Wales
    Numéro d'enregistrement06451551
    Nature du contrôle
    • La personne détient, directement ou indirectement, plus de 75 % des actions de la société.

    GAUCHO GRILL LIMITED a-t-elle des charges ?

    Charges
    ClassificationDatesStatutDétails
    A registered charge
    Créé le 18 juin 2018
    Livré le 21 juin 2018
    En cours
    Brève description
    All current and future material land (except for any floating charge leasehold property) and intellectual property (except for any floating charge intellectual property) and the specified intellectual property owned by the company, in each case as specified (and defined) in the deed of accession and charge registered by this form MR01 and including, amongst others, trademarks numbered 2574715 and 2527499. for more details please refer to the deed of accession and charge.
    La charge flottante couvre tout: Oui
    Contient une promesse négative: Oui
    Contient une charge flottante: Oui
    Contient une charge fixe: Oui
    Personnes ayant droit
    • Lloyds Bank PLC as Security Agent and Trustee for the Beneficiaries
    Transactions
    • 21 juin 2018Enregistrement d'une charge (MR01)
    A registered charge
    Créé le 13 avr. 2016
    Livré le 22 avr. 2016
    En cours
    Brève description
    N/A.
    Contient une charge fixe: Oui
    Personnes ayant droit
    • Lloyds Bank PLC (As Security Agent)
    Transactions
    • 22 avr. 2016Enregistrement d'une charge (MR01)
    A registered charge
    Créé le 17 févr. 2016
    Livré le 23 févr. 2016
    En cours
    Contient une promesse négative: Oui
    Contient une charge fixe: Oui
    Personnes ayant droit
    • Lloyds Bank PLC (As Security Agent)
    Transactions
    • 23 févr. 2016Enregistrement d'une charge (MR01)
    A registered charge
    Créé le 16 mai 2014
    Livré le 28 mai 2014
    Totalement satisfaite
    Brève description
    Cau.reg no.2527499 Reg on 1 october 2009 class 43:. gaucho.reg no.2427464 Reg on 18 july 2006 class 43:. gaucho.reg no.2550529 Reg on 14 july 2006 class 43:. gaucho.reg no.2574715 Reg on 10 march 2011 class 41:.
    La charge flottante couvre tout: Oui
    Contient une promesse négative: Oui
    Contient une charge flottante: Oui
    Contient une charge fixe: Oui
    Personnes ayant droit
    • Lloyds Bank PLC as Security Trustee
    Transactions
    • 28 mai 2014Enregistrement d'une charge (MR01)
    • 09 juil. 2018Satisfaction d'une charge (MR04)
    Supplemental agreement
    Créé le 25 août 2010
    Livré le 02 sept. 2010
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from any obligor under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    A security interest in the totality of shares it holds in gaucho lebanon sarl, together with any and all rights see image for full details.
    Personnes ayant droit
    • Lloyds Tsb Bank PLC (The Security Trustee)
    Transactions
    • 02 sept. 2010Enregistrement d'une charge (MG01)
    • 12 janv. 2016Satisfaction d'une charge (MR04)
    A pledge of shares agreement
    Créé le 18 août 2010
    Livré le 26 août 2010
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from any obligor to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    As security for the prompt and complete payment of the secured liabilities pledged and granted a security interest in the totality of shares it holds in gaucho lebanon sarl together with any and all rights attached see image for full details.
    Personnes ayant droit
    • Lloyds Tsb Bank PLC (The "Security Trustee")
    Transactions
    • 26 août 2010Enregistrement d'une charge (MG01)
    • 12 janv. 2016Satisfaction d'une charge (MR04)
    Agreement and deed of pledge of shares
    Créé le 20 déc. 2007
    Livré le 29 déc. 2007
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the pledgor or the company or both as obligors to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    The present shares. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Lloyds Tsb Bank PLC
    Transactions
    • 29 déc. 2007Enregistrement d'une charge (395)
    • 18 mars 2016Satisfaction d'une charge (MR04)
    Debenture
    Créé le 17 déc. 2007
    Livré le 19 déc. 2007
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the obligors to the finance parties under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Lloyds Tsb Bank PLC
    Transactions
    • 19 déc. 2007Enregistrement d'une charge (395)
    • 18 mars 2016Satisfaction d'une charge (MR04)
    A security agreement for the pledge of shares
    Créé le 03 août 2006
    Livré le 18 août 2006
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due of each obligor to any finance party on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    All its shares and share rights. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Anglo Irish Bank Corporation as Agent of and Security Trustee for the Finance Parties
    Transactions
    • 18 août 2006Enregistrement d'une charge (395)
    • 20 déc. 2007Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    A supplemental deed to a debenture dated 2 august 2006
    Créé le 02 août 2006
    Livré le 15 août 2006
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from or by any obligor to the finance parties (or any of them) or to the chargee on any account whatsoever and all other monies due or to become due from any charging company under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Anglo Irish Bank Corporation PLC as Agent of and Trustee for the Other Finance Parties (Thetrustee)
    Transactions
    • 15 août 2006Enregistrement d'une charge (395)
    • 20 déc. 2007Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Pledge of intellectual property rights
    Créé le 17 janv. 2005
    Livré le 03 févr. 2005
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    A first ranking right of pledge over all ip rights and to the extent it concerns future ip rights. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transactions
    • 03 févr. 2005Enregistrement d'une charge (395)
    • 04 août 2006Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Pledge of shares
    Créé le 17 janv. 2005
    Livré le 03 févr. 2005
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    The pledgor has granted to the pledgee a first ranking right of pledge over the shares and dividends. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transactions
    • 03 févr. 2005Enregistrement d'une charge (395)
    • 04 août 2006Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Debenture
    Créé le 17 janv. 2005
    Livré le 29 janv. 2005
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • The Royal Bank of Scotland PLC (Security Agent)
    Transactions
    • 29 janv. 2005Enregistrement d'une charge (395)
    • 04 août 2006Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Debenture
    Créé le 20 août 2002
    Livré le 23 août 2002
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Lloyds Tsb Bank PLC
    Transactions
    • 23 août 2002Enregistrement d'une charge (395)
    • 02 août 2006Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Letter of charge
    Créé le 02 déc. 1985
    Livré le 09 déc. 1985
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All moneys due or to become due from parambe collection limited and ceycon securirties limited to the chargee. On any account whatsoever.
    Brèves mentions
    All monies now or at any time hereafter standing to the credit of any account or accounts of the company in the bank's books.
    Personnes ayant droit
    • The Governor & the Company of the Bank of Scotland
    Transactions
    • 09 déc. 1985Enregistrement d'une charge
    • 27 avr. 2002Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Charge
    Créé le 05 avr. 1913
    Livré le 05 avr. 1913
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    £400
    Brèves mentions
    Undertaking, property and assets, present and future including uncalled capital.
    Personnes ayant droit
    • Mrs E. Blair
    Transactions
    • 05 avr. 1913Enregistrement d'une charge
    • 27 avr. 2002Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Series of debentures
    Créé le 06 août 1909
    Livré le 06 août 1909
    Totalement satisfaite
    Brèves mentions
    The company's undertaking, stock in trade, goodwill, book debts and all other property present and future including uncalled capital.
    Personnes ayant droit
    • No Trustees
    Transactions
    • 06 août 1909Enregistrement d'une charge pour garantir une série de débentures (397)
    • 27 avr. 2002Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Series of debentures
    Créé le 09 nov. 1908
    Livré le 09 nov. 1908
    Totalement satisfaite
    Brèves mentions
    The company's undertaking, stock in trade, goodwill, book debts and all other property present and future including uncalled capital.
    Personnes ayant droit
    • No Trustees
    Transactions
    • 09 nov. 1908Enregistrement d'une charge pour garantir une série de débentures (397)
    • 27 avr. 2002Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Series of debentures
    Créé le 08 sept. 1908
    Livré le 08 sept. 1908
    Totalement satisfaite
    Brèves mentions
    The company's undertaking, stock in trade, goodwill, book debts and all other property present and future including uncalled capital.
    Personnes ayant droit
    • No Trustees
    Transactions
    • 08 sept. 1908Enregistrement d'une charge pour garantir une série de débentures (397)
    • 27 avr. 2002Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)

    GAUCHO GRILL LIMITED a-t-elle des procédures d'insolvabilité ?

    Numéro de dossierDatesTypePraticiensAutre
    1
    DateType
    19 juil. 2018Administration started
    31 juil. 2019Administration ended
    In administration
    NomRôleAdresseNommé leCessé le
    Robert James Harding
    1 New Street Square
    EC4A 3HQ London
    practitioner
    1 New Street Square
    EC4A 3HQ London
    Matthew David Smith
    1 New Street Square
    EC4A 3HQ London
    practitioner
    1 New Street Square
    EC4A 3HQ London

    Source de données

    • Companies House du Royaume-Uni
      Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers.
    • Licence: CC0