PUNCH TAVERNS (WILLOW) LIMITED

PUNCH TAVERNS (WILLOW) LIMITED

  • Vue d'ensemble
  • Résumé
  • Objet social
  • Adresse
  • Dénominations sociales précédentes
  • Comptes
  • Dépôts
  • Dirigeants
  • Personnes ayant un contrôle significatif
  • Charges
  • Source de données
  • Vue d'ensemble

    Nom de la sociétéPUNCH TAVERNS (WILLOW) LIMITED
    Statut de la sociétéDissoute
    Forme juridiqueSociété à responsabilité limitée
    Numéro de société 00095855
    JuridictionAngleterre/Pays de Galles
    Date de création
    Date de cessation d'activité

    Résumé

    A des PSCs super sécurisésNon
    A des chargesOui
    A un historique d'insolvabilitéNon
    Le siège social est contestéNon

    Quel est l'objet de PUNCH TAVERNS (WILLOW) LIMITED ?

    • Société non marchande non marchande (74990) / Activités spécialisées, scientifiques et techniques

    Où se situe PUNCH TAVERNS (WILLOW) LIMITED ?

    Adresse du siège social
    Elsley Court
    20-22 Great Titchfield Street
    W1W 8BE London
    United Kingdom
    Adresse du siège social non livrableNon

    Quels étaient les noms précédents de PUNCH TAVERNS (WILLOW) LIMITED ?

    Dénominations sociales précédentes
    Nom de la sociétéDeJusqu'au
    PUNCH RETAILING (WILLOW) LIMITED23 sept. 199923 sept. 1999
    ALLIED DOMECQ RETAILING (WILLOW) LIMITED12 nov. 199612 nov. 1996
    WREXHAM LAGER BREWERY COMPANY LIMITED07 mars 198807 mars 1988
    WREXHAM LAGER BEER COMPANY LIMITED31 déc. 197831 déc. 1978
    INNES SMITH,AND COMPANY LIMITED 28 nov. 190728 nov. 1907

    Quels sont les derniers comptes de PUNCH TAVERNS (WILLOW) LIMITED ?

    Derniers comptes
    Derniers comptes arrêtés au31 déc. 2018

    Quels sont les derniers dépôts pour PUNCH TAVERNS (WILLOW) LIMITED ?

    Dépôts
    DateDescriptionDocumentType

    Bulletin officiel final dissous par radiation volontaire

    1 pagesGAZ2(A)

    Cessation de la nomination de David Forde en tant que directeur le 31 juil. 2020

    1 pagesTM01

    Déclaration de confirmation établie le 11 juil. 2020 avec mises à jour

    4 pagesCS01

    Premier avis au Bulletin officiel pour la radiation volontaire

    1 pagesGAZ1(A)

    Demande de radiation de la société du registre du commerce

    3 pagesDS01

    legacy

    1 pagesSH20

    État du capital au 17 janv. 2020

    • Capital: GBP 1
    3 pagesSH19

    legacy

    1 pagesCAP-SS

    Résolutions

    Resolutions
    1 pagesRESOLUTIONS
    Résolutions
    CatégorieDateDescriptionType
    capital

    Résolution de réduction du capital social émis

    RES06

    legacy

    3 pagesAGREEMENT1

    legacy

    3 pagesGUARANTEE1

    legacy

    79 pagesPARENT_ACC

    Déclaration de confirmation établie le 11 juil. 2019 sans mise à jour

    3 pagesCS01

    Nomination de Mr Sean Michael Paterson en tant qu'administrateur le 24 avr. 2019

    2 pagesAP01

    Cessation de la nomination de David James Tannahill en tant que directeur le 24 avr. 2019

    1 pagesTM01

    Période comptable actuelle prolongée du 24 août 2018 au 31 déc. 2018

    1 pagesAA01

    Déclaration de confirmation établie le 12 juil. 2018 sans mise à jour

    3 pagesCS01

    Comptes pour une société dormante établis au 19 août 2017

    3 pagesAA

    Modification des détails de Punch Taverns (Dc) Holdings Limited en tant que personne disposant d'un contrôle significatif le 04 sept. 2017

    2 pagesPSC05

    Changement d'adresse du siège social de Jubilee House Second Avenue Burton upon Trent Staffordshire DE14 2WF à Elsley Court 20-22 Great Titchfield Street London W1W 8BE le 08 sept. 2017

    1 pagesAD01

    Cessation de la nomination de Stephen Peter Dando en tant que directeur le 29 août 2017

    1 pagesTM01

    Nomination de Mr David Forde en tant qu'administrateur le 29 août 2017

    2 pagesAP01

    Cessation de la nomination de Francesca Appleby en tant que secrétaire le 29 août 2017

    1 pagesTM02

    Cessation de la nomination de Edward Michael Bashforth en tant que directeur le 29 août 2017

    1 pagesTM01

    Nomination de Mr Christopher John Moore en tant qu'administrateur le 29 août 2017

    2 pagesAP01

    Qui sont les dirigeants de PUNCH TAVERNS (WILLOW) LIMITED ?

    Dirigeants
    NomNommé leDate de démissionRôleAdresseIdentification de la sociétéPays de résidenceNationalitéDate de naissanceProfessionNuméro
    MOORE, Christopher John
    3-4 Broadway Park
    EH12 9JZ Edinburgh
    Heineken Uk Limited
    United Kingdom
    Administrateur
    3-4 Broadway Park
    EH12 9JZ Edinburgh
    Heineken Uk Limited
    United Kingdom
    United KingdomBritishDirector136853310001
    MOUNTSTEVENS, Lawson John Wembridge
    3-4 Broadway Park
    EH12 9JZ Edinburgh
    Heineken Uk Limited
    United Kingdom
    Administrateur
    3-4 Broadway Park
    EH12 9JZ Edinburgh
    Heineken Uk Limited
    United Kingdom
    EnglandBritishDirector112375050001
    PATERSON, Sean Michael
    South Gyle Broadway
    EH12 9JZ Edinburgh
    3-4 Broadway Park
    Scotland
    Administrateur
    South Gyle Broadway
    EH12 9JZ Edinburgh
    3-4 Broadway Park
    Scotland
    ScotlandBritishFinance Director257892140001
    APPLEBY, Francesca
    Second Avenue
    DE14 2WF Burton Upon Trent
    Jubilee House
    Staffordshire
    United Kingdom
    Secrétaire
    Second Avenue
    DE14 2WF Burton Upon Trent
    Jubilee House
    Staffordshire
    United Kingdom
    191629580001
    BELL, Richard Edgar, Llb Solicitor
    13 Harbury Street
    DE13 0RX Burton On Trent
    Staffordshire
    Secrétaire
    13 Harbury Street
    DE13 0RX Burton On Trent
    Staffordshire
    British637110001
    GUTHRIE, Harold Alexander
    61 The Lea
    ST4 8DY Stoke On Trent
    Staffordshire
    Secrétaire
    61 The Lea
    ST4 8DY Stoke On Trent
    Staffordshire
    British28998620001
    HARRIS, Claire Louise
    Second Avenue
    DE14 2WF Burton Upon Trent
    Jubilee House
    Staffordshire
    United Kingdom
    Secrétaire
    Second Avenue
    DE14 2WF Burton Upon Trent
    Jubilee House
    Staffordshire
    United Kingdom
    175490300001
    RUDD, Susan Clare
    17 Thacker Drive
    WS13 6NS Lichfield
    Staffordshire
    Secrétaire
    17 Thacker Drive
    WS13 6NS Lichfield
    Staffordshire
    British81789210004
    STEWART, Claire Susan
    Ninth Avenue
    DE14 3JZ Burton Upon Trent
    Sunrise House
    Staffordshire
    United Kingdom
    Secrétaire
    Ninth Avenue
    DE14 3JZ Burton Upon Trent
    Sunrise House
    Staffordshire
    United Kingdom
    British117216940001
    TYRRELL, Helen
    Second Avenue
    DE14 2WF Burton Upon Trent
    Jubilee House
    Staffordshire
    United Kingdom
    Secrétaire
    Second Avenue
    DE14 2WF Burton Upon Trent
    Jubilee House
    Staffordshire
    United Kingdom
    161809240001
    BASHFORTH, Edward Michael
    Second Avenue
    DE14 2WF Burton Upon Trent
    Jubilee House
    Staffordshire
    United Kingdom
    Administrateur
    Second Avenue
    DE14 2WF Burton Upon Trent
    Jubilee House
    Staffordshire
    United Kingdom
    United KingdomBritishDirector131551840002
    BELL, Richard Edgar, Llb Solicitor
    13 Harbury Street
    DE13 0RX Burton On Trent
    Staffordshire
    Administrateur
    13 Harbury Street
    DE13 0RX Burton On Trent
    Staffordshire
    BritishSecretary637110001
    CARTLIDGE, Henry
    4 Woodhouse Lane
    Woodhouse Meadow Priorslee
    TF2 9SX Telford
    Shropshire
    Administrateur
    4 Woodhouse Lane
    Woodhouse Meadow Priorslee
    TF2 9SX Telford
    Shropshire
    BritishCompany Director33545670001
    CONSTANTINE, Peter Anthony
    83 South Rise
    CF14 0RG Cardiff
    South Glamorgan
    Administrateur
    83 South Rise
    CF14 0RG Cardiff
    South Glamorgan
    WalesBritishChartered Surveyor Estates Dir114160540001
    DANDO, Stephen Peter
    Second Avenue
    DE14 2WF Burton Upon Trent
    Jubilee House
    Staffordshire
    United Kingdom
    Administrateur
    Second Avenue
    DE14 2WF Burton Upon Trent
    Jubilee House
    Staffordshire
    United Kingdom
    United KingdomBritishChartered Accountant152083750001
    DAVIS, Alan
    4 Ashley Court
    Ashby Road
    DE15 0LL Burton On Trent
    Staffordshire
    Administrateur
    4 Ashley Court
    Ashby Road
    DE15 0LL Burton On Trent
    Staffordshire
    BritishCompany Director15364140001
    DUTTON, Philip
    Second Avenue
    DE14 2WF Burton Upon Trent
    Jubilee House
    Staffordshire
    United Kingdom
    Administrateur
    Second Avenue
    DE14 2WF Burton Upon Trent
    Jubilee House
    Staffordshire
    United Kingdom
    United KingdomBritishDirector141395280001
    ELKIN, William Irwin
    Tudor Lodge Heritage Walk
    SY13 1JF Whitchurch
    Salop
    Administrateur
    Tudor Lodge Heritage Walk
    SY13 1JF Whitchurch
    Salop
    BritishProduction & Dist Director28998630003
    FORDE, David
    3-4 Broadway Park
    EH12 9JZ Edinburgh
    Heineken Uk Limited
    United Kingdom
    Administrateur
    3-4 Broadway Park
    EH12 9JZ Edinburgh
    Heineken Uk Limited
    United Kingdom
    United KingdomIrishDirector180590780001
    GUTHRIE, Harold Alexander
    61 The Lea
    ST4 8DY Stoke On Trent
    Staffordshire
    Administrateur
    61 The Lea
    ST4 8DY Stoke On Trent
    Staffordshire
    BritishCompany Director28998620001
    JONES, Bruce Abbott
    1 Hall Drive
    DE13 8TF Hanbury
    Staffordshire
    Administrateur
    1 Hall Drive
    DE13 8TF Hanbury
    Staffordshire
    BritishCompany Director29595900002
    KEMP, Deborah Jane
    6 Station Road
    Hampton In Arden
    B92 0BJ Solihull
    Administrateur
    6 Station Road
    Hampton In Arden
    B92 0BJ Solihull
    United KingdomBritishDirector79388130005
    KERSHAW, Harry
    5 Codham Close
    The Ithens Sontley Road
    LL13 7DZ Wrexham
    Clwyd
    Administrateur
    5 Codham Close
    The Ithens Sontley Road
    LL13 7DZ Wrexham
    Clwyd
    BritishCompany Director22215920001
    MCDONALD, Robert James
    46 Wentworth Drive
    WS14 9HN Lichfield
    Staffordshire
    Administrateur
    46 Wentworth Drive
    WS14 9HN Lichfield
    Staffordshire
    BritishDirector42019620001
    MCLOUGHLIN, Kevin Thomas
    Monkhide
    Tallarn Green
    SY14 7LJ Malpas
    Cheshire
    Administrateur
    Monkhide
    Tallarn Green
    SY14 7LJ Malpas
    Cheshire
    BritishHead Brewer51153090002
    PENDLETON, Harry
    Ashcroft Woodlands Close
    Thorpe
    DE6 2AP Ashbourne
    Derbyshire
    Administrateur
    Ashcroft Woodlands Close
    Thorpe
    DE6 2AP Ashbourne
    Derbyshire
    BritishCompany Director54398070001
    PRESTON, Neil David
    Second Avenue
    DE14 2WF Burton Upon Trent
    Jubilee House
    Staffordshire
    United Kingdom
    Administrateur
    Second Avenue
    DE14 2WF Burton Upon Trent
    Jubilee House
    Staffordshire
    United Kingdom
    United KingdomBritishDirector63043630002
    STEVENSON, David Robert
    3 Tweentown
    Donington Le Heath
    LE67 2GG Coalville
    Leicestershire
    Administrateur
    3 Tweentown
    Donington Le Heath
    LE67 2GG Coalville
    Leicestershire
    BritishAccountant40472950001
    TANNAHILL, David James
    3-4 Broadway Park
    EH12 9JZ Edinburgh
    Heineken Uk Limited
    United Kingdom
    Administrateur
    3-4 Broadway Park
    EH12 9JZ Edinburgh
    Heineken Uk Limited
    United Kingdom
    ScotlandBritishDirector237381690001
    WEBSTER, Ronald Edward
    Oakmere Murieston Road
    Hale
    WA15 9SU Altrincham
    Cheshire
    Administrateur
    Oakmere Murieston Road
    Hale
    WA15 9SU Altrincham
    Cheshire
    BritishPackaging/Distribution Mng54398110001
    WILKINSON, Anthony Eric
    Bupton Grange
    Longford Lane Longford
    DE6 3DT Ashbourne
    Derbyshire
    Administrateur
    Bupton Grange
    Longford Lane Longford
    DE6 3DT Ashbourne
    Derbyshire
    BritishCompany Director4656080002

    Qui sont les personnes ayant un contrôle significatif sur PUNCH TAVERNS (WILLOW) LIMITED ?

    Personnes ayant un contrôle significatif
    NomNotifié leAdresseCessé
    Broadway Park
    South Gyle Broadway
    EH12 9JZ Edinburgh
    3-4
    Scotland
    Scotland
    29 août 2017
    Broadway Park
    South Gyle Broadway
    EH12 9JZ Edinburgh
    3-4
    Scotland
    Scotland
    Non
    Forme juridiqueCorporate
    Pays d'enregistrementScotland
    Autorité légaleUnited Kingdom (Scotland)
    Lieu d'enregistrementCompanies House
    Numéro d'enregistrementSc065527
    Nature du contrôle
    • La personne a le droit d'exercer, ou exerce effectivement, une influence ou un contrôle significatif sur la société.
    Punch Taverns (Dc) Holdings Limited
    20-22 Great Titchfield Street
    W1W 8BE London
    Elsley Court
    United Kingdom
    06 avr. 2016
    20-22 Great Titchfield Street
    W1W 8BE London
    Elsley Court
    United Kingdom
    Non
    Forme juridiquePrivate Limited Company
    Autorité légaleCompanies Act 2006
    Nature du contrôle
    • La personne détient, directement ou indirectement, plus de 75 % des actions de la société.
    • La personne détient, directement ou indirectement, plus de 75 % des droits de vote dans la société.
    • La personne détient, directement ou indirectement, le droit de nommer ou de révoquer une majorité des membres du conseil d'administration de la société.

    PUNCH TAVERNS (WILLOW) LIMITED a-t-elle des charges ?

    Charges
    ClassificationDatesStatutDétails
    Deed of charge
    Créé le 22 avr. 2002
    Livré le 08 mai 2002
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee or any of the other spirit secured parties under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    A charge by way of first legal mortgage all of the company's right title interest and benefit present and future in to and under the freehold or leasehold property comprising the spirit mortgaged properties owned by it and described in part 1 of schedule 2 to the charge and all estates or interests in such property and all buildings trade and other fixtures fixed plant and machinery from time to time on such freehold or leasehold property.. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Deutsche Trustee Company Limited as Trustee for the Spirit Secured Parties
    Transactions
    • 08 mai 2002Enregistrement d'une charge (395)
    • 14 janv. 2004Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Deed of charge
    Créé le 22 avr. 2002
    Livré le 08 mai 2002
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the security trustee or any of the other pr secured parties on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    By way of assignment all of the company's right, title, interest and benefit, present and future in, to and under the master amendment deed.
    Personnes ayant droit
    • Deutsche Trustee Company Limited
    Transactions
    • 08 mai 2002Enregistrement d'une charge (395)
    • 24 janv. 2003Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    • 14 janv. 2004Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Deed of charge
    Créé le 28 juin 2000
    Livré le 15 juil. 2000
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All moneys due or to become due from the company, or any other charging company and/or guarantor to the chargee whether for its own account or as trustee for the pr secured parties or any of the other pr secured parties under or in respect of the issuer/borrower facility agreement, the charge and/or any other transaction documents to which it is a party (all as defined therein)
    Brèves mentions
    All right title and interest and benefit, in, to and under the f/h and l/h properties owned by it and described in part 1 of schedule 2 to the charge, and all estates or interests in such property and all buildings, trade and other fixtures, fiall right title interest and benefit, in, to and under the f/h xed plant and machinery a floating charge over the undertaking of all property and assets. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Bankers Trustee Company Limited (For Itself and on Behalf of the Pr Secured Parties) "the Security Trustee" (as Defined Therein)
    Transactions
    • 15 juil. 2000Enregistrement d'une charge (395)
    • 24 janv. 2003Déclaration que tout ou partie de la propriété d'une charge flottante a été libérée (403b)
    • 14 janv. 2004Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)

    Source de données

    • Companies House du Royaume-Uni
      Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers.
    • Licence: CC0