PUNCH TAVERNS (WILLOW) LIMITED
Vue d'ensemble
Nom de la société | PUNCH TAVERNS (WILLOW) LIMITED |
---|---|
Statut de la société | Dissoute |
Forme juridique | Société à responsabilité limitée |
Numéro de société | 00095855 |
Juridiction | Angleterre/Pays de Galles |
Date de création | |
Date de cessation d'activité |
Résumé
A des PSCs super sécurisés | Non |
---|---|
A des charges | Oui |
A un historique d'insolvabilité | Non |
Le siège social est contesté | Non |
Où se situe PUNCH TAVERNS (WILLOW) LIMITED ?
Adresse du siège social | Elsley Court 20-22 Great Titchfield Street W1W 8BE London United Kingdom |
---|---|
Adresse du siège social non livrable | Non |
Quels sont les derniers comptes de PUNCH TAVERNS (WILLOW) LIMITED ?
Derniers comptes | |
---|---|
Derniers comptes arrêtés au | 31 déc. 2018 |
Quels sont les derniers dépôts pour PUNCH TAVERNS (WILLOW) LIMITED ?
Date | Description | Document | Type | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bulletin officiel final dissous par radiation volontaire | 1 pages | GAZ2(A) | ||||||||||
Cessation de la nomination de David Forde en tant que directeur le 31 juil. 2020 | 1 pages | TM01 | ||||||||||
Déclaration de confirmation établie le 11 juil. 2020 avec mises à jour | 4 pages | CS01 | ||||||||||
Premier avis au Bulletin officiel pour la radiation volontaire | 1 pages | GAZ1(A) | ||||||||||
Demande de radiation de la société du registre du commerce | 3 pages | DS01 | ||||||||||
legacy | 1 pages | SH20 | ||||||||||
État du capital au 17 janv. 2020
| 3 pages | SH19 | ||||||||||
legacy | 1 pages | CAP-SS | ||||||||||
Résolutions Resolutions | 1 pages | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
legacy | 3 pages | AGREEMENT1 | ||||||||||
legacy | 3 pages | GUARANTEE1 | ||||||||||
legacy | 79 pages | PARENT_ACC | ||||||||||
Déclaration de confirmation établie le 11 juil. 2019 sans mise à jour | 3 pages | CS01 | ||||||||||
Nomination de Mr Sean Michael Paterson en tant qu'administrateur le 24 avr. 2019 | 2 pages | AP01 | ||||||||||
Cessation de la nomination de David James Tannahill en tant que directeur le 24 avr. 2019 | 1 pages | TM01 | ||||||||||
Période comptable actuelle prolongée du 24 août 2018 au 31 déc. 2018 | 1 pages | AA01 | ||||||||||
Déclaration de confirmation établie le 12 juil. 2018 sans mise à jour | 3 pages | CS01 | ||||||||||
Comptes pour une société dormante établis au 19 août 2017 | 3 pages | AA | ||||||||||
Modification des détails de Punch Taverns (Dc) Holdings Limited en tant que personne disposant d'un contrôle significatif le 04 sept. 2017 | 2 pages | PSC05 | ||||||||||
Changement d'adresse du siège social de Jubilee House Second Avenue Burton upon Trent Staffordshire DE14 2WF à Elsley Court 20-22 Great Titchfield Street London W1W 8BE le 08 sept. 2017 | 1 pages | AD01 | ||||||||||
Cessation de la nomination de Stephen Peter Dando en tant que directeur le 29 août 2017 | 1 pages | TM01 | ||||||||||
Nomination de Mr David Forde en tant qu'administrateur le 29 août 2017 | 2 pages | AP01 | ||||||||||
Cessation de la nomination de Francesca Appleby en tant que secrétaire le 29 août 2017 | 1 pages | TM02 | ||||||||||
Cessation de la nomination de Edward Michael Bashforth en tant que directeur le 29 août 2017 | 1 pages | TM01 | ||||||||||
Nomination de Mr Christopher John Moore en tant qu'administrateur le 29 août 2017 | 2 pages | AP01 | ||||||||||
Qui sont les dirigeants de PUNCH TAVERNS (WILLOW) LIMITED ?
Nom | Nommé le | Date de démission | Rôle | Adresse | Identification de la société | Pays de résidence | Nationalité | Date de naissance | Profession | Numéro |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MOORE, Christopher John | Administrateur | 3-4 Broadway Park EH12 9JZ Edinburgh Heineken Uk Limited United Kingdom | United Kingdom | British | Director | 136853310001 | ||||
MOUNTSTEVENS, Lawson John Wembridge | Administrateur | 3-4 Broadway Park EH12 9JZ Edinburgh Heineken Uk Limited United Kingdom | England | British | Director | 112375050001 | ||||
PATERSON, Sean Michael | Administrateur | South Gyle Broadway EH12 9JZ Edinburgh 3-4 Broadway Park Scotland | Scotland | British | Finance Director | 257892140001 | ||||
APPLEBY, Francesca | Secrétaire | Second Avenue DE14 2WF Burton Upon Trent Jubilee House Staffordshire United Kingdom | 191629580001 | |||||||
BELL, Richard Edgar, Llb Solicitor | Secrétaire | 13 Harbury Street DE13 0RX Burton On Trent Staffordshire | British | 637110001 | ||||||
GUTHRIE, Harold Alexander | Secrétaire | 61 The Lea ST4 8DY Stoke On Trent Staffordshire | British | 28998620001 | ||||||
HARRIS, Claire Louise | Secrétaire | Second Avenue DE14 2WF Burton Upon Trent Jubilee House Staffordshire United Kingdom | 175490300001 | |||||||
RUDD, Susan Clare | Secrétaire | 17 Thacker Drive WS13 6NS Lichfield Staffordshire | British | 81789210004 | ||||||
STEWART, Claire Susan | Secrétaire | Ninth Avenue DE14 3JZ Burton Upon Trent Sunrise House Staffordshire United Kingdom | British | 117216940001 | ||||||
TYRRELL, Helen | Secrétaire | Second Avenue DE14 2WF Burton Upon Trent Jubilee House Staffordshire United Kingdom | 161809240001 | |||||||
BASHFORTH, Edward Michael | Administrateur | Second Avenue DE14 2WF Burton Upon Trent Jubilee House Staffordshire United Kingdom | United Kingdom | British | Director | 131551840002 | ||||
BELL, Richard Edgar, Llb Solicitor | Administrateur | 13 Harbury Street DE13 0RX Burton On Trent Staffordshire | British | Secretary | 637110001 | |||||
CARTLIDGE, Henry | Administrateur | 4 Woodhouse Lane Woodhouse Meadow Priorslee TF2 9SX Telford Shropshire | British | Company Director | 33545670001 | |||||
CONSTANTINE, Peter Anthony | Administrateur | 83 South Rise CF14 0RG Cardiff South Glamorgan | Wales | British | Chartered Surveyor Estates Dir | 114160540001 | ||||
DANDO, Stephen Peter | Administrateur | Second Avenue DE14 2WF Burton Upon Trent Jubilee House Staffordshire United Kingdom | United Kingdom | British | Chartered Accountant | 152083750001 | ||||
DAVIS, Alan | Administrateur | 4 Ashley Court Ashby Road DE15 0LL Burton On Trent Staffordshire | British | Company Director | 15364140001 | |||||
DUTTON, Philip | Administrateur | Second Avenue DE14 2WF Burton Upon Trent Jubilee House Staffordshire United Kingdom | United Kingdom | British | Director | 141395280001 | ||||
ELKIN, William Irwin | Administrateur | Tudor Lodge Heritage Walk SY13 1JF Whitchurch Salop | British | Production & Dist Director | 28998630003 | |||||
FORDE, David | Administrateur | 3-4 Broadway Park EH12 9JZ Edinburgh Heineken Uk Limited United Kingdom | United Kingdom | Irish | Director | 180590780001 | ||||
GUTHRIE, Harold Alexander | Administrateur | 61 The Lea ST4 8DY Stoke On Trent Staffordshire | British | Company Director | 28998620001 | |||||
JONES, Bruce Abbott | Administrateur | 1 Hall Drive DE13 8TF Hanbury Staffordshire | British | Company Director | 29595900002 | |||||
KEMP, Deborah Jane | Administrateur | 6 Station Road Hampton In Arden B92 0BJ Solihull | United Kingdom | British | Director | 79388130005 | ||||
KERSHAW, Harry | Administrateur | 5 Codham Close The Ithens Sontley Road LL13 7DZ Wrexham Clwyd | British | Company Director | 22215920001 | |||||
MCDONALD, Robert James | Administrateur | 46 Wentworth Drive WS14 9HN Lichfield Staffordshire | British | Director | 42019620001 | |||||
MCLOUGHLIN, Kevin Thomas | Administrateur | Monkhide Tallarn Green SY14 7LJ Malpas Cheshire | British | Head Brewer | 51153090002 | |||||
PENDLETON, Harry | Administrateur | Ashcroft Woodlands Close Thorpe DE6 2AP Ashbourne Derbyshire | British | Company Director | 54398070001 | |||||
PRESTON, Neil David | Administrateur | Second Avenue DE14 2WF Burton Upon Trent Jubilee House Staffordshire United Kingdom | United Kingdom | British | Director | 63043630002 | ||||
STEVENSON, David Robert | Administrateur | 3 Tweentown Donington Le Heath LE67 2GG Coalville Leicestershire | British | Accountant | 40472950001 | |||||
TANNAHILL, David James | Administrateur | 3-4 Broadway Park EH12 9JZ Edinburgh Heineken Uk Limited United Kingdom | Scotland | British | Director | 237381690001 | ||||
WEBSTER, Ronald Edward | Administrateur | Oakmere Murieston Road Hale WA15 9SU Altrincham Cheshire | British | Packaging/Distribution Mng | 54398110001 | |||||
WILKINSON, Anthony Eric | Administrateur | Bupton Grange Longford Lane Longford DE6 3DT Ashbourne Derbyshire | British | Company Director | 4656080002 |
Qui sont les personnes ayant un contrôle significatif sur PUNCH TAVERNS (WILLOW) LIMITED ?
Nom | Notifié le | Adresse | Cessé | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Heineken Uk Limited | 29 août 2017 | Broadway Park South Gyle Broadway EH12 9JZ Edinburgh 3-4 Scotland Scotland | Non | ||||||||||
| |||||||||||||
Nature du contrôle
| |||||||||||||
Punch Taverns (Dc) Holdings Limited | 06 avr. 2016 | 20-22 Great Titchfield Street W1W 8BE London Elsley Court United Kingdom | Non | ||||||||||
| |||||||||||||
Nature du contrôle
|
PUNCH TAVERNS (WILLOW) LIMITED a-t-elle des charges ?
Classification | Dates | Statut | Détails | |
---|---|---|---|---|
Deed of charge | Créé le 22 avr. 2002 Livré le 08 mai 2002 | Totalement satisfaite | Montant garanti All monies due or to become due from the company to the chargee or any of the other spirit secured parties under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Brèves mentions A charge by way of first legal mortgage all of the company's right title interest and benefit present and future in to and under the freehold or leasehold property comprising the spirit mortgaged properties owned by it and described in part 1 of schedule 2 to the charge and all estates or interests in such property and all buildings trade and other fixtures fixed plant and machinery from time to time on such freehold or leasehold property.. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
Deed of charge | Créé le 22 avr. 2002 Livré le 08 mai 2002 | Totalement satisfaite | Montant garanti All monies due or to become due from the company to the security trustee or any of the other pr secured parties on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Brèves mentions By way of assignment all of the company's right, title, interest and benefit, present and future in, to and under the master amendment deed. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
Deed of charge | Créé le 28 juin 2000 Livré le 15 juil. 2000 | Totalement satisfaite | Montant garanti All moneys due or to become due from the company, or any other charging company and/or guarantor to the chargee whether for its own account or as trustee for the pr secured parties or any of the other pr secured parties under or in respect of the issuer/borrower facility agreement, the charge and/or any other transaction documents to which it is a party (all as defined therein) | |
Brèves mentions All right title and interest and benefit, in, to and under the f/h and l/h properties owned by it and described in part 1 of schedule 2 to the charge, and all estates or interests in such property and all buildings, trade and other fixtures, fiall right title interest and benefit, in, to and under the f/h xed plant and machinery a floating charge over the undertaking of all property and assets. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
|
Source de données
- Companies House du Royaume-Uni
Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers. - Licence: CC0