COATS GROUP PLC

  • Vue d'ensemble
  • Résumé
  • Objet social
  • Adresse
  • Dénominations sociales précédentes
  • Comptes
  • Déclaration de confirmation
  • Dépôts
  • Dirigeants
  • Source de données
  • Vue d'ensemble

    Nom de la sociétéCOATS GROUP PLC
    Statut de la sociétéActive
    Forme juridiqueSociété anonyme cotée en bourse
    Numéro de société 00103548
    JuridictionAngleterre/Pays de Galles
    Date de création

    Résumé

    A des PSCs super sécurisésNon
    A des chargesNon
    A un historique d'insolvabilitéNon
    Le siège social est contestéNon

    Quel est l'objet de COATS GROUP PLC ?

    • Activités des sièges sociaux (70100) / Activités spécialisées, scientifiques et techniques

    Où se situe COATS GROUP PLC ?

    Adresse du siège social
    4th Floor 14 Aldermanbury Square
    EC2V 7HS London
    England
    Adresse du siège social non livrableNon

    Quels étaient les noms précédents de COATS GROUP PLC ?

    Dénominations sociales précédentes
    Nom de la sociétéDeJusqu'au
    GUINNESS PEAT GROUP PLC13 déc. 200213 déc. 2002
    BRUNEL HOLDINGS PLC03 janv. 199503 janv. 1995
    B M GROUP PLC01 mai 198501 mai 1985
    BRAHAM MILLAR GROUP PLC17 juin 190917 juin 1909

    Quels sont les derniers comptes de COATS GROUP PLC ?

    En retardNon
    Prochains comptes
    Fin de la prochaine période comptable le31 déc. 2025
    Date d'échéance des prochains comptes30 juin 2026
    Derniers comptes
    Derniers comptes arrêtés au31 déc. 2024

    Quel est le statut de la dernière déclaration de confirmation pour COATS GROUP PLC ?

    Dernière déclaration de confirmation établie jusqu'au05 nov. 2026
    Date d'échéance de la prochaine déclaration de confirmation19 nov. 2026
    Dernière déclaration de confirmation
    Prochaine déclaration de confirmation établie jusqu'au05 nov. 2025
    En retardNon

    Quels sont les derniers dépôts pour COATS GROUP PLC ?

    Dépôts
    DateDescriptionDocumentType

    Modification des coordonnées de l'administrateur Ms Hannah Kate Nichols le 24 janv. 2026

    2 pagesCH01

    Déclaration de confirmation établie le 05 nov. 2025 sans mise à jour

    3 pagesCS01

    legacy

    4 pagesRP04SH01

    État du capital après une attribution d'actions au 21 juil. 2025

    • Capital: GBP 15,978,103.8
    4 pagesSH01
    Annotations
    DateAnnotation
    01 août 2025Clarification A second filed SH01 was registered on 01/08/2025

    Nomination de Gang Wu en tant qu'administrateur le 01 juil. 2025

    2 pagesAP01

    Résolutions

    Resolutions
    3 pagesRESOLUTIONS
    Résolutions
    CatégorieDateDescriptionType
    capital

    Résolution de suppression des droits de préemption

    RES11
    capital

    Résolution d'autorisation d'achat d'un certain nombre d'actions

    RES09
    capital

    Résolutions

    Agm notice 21/05/2025
    RES13
    capital

    Résolution d'attribution de valeurs mobilières

    RES10

    Comptes consolidés établis au 31 déc. 2024

    218 pagesAA

    Cessation de la nomination de Jacqueline Wynn Callaway en tant que directeur le 21 mai 2025

    1 pagesTM01

    Nomination de Ms Hannah Kate Nichols en tant qu'administrateur le 24 avr. 2025

    2 pagesAP01

    Déclaration de confirmation établie le 08 déc. 2024 sans mise à jour

    3 pagesCS01

    Cessation de la nomination de Rajiv Sharma en tant que directeur le 30 sept. 2024

    1 pagesTM01

    Nomination de Mr Srinivas Phatak en tant qu'administrateur le 01 sept. 2024

    2 pagesAP01

    Nomination de Mr David Paja Burgoa en tant qu'administrateur le 01 sept. 2024

    2 pagesAP01

    Comptes consolidés établis au 31 déc. 2023

    211 pagesAA

    Résolutions

    Resolutions
    4 pagesRESOLUTIONS
    Résolutions
    CatégorieDateDescriptionType
    capital

    Résolution de suppression des droits de préemption

    RES11
    capital

    Résolution d'autorisation d'achat d'un certain nombre d'actions

    RES09
    capital

    Résolutions

    Rules of the of the coats group PLC long term incentive plan approved, rulesof the coats group PLC deferred annual bonus plan approved, directors authorised to adopt further schemes, notice for a general meeting 22/05/2024
    RES13
    capital

    Résolution d'attribution de valeurs mobilières

    RES10

    Cessation de la nomination de Nicholas James Douglas Bull en tant que directeur le 22 mai 2024

    1 pagesTM01

    Modification des coordonnées de l'administrateur Ms Jacqueline Wynn Callaway le 15 mars 2024

    2 pagesCH01

    Déclaration de confirmation établie le 08 déc. 2023 sans mise à jour

    3 pagesCS01

    Nomination de Ms Sarah Louise Highfield en tant qu'administrateur le 01 nov. 2023

    2 pagesAP01

    Changement d'adresse du siège social de , the Pavilions Bridgwater Road, Bristol, BS13 8FD, England à 4th Floor 14 Aldermanbury Square London EC2V 7HS le 20 oct. 2023

    1 pagesAD01

    Modification des coordonnées de l'administrateur Mr Rajiv Sharma le 10 oct. 2023

    2 pagesCH01

    Comptes consolidés établis au 31 déc. 2022

    187 pagesAA

    Résolutions

    Resolutions
    3 pagesRESOLUTIONS
    Résolutions
    CatégorieDateDescriptionType
    capital

    Résolution de suppression des droits de préemption

    RES11
    capital

    Résolution d'autorisation d'achat d'un certain nombre d'actions

    RES09
    capital

    Résolutions

    Notice to call general meetings, not agm 17/05/2023
    RES13
    capital

    Résolution d'attribution de valeurs mobilières

    RES10

    Cessation de la nomination de Heather Lawrence en tant que directeur le 31 mars 2023

    1 pagesTM01

    Déclaration de confirmation établie le 08 déc. 2022 sans mise à jour

    3 pagesCS01

    Qui sont les dirigeants de COATS GROUP PLC ?

    Dirigeants
    NomNommé leDate de démissionRôleAdresseIdentification de la sociétéPays de résidenceNationalitéDate de naissanceProfessionNuméro
    MORGAN, Stuart John
    14 Aldermanbury Square
    EC2V 7HS London
    4th Floor
    England
    Secrétaire
    14 Aldermanbury Square
    EC2V 7HS London
    4th Floor
    England
    191227060001
    GOSNELL, David Peter
    14 Aldermanbury Square
    EC2V 7HS London
    4th Floor
    England
    Administrateur
    14 Aldermanbury Square
    EC2V 7HS London
    4th Floor
    England
    EnglandBritish71048770002
    HIGHFIELD, Sarah Louise
    14 Aldermanbury Square
    EC2V 7HS London
    4th Floor
    England
    Administrateur
    14 Aldermanbury Square
    EC2V 7HS London
    4th Floor
    England
    United KingdomBritish197724250001
    LU, Hongyan Echo
    14 Aldermanbury Square
    EC2V 7HS London
    4th Floor
    England
    Administrateur
    14 Aldermanbury Square
    EC2V 7HS London
    4th Floor
    England
    EnglandBritish240837970002
    MURRAY, Stephen Matthew
    14 Aldermanbury Square
    EC2V 7HS London
    4th Floor
    England
    Administrateur
    14 Aldermanbury Square
    EC2V 7HS London
    4th Floor
    England
    United KingdomBritish192384210001
    NICHOLS, Hannah Kate
    14 Aldermanbury Square
    EC2V 7HS London
    4th Floor
    England
    Administrateur
    14 Aldermanbury Square
    EC2V 7HS London
    4th Floor
    England
    EnglandBritish335039580002
    PAJA BURGOA, David
    14 Aldermanbury Square
    EC2V 7HS London
    4th Floor
    England
    Administrateur
    14 Aldermanbury Square
    EC2V 7HS London
    4th Floor
    England
    EnglandSpanish326675000001
    PHATAK, Srinivas
    14 Aldermanbury Square
    EC2V 7HS London
    4th Floor
    England
    Administrateur
    14 Aldermanbury Square
    EC2V 7HS London
    4th Floor
    England
    EnglandIndian305897190001
    PHILIP, Frances Paxson
    14 Aldermanbury Square
    EC2V 7HS London
    4th Floor
    England
    Administrateur
    14 Aldermanbury Square
    EC2V 7HS London
    4th Floor
    England
    United StatesAmerican216069030001
    SIGURDSSON, Jakob
    14 Aldermanbury Square
    EC2V 7HS London
    4th Floor
    England
    Administrateur
    14 Aldermanbury Square
    EC2V 7HS London
    4th Floor
    England
    EnglandIcelandic274858980001
    WU, Gang
    14 Aldermanbury Square
    EC2V 7HS London
    4th Floor
    England
    Administrateur
    14 Aldermanbury Square
    EC2V 7HS London
    4th Floor
    England
    EnglandBritish193394560001
    HEALY, Chritopher William
    Pall Mall
    SW1Y 5ES London
    78
    England
    Secrétaire
    Pall Mall
    SW1Y 5ES London
    78
    England
    British146217840001
    KING, John Alan Gibbs
    10 Ashvale Close
    Nailsea
    BS48 1QH Bristol
    Secrétaire
    10 Ashvale Close
    Nailsea
    BS48 1QH Bristol
    British9313920001
    RUSSELL, James Richard
    The Old Stables
    Empingham Road
    PE9 3RP Ketton
    Rutland
    Secrétaire
    The Old Stables
    Empingham Road
    PE9 3RP Ketton
    Rutland
    British904390002
    PRISM COSEC LIMITED
    Margaret Street
    W1W 8RL London
    10
    England
    Secrétaire
    Margaret Street
    W1W 8RL London
    10
    England
    Type d'identificationEEE
    Numéro d'enregistrement05533248
    116519070002
    ALLEN, Michael Nicholas
    The Square
    Stockley Park
    UB11 1TD Uxbridge
    1
    Middlesex
    England
    Administrateur
    The Square
    Stockley Park
    UB11 1TD Uxbridge
    1
    Middlesex
    England
    New ZealandNew Zealander154487670001
    ANDERSON, Moreen Ruth
    The Square
    Stockley Park
    UB11 1TD Uxbridge
    1
    Middlesex
    England
    Administrateur
    The Square
    Stockley Park
    UB11 1TD Uxbridge
    1
    Middlesex
    England
    United KingdomBritish187696210002
    BARRETT, Barrie Michael
    The Firs
    Spetchley Road
    WR5 2NL Worcester
    Worcestershire
    Administrateur
    The Firs
    Spetchley Road
    WR5 2NL Worcester
    Worcestershire
    British4061200002
    BEYER, Trevor Jorgen Nielsen
    14 Walnut Court
    St Marys Gate
    W8 5UB London
    Administrateur
    14 Walnut Court
    St Marys Gate
    W8 5UB London
    New Zealander6621410001
    BODDIE, Simon
    Longwalk Road
    Stockley Park
    UB11 1FE Uxbridge
    4
    England
    Administrateur
    Longwalk Road
    Stockley Park
    UB11 1FE Uxbridge
    4
    England
    United KingdomBritish289650160001
    BRIERLEY, Ronald Alfred, Sir
    The Square
    Stockley Park
    UB11 1TD Uxbridge
    1
    Middlesex
    England
    Administrateur
    The Square
    Stockley Park
    UB11 1TD Uxbridge
    1
    Middlesex
    England
    AustraliaNew Zealander87147990001
    BULL, Nicholas James Douglas
    14 Aldermanbury Square
    EC2V 7HS London
    4th Floor
    England
    Administrateur
    14 Aldermanbury Square
    EC2V 7HS London
    4th Floor
    England
    United KingdomBritish35443110002
    CALLAWAY, Jacqueline Wynn
    14 Aldermanbury Square
    EC2V 7HS London
    4th Floor
    England
    Administrateur
    14 Aldermanbury Square
    EC2V 7HS London
    4th Floor
    England
    EnglandNew Zealander277130130002
    CAMPBELL, Robert James
    The Square
    Stockley Park
    UB11 1TD Uxbridge
    1
    Middlesex
    England
    Administrateur
    The Square
    Stockley Park
    UB11 1TD Uxbridge
    1
    Middlesex
    England
    New ZealandNew Zealander281138640001
    CLASPER, Michael
    Longwalk Road
    Stockley Park
    UB11 1FE Uxbridge
    4
    England
    Administrateur
    Longwalk Road
    Stockley Park
    UB11 1FE Uxbridge
    4
    England
    United KingdomBritish181056620002
    CURETON, Graeme James
    45 Victor Avenue
    Picnic Point
    New South Wales
    2213
    Australia
    Administrateur
    45 Victor Avenue
    Picnic Point
    New South Wales
    2213
    Australia
    Australian87148340001
    FAHY, Anne Kathleen
    Longwalk Road
    Stockley Park
    UB11 1FE Uxbridge
    4
    England
    Administrateur
    Longwalk Road
    Stockley Park
    UB11 1FE Uxbridge
    4
    England
    EnglandIrish174845290001
    FORMAN, Paul Anthony
    The Square
    Stockley Park
    UB11 1TD Uxbridge
    1
    Middlesex
    England
    Administrateur
    The Square
    Stockley Park
    UB11 1TD Uxbridge
    1
    Middlesex
    England
    United KingdomBritish148283170001
    GIBBS, Anthony Ian
    45 Pall Mall
    SW1Y 5GP London
    First Floor Times Place
    Administrateur
    45 Pall Mall
    SW1Y 5GP London
    First Floor Times Place
    New ZealandBritish New Zealander47689160002
    HALL, Graham
    Walls Farm Stoughton Road
    Stoughton
    BS28 4PP Wedmore
    Somerset
    Administrateur
    Walls Farm Stoughton Road
    Stoughton
    BS28 4PP Wedmore
    Somerset
    British57562800001
    HICKS, Alun George
    Westways
    Tintagel Road Finchampstead
    RG40 3JJ Wokingham
    Berkshire
    Administrateur
    Westways
    Tintagel Road Finchampstead
    RG40 3JJ Wokingham
    Berkshire
    EnglandBritish73305120001
    HOWES, Richard David
    The Square
    Stockley Park
    UB11 1TD Uxbridge
    1
    Middlesex
    England
    Administrateur
    The Square
    Stockley Park
    UB11 1TD Uxbridge
    1
    Middlesex
    England
    EnglandBritish265695690001
    JOHNSON, Mark Roderick Granger
    Level 9
    66 Hunter Street
    2000 Sydney
    Suite 7
    New South Wales
    Australia
    Administrateur
    Level 9
    66 Hunter Street
    2000 Sydney
    Suite 7
    New South Wales
    Australia
    AustraliaAustralian154484900001
    LANGLEY, Ronald
    45 Pall Mall
    SW1Y 5GP London
    First Floor Times Place
    Administrateur
    45 Pall Mall
    SW1Y 5GP London
    First Floor Times Place
    Australian139002690001
    LAWRENCE, Heather
    Bridgwater Road
    BS13 8FD Bristol
    The Pavilions
    England
    Administrateur
    Bridgwater Road
    BS13 8FD Bristol
    The Pavilions
    England
    SwitzerlandBritish301958220001

    Source de données

    • Companies House du Royaume-Uni
      Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers.
    • Licence: CC0