SUTER ESTATES LIMITED

  • Vue d'ensemble
  • Résumé
  • Objet social
  • Adresse
  • Dénominations sociales précédentes
  • Comptes
  • Dépôts
  • Dirigeants
  • Charges
  • Insolvabilité
  • Source de données
  • Vue d'ensemble

    Nom de la sociétéSUTER ESTATES LIMITED
    Statut de la sociétéDissoute
    Forme juridiqueSociété à responsabilité limitée
    Numéro de société 00107150
    JuridictionAngleterre/Pays de Galles
    Date de création
    Date de cessation d'activité

    Résumé

    A des PSCs super sécurisésNon
    A des chargesOui
    A un historique d'insolvabilitéOui
    Le siège social est contestéNon

    Quel est l'objet de SUTER ESTATES LIMITED ?

    • (7020) /

    Où se situe SUTER ESTATES LIMITED ?

    Adresse du siège social
    Olympia House
    Armitage Road
    NW11 8RQ London
    Adresse du siège social non livrableNon

    Quels étaient les noms précédents de SUTER ESTATES LIMITED ?

    Dénominations sociales précédentes
    Nom de la sociétéDeJusqu'au
    HERMETIC SECURITIES LIMITED26 janv. 191026 janv. 1910

    Quels sont les derniers comptes de SUTER ESTATES LIMITED ?

    Derniers comptes
    Derniers comptes arrêtés au31 mars 2011

    Quels sont les derniers dépôts pour SUTER ESTATES LIMITED ?

    Dépôts
    DateDescriptionDocumentType

    Gazette finale dissoute à la suite d'une liquidation

    1 pagesGAZ2

    Retour de la réunion finale dans une liquidation volontaire des membres

    2 pages4.71

    Changement d'adresse du siège social de Nations House 103 Wigmore Street London W1U 1AE le 08 mars 2012

    2 pagesAD01

    Nomination d'un liquidateur volontaire

    1 pages600

    Résolutions

    Resolutions
    1 pagesRESOLUTIONS
    Résolutions
    CatégorieDateDescriptionType
    liquidation

    Résolution spéciale pour la liquidation au 28 févr. 2012

    LRESSP

    Déclaration de solvabilité

    3 pages4.70

    Cessation de la nomination de Vinod Bachulal Vaghela en tant que directeur le 21 déc. 2011

    1 pagesTM01

    Comptes annuels établis au 31 mars 2011

    10 pagesAA

    Déclaration annuelle jusqu'au 03 mai 2011 avec liste complète des actionnaires

    6 pagesAR01
    Dépôts associés
    CatégorieDateDescriptionType
    capital03 mai 2011

    État du capital au 03 mai 2011

    • Capital: GBP 100,000
    SH01

    Comptes annuels établis au 31 mars 2010

    11 pagesAA

    Cessation de la nomination de Philip Warner en tant que directeur

    1 pagesTM01

    legacy

    3 pagesMG02

    legacy

    3 pagesMG02

    Déclaration annuelle jusqu'au 03 mai 2010 avec liste complète des actionnaires

    6 pagesAR01

    Comptes annuels établis au 31 mars 2009

    11 pagesAA

    legacy

    2 pages288a

    legacy

    1 pages288b

    legacy

    4 pages363a

    legacy

    1 pages288a

    legacy

    1 pages288b

    Comptes annuels établis au 31 mars 2008

    13 pagesAA

    legacy

    4 pages363a

    Comptes annuels établis au 31 mars 2007

    15 pagesAA

    legacy

    3 pages363a

    Comptes annuels établis au 31 mars 2006

    17 pagesAA

    Qui sont les dirigeants de SUTER ESTATES LIMITED ?

    Dirigeants
    NomNommé leDate de démissionRôleAdresseIdentification de la sociétéPays de résidenceNationalitéDate de naissanceProfessionNuméro
    LANCHESTER, David James
    1 Holly Close
    IG9 6HT Buckhurst Hill
    Essex
    Secrétaire
    1 Holly Close
    IG9 6HT Buckhurst Hill
    Essex
    British7014460002
    GAME, Robert William
    Newbury Lane
    Cousley Wood
    TN5 6HD Wadhurst
    Rosemary Cottage
    East Sussex
    Administrateur
    Newbury Lane
    Cousley Wood
    TN5 6HD Wadhurst
    Rosemary Cottage
    East Sussex
    United KingdomEnglish139555050001
    KEOGH, Mark William
    Norfolk House 28 Kidmore Road
    Caversham
    RG4 7LU Reading
    Administrateur
    Norfolk House 28 Kidmore Road
    Caversham
    RG4 7LU Reading
    EnglandIrish62140690001
    BLYTHE-TINKER, Nigel Edwin
    Top Farm
    High Street
    PE19 6RX Toseland
    Cambs
    Secrétaire
    Top Farm
    High Street
    PE19 6RX Toseland
    Cambs
    British63851130001
    FOLGER, Susan
    12 Court Lane Gardens
    Dulwich
    SE21 7DZ London
    Secrétaire
    12 Court Lane Gardens
    Dulwich
    SE21 7DZ London
    British36525980001
    HENSON, Mark Richard
    5 Hazeland Steading
    PE10 0PW Morton
    Lincolnshire
    Secrétaire
    5 Hazeland Steading
    PE10 0PW Morton
    Lincolnshire
    British104630800001
    LOWES, Richard Phillip
    2 Westcott Keep
    RH6 9US Horley
    Surrey
    Secrétaire
    2 Westcott Keep
    RH6 9US Horley
    Surrey
    British5785520001
    PATON WALSH, Antony Edmund
    60 Mount Ararat Road
    TW10 6PJ Richmond
    Surrey
    Secrétaire
    60 Mount Ararat Road
    TW10 6PJ Richmond
    Surrey
    British43425770001
    WILLIAMS, John Benedict Alan
    16 Oakwood Road
    Golders Green
    NW11 6QY London
    Secrétaire
    16 Oakwood Road
    Golders Green
    NW11 6QY London
    British79419360001
    ASCOT CORPORATE SECRETARIES LIMITED
    2 Heathrow Boulevard
    284 Bath Road
    UB7 0DQ West Drayton
    Middlesex
    Secrétaire
    2 Heathrow Boulevard
    284 Bath Road
    UB7 0DQ West Drayton
    Middlesex
    69324550001
    ABELL, John David
    The Old Rectory Main Street
    Branston By Belvoir
    NG32 1RU Grantham
    Lincolnshire
    Administrateur
    The Old Rectory Main Street
    Branston By Belvoir
    NG32 1RU Grantham
    Lincolnshire
    United KingdomBritish71975220001
    COLLINS, Peter William
    The Oaks
    23 Croft Road
    RG40 3HX Wokingham
    Berkshire
    Administrateur
    The Oaks
    23 Croft Road
    RG40 3HX Wokingham
    Berkshire
    United KingdomBritish26086560001
    EDWARDS, John Nigel
    8b Avery Row
    Mayfair
    W1K 4AL London
    Administrateur
    8b Avery Row
    Mayfair
    W1K 4AL London
    United KingdomBritish37742270003
    EDWARDS, John Nigel
    976b Garratt Lane
    SW17 0ND London
    Administrateur
    976b Garratt Lane
    SW17 0ND London
    British37742270001
    FERGUSON, Daniel
    33 The Avenue
    EN6 1EG Potters Bar
    Hertfordshire
    Administrateur
    33 The Avenue
    EN6 1EG Potters Bar
    Hertfordshire
    United KingdomBritish29071630001
    FIRTH, Arthur Gregory
    Westridge House
    Belvoir Close
    Colsterworth
    Lincolnshire
    Administrateur
    Westridge House
    Belvoir Close
    Colsterworth
    Lincolnshire
    British17118450001
    FOLGER, Susan
    12 Court Lane Gardens
    Dulwich
    SE21 7DZ London
    Administrateur
    12 Court Lane Gardens
    Dulwich
    SE21 7DZ London
    British36525980001
    GRANT, John Albert Martin
    The Malthouse Manor Lane
    Claverdon
    CV35 8NH Warwick
    Warwickshire
    Administrateur
    The Malthouse Manor Lane
    Claverdon
    CV35 8NH Warwick
    Warwickshire
    EnglandBritish55161940001
    HEATHWOOD, Derek Kevin
    47 Fullarton Crescent
    KA10 6LL Troon
    South Ayrshire
    Administrateur
    47 Fullarton Crescent
    KA10 6LL Troon
    South Ayrshire
    British85468580002
    HEWITT, Alan
    The White House Casthorpe Road
    Barrowby
    NG32 1DW Grantham
    Lincolnshire
    Administrateur
    The White House Casthorpe Road
    Barrowby
    NG32 1DW Grantham
    Lincolnshire
    British572100002
    HOARE, Brian David
    The Old Barn 32 High Street
    LE14 4AH Waltham On The Wolds
    Leicestershire
    Administrateur
    The Old Barn 32 High Street
    LE14 4AH Waltham On The Wolds
    Leicestershire
    British28340230001
    JONES, Morgan Lewis
    4 Camden Close
    BR7 5PH Chislehurst
    Kent
    Administrateur
    4 Camden Close
    BR7 5PH Chislehurst
    Kent
    EnglandBritish10146340003
    MEADE, Karl Robert
    Holly Mount
    Penn Road
    HP9 2TS Beaconsfield
    Buckinghamshire
    Administrateur
    Holly Mount
    Penn Road
    HP9 2TS Beaconsfield
    Buckinghamshire
    EnglandBritish118074370001
    MOORE, Richard
    88 Alzey Gardens
    AL5 5SZ Harpenden
    Hertfordshire
    Administrateur
    88 Alzey Gardens
    AL5 5SZ Harpenden
    Hertfordshire
    British73793650001
    REYNOLDS, Malcolm Stanley
    74 Scatterdells Lane
    Chipperfield
    WD4 9EX Kings Langley
    Hertfordshire
    Administrateur
    74 Scatterdells Lane
    Chipperfield
    WD4 9EX Kings Langley
    Hertfordshire
    British10865710001
    RIDER, Stuart Granville
    3 Kesteven Court
    North Parade
    NG31 8FP Grantham
    Lincolnshire
    Administrateur
    3 Kesteven Court
    North Parade
    NG31 8FP Grantham
    Lincolnshire
    British36675890002
    RILEY, Michael James
    16 Ladbroke Road
    W11 3NJ London
    Administrateur
    16 Ladbroke Road
    W11 3NJ London
    British3055390001
    STEVENS, Michael John
    32 Woodfield Park
    HP6 5QH Amersham
    Buckinghamshire
    Administrateur
    32 Woodfield Park
    HP6 5QH Amersham
    Buckinghamshire
    United KingdomBritish60348780002
    VAGHELA, Vinod Bachulal
    99 Cathles Road
    Balham
    SW12 9LF London
    Administrateur
    99 Cathles Road
    Balham
    SW12 9LF London
    EnglandBritish5689250001
    VINCENT, Michael
    23 Saint Aubyns's Avenue
    SW19 7BL London
    Administrateur
    23 Saint Aubyns's Avenue
    SW19 7BL London
    EnglandBritish99258270001
    WARNER, Philip Courtenay Thomas, Sir
    Marden Grange
    Marden
    SN10 3RQ Devizes
    Wiltshire
    Administrateur
    Marden Grange
    Marden
    SN10 3RQ Devizes
    Wiltshire
    United KingdomBritish7356840001
    WATSON, Ian Richard
    Old Dove House
    Annables Lane
    AL5 3PR Harpenden
    Hertfordshire
    Administrateur
    Old Dove House
    Annables Lane
    AL5 3PR Harpenden
    Hertfordshire
    EnglandBritish68256540001
    WILLIAMS, John Benedict Alan
    16 Oakwood Road
    Golders Green
    NW11 6QY London
    Administrateur
    16 Oakwood Road
    Golders Green
    NW11 6QY London
    British79419360001
    ASCOT CORPORATE DIRECTORS LIMIYED
    2 Heathrow Boulevard
    284 Bath Road
    UB7 0DQ West Drayton
    Middlesex
    Administrateur
    2 Heathrow Boulevard
    284 Bath Road
    UB7 0DQ West Drayton
    Middlesex
    67372750003

    SUTER ESTATES LIMITED a-t-elle des charges ?

    Charges
    ClassificationDatesStatutDétails
    Security agreement
    Créé le 22 juil. 2005
    Livré le 04 août 2005
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from each obligor to any finance party under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Anglo Irish Bank Corporation PLC (The "Agent") as Agent and Trustee for the Finance Parties
    Transactions
    • 04 août 2005Enregistrement d'une charge (395)
    • 01 juil. 2010Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (MG02)
    Mezzanine security agreement
    Créé le 22 juil. 2005
    Livré le 01 août 2005
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from each mezzanine obligor to the lender on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    By way of fixed charge all estates or interest in any f/h or l/h property now or subsequently owned by it, by way of fixed charge its interests in all investments now or subsequently held by it. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Warner Estate, Limited
    Transactions
    • 01 août 2005Enregistrement d'une charge (395)
    • 01 juil. 2010Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (MG02)
    Deed of debenture
    Créé le 16 juil. 2003
    Livré le 21 juil. 2003
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    F/H property 2/22 yorkshire street, burnley t/n LA809118. F/h property the new inn roundabout, pontypool t/n WA583381, f/h property 15 fir tree road hastings t/n HT18815.
    Personnes ayant droit
    • National Westminster Bank PLC
    Transactions
    • 21 juil. 2003Enregistrement d'une charge (395)
    • 05 août 2004Déclaration que tout ou partie de la propriété d'une charge flottante a été libérée (403b)
    • 19 juil. 2005Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Debenture
    Créé le 29 déc. 1998
    Livré le 07 janv. 1999
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under or pursuant to the finance documents (as defined)
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Barclays Bank PLC,as Trustee for the Beneficiaries (As Defined)
    Transactions
    • 07 janv. 1999Enregistrement d'une charge (395)
    • 08 avr. 1999Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Deed of admission
    Créé le 23 mars 1995
    Livré le 10 avr. 1995
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Lloyds Bank PLC
    Transactions
    • 10 avr. 1995Enregistrement d'une charge (395)
    Omnibus debenture
    Créé le 25 mai 1994
    Livré le 01 juin 1994
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Lloyds Bank PLC
    Transactions
    • 01 juin 1994Enregistrement d'une charge (395)
    Debenture
    Créé le 25 févr. 1982
    Livré le 05 mars 1982
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Fixed and floaitng charges over undertaking and all property including property listed in schedule attached to doc M139 and assets present and future inlcuding uncalled capital with all buildings fixtures (including trade fixtures) fixed plant & machinery.
    Personnes ayant droit
    • Lloyds Bank PLC
    Transactions
    • 05 mars 1982Enregistrement d'une charge
    • 25 juin 1994Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Letter of set-off
    Créé le 21 mai 1981
    Livré le 28 mai 1981
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Any sum or sums for the time being standing to the credit of any present or future account of the company with lloyds bank limited.
    Personnes ayant droit
    • Lloyds Bank PLC
    Transactions
    • 28 mai 1981Enregistrement d'une charge
    Special omnibus letter of set off
    Créé le 30 juin 1980
    Livré le 08 juil. 1980
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Any sum of sums for the time being standing to the credit of any present or future account of the company with lloyds bank limited.
    Personnes ayant droit
    • Lloyds Bank PLC
    Transactions
    • 08 juil. 1980Enregistrement d'une charge
    Special omnibus letter of set off
    Créé le 01 janv. 1979
    Livré le 08 janv. 1979
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Any sum or sums for the time being standing to the credit of any present or future account of the company with lloyds bank limited.
    Personnes ayant droit
    • Lloyds Bank PLC
    Transactions
    • 08 janv. 1979Enregistrement d'une charge
    • 24 mai 1997Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)

    SUTER ESTATES LIMITED a-t-elle des procédures d'insolvabilité ?

    Numéro de dossierDatesTypePraticiensAutre
    1
    DateType
    09 nov. 2012Dissolved on
    28 févr. 2012Commencement of winding up
    Members voluntary liquidation
    NomRôleAdresseNommé leCessé le
    Stephen Gordon Franklin
    Panos Eliades Franklin & Co Olympia House
    Armitage Road
    NW11 8RQ London
    practitioner
    Panos Eliades Franklin & Co Olympia House
    Armitage Road
    NW11 8RQ London

    Source de données

    • Companies House du Royaume-Uni
      Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers.
    • Licence: CC0