BATES MOTORS (BELCHER) LIMITED

BATES MOTORS (BELCHER) LIMITED

  • Vue d'ensemble
  • Résumé
  • Objet social
  • Adresse
  • Comptes
  • Dépôts
  • Dirigeants
  • Personnes ayant un contrôle significatif
  • Charges
  • Source de données
  • Vue d'ensemble

    Nom de la sociétéBATES MOTORS (BELCHER) LIMITED
    Statut de la sociétéDissoute
    Forme juridiqueSociété à responsabilité limitée
    Numéro de société 00107744
    JuridictionAngleterre/Pays de Galles
    Date de création
    Date de cessation d'activité

    Résumé

    A des PSCs super sécurisésNon
    A des chargesOui
    A un historique d'insolvabilitéNon
    Le siège social est contestéNon

    Quel est l'objet de BATES MOTORS (BELCHER) LIMITED ?

    • Société inactive (99999) / Activités des organisations et organismes extraterritoriaux

    Où se situe BATES MOTORS (BELCHER) LIMITED ?

    Adresse du siège social
    First Floor Unit 3140 Park Square Solihull Parkway
    Birmingham Business Park
    B37 7YN Birmingham
    Adresse du siège social non livrableNon

    Quels sont les derniers comptes de BATES MOTORS (BELCHER) LIMITED ?

    Derniers comptes
    Derniers comptes arrêtés au31 déc. 2019

    Quels sont les derniers dépôts pour BATES MOTORS (BELCHER) LIMITED ?

    Dépôts
    DateDescriptionDocumentType

    Bulletin officiel final dissous par radiation volontaire

    1 pagesGAZ2(A)

    Premier avis au Bulletin officiel pour la radiation volontaire

    1 pagesGAZ1(A)

    Demande de radiation de la société du registre du commerce

    2 pagesDS01

    Déclaration de confirmation établie le 31 janv. 2021 sans mise à jour

    3 pagesCS01

    Comptes pour une société dormante établis au 31 déc. 2019

    5 pagesAA

    Nomination de Miss Farheen Ahmad en tant qu'administrateur le 14 févr. 2020

    2 pagesAP01

    Déclaration de confirmation établie le 31 janv. 2020 sans mise à jour

    3 pagesCS01

    Cessation de la nomination de Thomas Andrew Dale en tant que directeur le 29 janv. 2020

    1 pagesTM01

    Comptes pour une société dormante établis au 31 déc. 2018

    5 pagesAA

    Nomination de Mr Thomas Andrew Dale en tant qu'administrateur le 04 juil. 2019

    2 pagesAP01

    Cessation de la nomination de Anton Clive Jeary en tant que directeur le 04 juil. 2019

    1 pagesTM01

    Déclaration de confirmation établie le 31 janv. 2019 sans mise à jour

    3 pagesCS01

    Comptes pour une société dormante établis au 31 déc. 2017

    5 pagesAA

    Modification des détails de Inchcape Transition Limited en tant que personne disposant d'un contrôle significatif le 01 avr. 2018

    5 pagesPSC05

    Modification des coordonnées du secrétaire Inchcape Uk Corporate Management Limited le 01 avr. 2018

    3 pagesCH04

    Changement d'adresse du siège social de Inchcape House Langford Lane Kidlington Oxford OX5 1HT à First Floor Unit 3140 Park Square Solihull Parkway Birmingham Business Park Birmingham B37 7YN le 09 avr. 2018

    2 pagesAD01

    Déclaration de confirmation établie le 31 janv. 2018 sans mise à jour

    3 pagesCS01

    Comptes pour une société dormante établis au 31 déc. 2016

    5 pagesAA

    Déclaration de confirmation établie le 31 janv. 2017 avec mises à jour

    5 pagesCS01

    Comptes pour une société dormante établis au 31 déc. 2015

    5 pagesAA

    Déclaration annuelle jusqu'au 31 janv. 2016 avec liste complète des actionnaires

    4 pagesAR01
    Dépôts associés
    CatégorieDateDescriptionType
    capital22 févr. 2016

    État du capital au 22 févr. 2016

    • Capital: GBP 2,550
    SH01

    Comptes pour une société dormante établis au 31 déc. 2014

    5 pagesAA

    Déclaration annuelle jusqu'au 31 janv. 2015 avec liste complète des actionnaires

    4 pagesAR01
    Dépôts associés
    CatégorieDateDescriptionType
    capital11 févr. 2015

    État du capital au 11 févr. 2015

    • Capital: GBP 2,550
    SH01

    Comptes pour une société dormante établis au 31 déc. 2013

    5 pagesAA

    Déclaration annuelle jusqu'au 31 janv. 2014 avec liste complète des actionnaires

    4 pagesAR01
    Dépôts associés
    CatégorieDateDescriptionType
    capital17 févr. 2014

    État du capital au 17 févr. 2014

    • Capital: GBP 2,550
    SH01

    Qui sont les dirigeants de BATES MOTORS (BELCHER) LIMITED ?

    Dirigeants
    NomNommé leDate de démissionRôleAdresseIdentification de la sociétéPays de résidenceNationalitéDate de naissanceProfessionNuméro
    INCHCAPE UK CORPORATE MANAGEMENT LIMITED
    Park Square Solihull Parkway
    Birmingham Business Park
    B37 7YN Birmingham
    First Floor Unit 3140
    United Kingdom
    Secrétaire
    Park Square Solihull Parkway
    Birmingham Business Park
    B37 7YN Birmingham
    First Floor Unit 3140
    United Kingdom
    Type d'identificationSociété à responsabilité limitée du Royaume-Uni
    Numéro d'enregistrement5200589
    100307260071
    AHMAD, Farheen
    Solihull Parkway
    Birmingham Business Park
    B37 7YN Birmingham
    First Floor Unit 3140 Park Square
    Administrateur
    Solihull Parkway
    Birmingham Business Park
    B37 7YN Birmingham
    First Floor Unit 3140 Park Square
    EnglandBritish266847010001
    INCHCAPE CORPORATE SERVICES LIMITED
    St James's Square
    SW1Y 5LP London
    22a
    England
    Administrateur
    St James's Square
    SW1Y 5LP London
    22a
    England
    Type d'identificationSociété à responsabilité limitée du Royaume-Uni
    Numéro d'enregistrement1235709
    79689420001
    GATHERCOLE, Paul Trevor
    64 Marlowe Way
    CO3 4JP Colchester
    Essex
    Secrétaire
    64 Marlowe Way
    CO3 4JP Colchester
    Essex
    British91445650001
    JEARY, Anton Clive
    105a St Peters Road
    West Lynn
    PE34 3JR Kings Lynn
    Norfolk
    Secrétaire
    105a St Peters Road
    West Lynn
    PE34 3JR Kings Lynn
    Norfolk
    British92285800001
    NEWMAN, Robin Alfred
    Acorn Cottage The Ridge
    Little Baddow
    CM3 4RT Chelmsford
    Essex
    Secrétaire
    Acorn Cottage The Ridge
    Little Baddow
    CM3 4RT Chelmsford
    Essex
    British6138000001
    WHEATLEY, Martin Peter
    Amberley Lambridge Wood Road
    RG9 3BS Henley On Thames
    Oxfordshire
    Secrétaire
    Amberley Lambridge Wood Road
    RG9 3BS Henley On Thames
    Oxfordshire
    British55180460001
    BELCHER, Edward Stephen Argent
    Ulting Hall
    Ulting
    CM9 6QR Maldon
    Essex
    Administrateur
    Ulting Hall
    Ulting
    CM9 6QR Maldon
    Essex
    British28491690001
    BELCHER, Hilary Angela Argent
    Ulting Hall Eastae
    Ulting
    CM9 6QR Maldon
    Essex
    Administrateur
    Ulting Hall Eastae
    Ulting
    CM9 6QR Maldon
    Essex
    British36358000001
    BELCHER, Vera Mary
    Highlands Highlands Drive
    CM9 6HX Maldon
    Essex
    Administrateur
    Highlands Highlands Drive
    CM9 6HX Maldon
    Essex
    British6138020001
    BOULT, Richard David
    22 Geneva Road
    KT1 2TW Kingston Upon Thames
    Surrey
    Administrateur
    22 Geneva Road
    KT1 2TW Kingston Upon Thames
    Surrey
    EnglandBritish57391140001
    DALE, Thomas Andrew
    Solihull Parkway
    Birmingham Business Park
    B37 7YN Birmingham
    First Floor Unit 3140 Park Square
    Administrateur
    Solihull Parkway
    Birmingham Business Park
    B37 7YN Birmingham
    First Floor Unit 3140 Park Square
    United KingdomBritish260286850001
    FRANKLIN, Christopher Tom
    Woodway Barn Woodway Road
    Sibford Ferris
    OX15 5DA Banbury
    Oxfordshire
    Administrateur
    Woodway Barn Woodway Road
    Sibford Ferris
    OX15 5DA Banbury
    Oxfordshire
    British70288830001
    HAZELWOOD, Robert
    Wistaria House
    14 Ethorpe Close
    SL9 8PL Gerrards Cross
    Buckinghamshire
    Administrateur
    Wistaria House
    14 Ethorpe Close
    SL9 8PL Gerrards Cross
    Buckinghamshire
    British70288980002
    JEARY, Anton Clive
    Solihull Parkway
    Birmingham Business Park
    B37 7YN Birmingham
    First Floor Unit 3140 Park Square
    Administrateur
    Solihull Parkway
    Birmingham Business Park
    B37 7YN Birmingham
    First Floor Unit 3140 Park Square
    EnglandBritish169892630001
    MCCORMACK, Connor
    New College House
    Alchester Road
    OX26 1UN Chesterton
    Oxfordshire
    Administrateur
    New College House
    Alchester Road
    OX26 1UN Chesterton
    Oxfordshire
    United KingdomBritish108832810002
    NEWMAN, Robin Alfred
    Acorn Cottage The Ridge
    Little Baddow
    CM3 4RT Chelmsford
    Essex
    Administrateur
    Acorn Cottage The Ridge
    Little Baddow
    CM3 4RT Chelmsford
    Essex
    British6138000001
    RABAN, Mark Douglas
    18 Orchard Lane
    MK43 7BP Harrold
    Bedfordshire
    Administrateur
    18 Orchard Lane
    MK43 7BP Harrold
    Bedfordshire
    United KingdomBritish261262130001
    SKELTON, Robert John
    233 Plumberow Avenue
    SS5 5NZ Hockley
    Essex
    Administrateur
    233 Plumberow Avenue
    SS5 5NZ Hockley
    Essex
    EnglandBritish8028550001
    VICKERS, David York
    Little Bell Hill
    Bakers Lane
    CM3 4NS Danbury
    Essex
    Administrateur
    Little Bell Hill
    Bakers Lane
    CM3 4NS Danbury
    Essex
    British76394030001
    WALLWORK, Paul Anthony Hewitt
    Baytree Cottage
    Church Road Lyndon
    LE15 8TU Oakham
    Rutland
    Administrateur
    Baytree Cottage
    Church Road Lyndon
    LE15 8TU Oakham
    Rutland
    British113014520001
    WALTER, Kevin Raymond
    Little Hill Farm
    Mope Lane
    CM8 3JP Wickham Bishops
    Essex
    Administrateur
    Little Hill Farm
    Mope Lane
    CM8 3JP Wickham Bishops
    Essex
    EnglandBritish91445840002
    WHEATLEY, Martin Peter
    Amberley Lambridge Wood Road
    RG9 3BS Henley On Thames
    Oxfordshire
    Administrateur
    Amberley Lambridge Wood Road
    RG9 3BS Henley On Thames
    Oxfordshire
    EnglandBritish55180460001

    Qui sont les personnes ayant un contrôle significatif sur BATES MOTORS (BELCHER) LIMITED ?

    Personnes ayant un contrôle significatif
    NomNotifié leAdresseCessé
    Inchcape Transition Limited
    Solihull Parkway
    Birmingham Business Park
    B37 7YN Birmingham
    First Floor, Unit 3140, Park Square
    United Kingdom
    06 avr. 2016
    Solihull Parkway
    Birmingham Business Park
    B37 7YN Birmingham
    First Floor, Unit 3140, Park Square
    United Kingdom
    Non
    Forme juridiqueLimited By Shares
    Pays d'enregistrementEngland And Wales
    Autorité légaleUnited Kingdom (England)
    Lieu d'enregistrementUnited Kingdom (England) Companies House
    Numéro d'enregistrement4053624
    Nature du contrôle
    • La personne détient, directement ou indirectement, plus de 75 % des actions de la société.
    • La personne détient, directement ou indirectement, plus de 75 % des droits de vote dans la société.
    • La personne détient, directement ou indirectement, le droit de nommer ou de révoquer une majorité des membres du conseil d'administration de la société.

    BATES MOTORS (BELCHER) LIMITED a-t-elle des charges ?

    Charges
    ClassificationDatesStatutDétails
    Legal charge
    Créé le 29 févr. 1996
    Livré le 11 mars 1996
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    289/299 kennington lane l/b of lambeth t/nos.SGL279332 and TGL25526.
    Personnes ayant droit
    • Barclays Bank PLC
    Transactions
    • 11 mars 1996Enregistrement d'une charge (395)
    • 10 oct. 2001Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Debenture
    Créé le 05 avr. 1995
    Livré le 11 avr. 1995
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee
    Brèves mentions
    All those monies which may from time to time be owing to bates motors (belcher) limited by bmw (GB) limited in respect of refunds of monies paid by or by the direction of bates motors (belcher) limited to bmw (GB) limited by way of deposit on the acquisition of motor vehicles on a consignment basis.
    Personnes ayant droit
    • Bmw Finance (GB) Limited
    Transactions
    • 11 avr. 1995Enregistrement d'une charge (395)
    • 13 mars 2008Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Legal charge
    Créé le 11 oct. 1993
    Livré le 20 oct. 1993
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Land/premises at hilltop garage,colchester road,harold wood,l/b of havering.t/no.egl 140863.
    Personnes ayant droit
    • Barclays Bank PLC
    Transactions
    • 20 oct. 1993Enregistrement d'une charge (395)
    • 27 juil. 2001Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Legal charge
    Créé le 11 oct. 1993
    Livré le 20 oct. 1993
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Land/premises at hilltop garage,colchester road,harold wood,l/b of havering.t/no.ngl 75623.
    Personnes ayant droit
    • Barclays Bank PLC
    Transactions
    • 20 oct. 1993Enregistrement d'une charge (395)
    • 27 juil. 2001Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Legal charge
    Créé le 22 oct. 1990
    Livré le 08 nov. 1990
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Filling station situate at harcog motor centre maldon road, witham, essex.
    Personnes ayant droit
    • Barclays Bank PLC
    Transactions
    • 08 nov. 1990Enregistrement d'une charge
    • 31 août 2001Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Legal charge
    Créé le 06 août 1990
    Livré le 14 août 1990
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Land situated in spital road, maldon essex, having a frontage thereto of 166 feet.
    Personnes ayant droit
    • Barclays Bank PLC
    Transactions
    • 14 août 1990Enregistrement d'une charge
    • 10 oct. 2001Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Legal charge
    Créé le 06 août 1990
    Livré le 14 août 1990
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Land situated in danbury having a frontage to the main road from chelmsford to danbury of approx. 33 feet. Essex.
    Personnes ayant droit
    • Barclays Bank PLC
    Transactions
    • 14 août 1990Enregistrement d'une charge
    • 10 oct. 2001Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Legal charge
    Créé le 06 août 1990
    Livré le 14 août 1990
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Land situate in danbury having a frontage to the main road from maldon to danbury k/a ashdown service station essex.
    Personnes ayant droit
    • Barclays Bank PLC
    Transactions
    • 14 août 1990Enregistrement d'une charge
    • 27 juil. 2001Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Debenture
    Créé le 05 juil. 1990
    Livré le 20 juil. 1990
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personnes ayant droit
    • Barclays Bank PLC
    Transactions
    • 20 juil. 1990Enregistrement d'une charge
    • 14 nov. 2002Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Legal charge
    Créé le 06 déc. 1988
    Livré le 22 déc. 1988
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Land situate in danbury having a frontage to the main road from chelmsford to danbury of approx 33 feet, essex.
    Personnes ayant droit
    • Barclays Bank PLC
    Transactions
    • 22 déc. 1988Enregistrement d'une charge
    • 27 juil. 2001Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Legal charge
    Créé le 06 déc. 1988
    Livré le 22 déc. 1988
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Land situate in danbury having a frontage to the main road from maldon to danbury, essex k/as ashdown service station.
    Personnes ayant droit
    • Barclays Bank PLC
    Transactions
    • 22 déc. 1988Enregistrement d'une charge
    • 27 juil. 2001Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Legal charge
    Créé le 22 juin 1984
    Livré le 03 juil. 1984
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    F/H ashdown service station, danbury, essex.
    Personnes ayant droit
    • Barclays Bank PLC
    Transactions
    • 03 juil. 1984Enregistrement d'une charge
    • 27 juil. 2001Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Legal charge
    Créé le 22 juin 1984
    Livré le 03 juil. 1984
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Piece or parcel of f/h land, danbury, essex, frontage to the main road leading from chelmsford to danbury approx. 33 feet.
    Personnes ayant droit
    • Barclays Bank PLC
    Transactions
    • 03 juil. 1984Enregistrement d'une charge
    • 27 juil. 2001Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Legal charge
    Créé le 29 mars 1983
    Livré le 08 avr. 1983
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    F/H land situated in spital road maldon, essex having a frontage thereto of 166 feet.
    Personnes ayant droit
    • Barclays Bank PLC
    Transactions
    • 08 avr. 1983Enregistrement d'une charge
    • 27 juil. 2001Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Legal charge
    Créé le 13 oct. 1981
    Livré le 22 oct. 1981
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    F/H spital road, maldon, essex having a frontage of 166 feet.
    Personnes ayant droit
    • Barclays Bank PLC
    Transactions
    • 22 oct. 1981Enregistrement d'une charge
    Legal charge
    Créé le 24 mai 1972
    Livré le 30 mai 1972
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Land to rear of bates motors showrooms, spital road, maldon.
    Personnes ayant droit
    • Barclays Bank PLC
    Transactions
    • 30 mai 1972Enregistrement d'une charge
    • 27 juil. 2001Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)

    Source de données

    • Companies House du Royaume-Uni
      Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers.
    • Licence: CC0