BATES MOTORS (BELCHER) LIMITED
Vue d'ensemble
| Nom de la société | BATES MOTORS (BELCHER) LIMITED |
|---|---|
| Statut de la société | Dissoute |
| Forme juridique | Société à responsabilité limitée |
| Numéro de société | 00107744 |
| Juridiction | Angleterre/Pays de Galles |
| Date de création | |
| Date de cessation d'activité |
Résumé
| A des PSCs super sécurisés | Non |
|---|---|
| A des charges | Oui |
| A un historique d'insolvabilité | Non |
| Le siège social est contesté | Non |
Où se situe BATES MOTORS (BELCHER) LIMITED ?
| Adresse du siège social | First Floor Unit 3140 Park Square Solihull Parkway Birmingham Business Park B37 7YN Birmingham |
|---|---|
| Adresse du siège social non livrable | Non |
Quels sont les derniers comptes de BATES MOTORS (BELCHER) LIMITED ?
| Derniers comptes | |
|---|---|
| Derniers comptes arrêtés au | 31 déc. 2019 |
Quels sont les derniers dépôts pour BATES MOTORS (BELCHER) LIMITED ?
| Date | Description | Document | Type | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bulletin officiel final dissous par radiation volontaire | 1 pages | GAZ2(A) | ||||||||||
Premier avis au Bulletin officiel pour la radiation volontaire | 1 pages | GAZ1(A) | ||||||||||
Demande de radiation de la société du registre du commerce | 2 pages | DS01 | ||||||||||
Déclaration de confirmation établie le 31 janv. 2021 sans mise à jour | 3 pages | CS01 | ||||||||||
Comptes pour une société dormante établis au 31 déc. 2019 | 5 pages | AA | ||||||||||
Nomination de Miss Farheen Ahmad en tant qu'administrateur le 14 févr. 2020 | 2 pages | AP01 | ||||||||||
Déclaration de confirmation établie le 31 janv. 2020 sans mise à jour | 3 pages | CS01 | ||||||||||
Cessation de la nomination de Thomas Andrew Dale en tant que directeur le 29 janv. 2020 | 1 pages | TM01 | ||||||||||
Comptes pour une société dormante établis au 31 déc. 2018 | 5 pages | AA | ||||||||||
Nomination de Mr Thomas Andrew Dale en tant qu'administrateur le 04 juil. 2019 | 2 pages | AP01 | ||||||||||
Cessation de la nomination de Anton Clive Jeary en tant que directeur le 04 juil. 2019 | 1 pages | TM01 | ||||||||||
Déclaration de confirmation établie le 31 janv. 2019 sans mise à jour | 3 pages | CS01 | ||||||||||
Comptes pour une société dormante établis au 31 déc. 2017 | 5 pages | AA | ||||||||||
Modification des détails de Inchcape Transition Limited en tant que personne disposant d'un contrôle significatif le 01 avr. 2018 | 5 pages | PSC05 | ||||||||||
Modification des coordonnées du secrétaire Inchcape Uk Corporate Management Limited le 01 avr. 2018 | 3 pages | CH04 | ||||||||||
Changement d'adresse du siège social de Inchcape House Langford Lane Kidlington Oxford OX5 1HT à First Floor Unit 3140 Park Square Solihull Parkway Birmingham Business Park Birmingham B37 7YN le 09 avr. 2018 | 2 pages | AD01 | ||||||||||
Déclaration de confirmation établie le 31 janv. 2018 sans mise à jour | 3 pages | CS01 | ||||||||||
Comptes pour une société dormante établis au 31 déc. 2016 | 5 pages | AA | ||||||||||
Déclaration de confirmation établie le 31 janv. 2017 avec mises à jour | 5 pages | CS01 | ||||||||||
Comptes pour une société dormante établis au 31 déc. 2015 | 5 pages | AA | ||||||||||
Déclaration annuelle jusqu'au 31 janv. 2016 avec liste complète des actionnaires | 4 pages | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Comptes pour une société dormante établis au 31 déc. 2014 | 5 pages | AA | ||||||||||
Déclaration annuelle jusqu'au 31 janv. 2015 avec liste complète des actionnaires | 4 pages | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Comptes pour une société dormante établis au 31 déc. 2013 | 5 pages | AA | ||||||||||
Déclaration annuelle jusqu'au 31 janv. 2014 avec liste complète des actionnaires | 4 pages | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Qui sont les dirigeants de BATES MOTORS (BELCHER) LIMITED ?
| Nom | Nommé le | Date de démission | Rôle | Adresse | Identification de la société | Pays de résidence | Nationalité | Date de naissance | Profession | Numéro | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INCHCAPE UK CORPORATE MANAGEMENT LIMITED | Secrétaire | Park Square Solihull Parkway Birmingham Business Park B37 7YN Birmingham First Floor Unit 3140 United Kingdom |
| 100307260071 | ||||||||||
| AHMAD, Farheen | Administrateur | Solihull Parkway Birmingham Business Park B37 7YN Birmingham First Floor Unit 3140 Park Square | England | British | 266847010001 | |||||||||
| INCHCAPE CORPORATE SERVICES LIMITED | Administrateur | St James's Square SW1Y 5LP London 22a England |
| 79689420001 | ||||||||||
| GATHERCOLE, Paul Trevor | Secrétaire | 64 Marlowe Way CO3 4JP Colchester Essex | British | 91445650001 | ||||||||||
| JEARY, Anton Clive | Secrétaire | 105a St Peters Road West Lynn PE34 3JR Kings Lynn Norfolk | British | 92285800001 | ||||||||||
| NEWMAN, Robin Alfred | Secrétaire | Acorn Cottage The Ridge Little Baddow CM3 4RT Chelmsford Essex | British | 6138000001 | ||||||||||
| WHEATLEY, Martin Peter | Secrétaire | Amberley Lambridge Wood Road RG9 3BS Henley On Thames Oxfordshire | British | 55180460001 | ||||||||||
| BELCHER, Edward Stephen Argent | Administrateur | Ulting Hall Ulting CM9 6QR Maldon Essex | British | 28491690001 | ||||||||||
| BELCHER, Hilary Angela Argent | Administrateur | Ulting Hall Eastae Ulting CM9 6QR Maldon Essex | British | 36358000001 | ||||||||||
| BELCHER, Vera Mary | Administrateur | Highlands Highlands Drive CM9 6HX Maldon Essex | British | 6138020001 | ||||||||||
| BOULT, Richard David | Administrateur | 22 Geneva Road KT1 2TW Kingston Upon Thames Surrey | England | British | 57391140001 | |||||||||
| DALE, Thomas Andrew | Administrateur | Solihull Parkway Birmingham Business Park B37 7YN Birmingham First Floor Unit 3140 Park Square | United Kingdom | British | 260286850001 | |||||||||
| FRANKLIN, Christopher Tom | Administrateur | Woodway Barn Woodway Road Sibford Ferris OX15 5DA Banbury Oxfordshire | British | 70288830001 | ||||||||||
| HAZELWOOD, Robert | Administrateur | Wistaria House 14 Ethorpe Close SL9 8PL Gerrards Cross Buckinghamshire | British | 70288980002 | ||||||||||
| JEARY, Anton Clive | Administrateur | Solihull Parkway Birmingham Business Park B37 7YN Birmingham First Floor Unit 3140 Park Square | England | British | 169892630001 | |||||||||
| MCCORMACK, Connor | Administrateur | New College House Alchester Road OX26 1UN Chesterton Oxfordshire | United Kingdom | British | 108832810002 | |||||||||
| NEWMAN, Robin Alfred | Administrateur | Acorn Cottage The Ridge Little Baddow CM3 4RT Chelmsford Essex | British | 6138000001 | ||||||||||
| RABAN, Mark Douglas | Administrateur | 18 Orchard Lane MK43 7BP Harrold Bedfordshire | United Kingdom | British | 261262130001 | |||||||||
| SKELTON, Robert John | Administrateur | 233 Plumberow Avenue SS5 5NZ Hockley Essex | England | British | 8028550001 | |||||||||
| VICKERS, David York | Administrateur | Little Bell Hill Bakers Lane CM3 4NS Danbury Essex | British | 76394030001 | ||||||||||
| WALLWORK, Paul Anthony Hewitt | Administrateur | Baytree Cottage Church Road Lyndon LE15 8TU Oakham Rutland | British | 113014520001 | ||||||||||
| WALTER, Kevin Raymond | Administrateur | Little Hill Farm Mope Lane CM8 3JP Wickham Bishops Essex | England | British | 91445840002 | |||||||||
| WHEATLEY, Martin Peter | Administrateur | Amberley Lambridge Wood Road RG9 3BS Henley On Thames Oxfordshire | England | British | 55180460001 |
Qui sont les personnes ayant un contrôle significatif sur BATES MOTORS (BELCHER) LIMITED ?
| Nom | Notifié le | Adresse | Cessé | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Inchcape Transition Limited | 06 avr. 2016 | Solihull Parkway Birmingham Business Park B37 7YN Birmingham First Floor, Unit 3140, Park Square United Kingdom | Non | ||||||||||
| |||||||||||||
Nature du contrôle
| |||||||||||||
BATES MOTORS (BELCHER) LIMITED a-t-elle des charges ?
| Classification | Dates | Statut | Détails | |
|---|---|---|---|---|
| Legal charge | Créé le 29 févr. 1996 Livré le 11 mars 1996 | Totalement satisfaite | Montant garanti All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brèves mentions 289/299 kennington lane l/b of lambeth t/nos.SGL279332 and TGL25526. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
| Debenture | Créé le 05 avr. 1995 Livré le 11 avr. 1995 | Totalement satisfaite | Montant garanti All monies due or to become due from the company to the chargee | |
Brèves mentions All those monies which may from time to time be owing to bates motors (belcher) limited by bmw (GB) limited in respect of refunds of monies paid by or by the direction of bates motors (belcher) limited to bmw (GB) limited by way of deposit on the acquisition of motor vehicles on a consignment basis. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
| Legal charge | Créé le 11 oct. 1993 Livré le 20 oct. 1993 | Totalement satisfaite | Montant garanti All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brèves mentions Land/premises at hilltop garage,colchester road,harold wood,l/b of havering.t/no.egl 140863. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
| Legal charge | Créé le 11 oct. 1993 Livré le 20 oct. 1993 | Totalement satisfaite | Montant garanti All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brèves mentions Land/premises at hilltop garage,colchester road,harold wood,l/b of havering.t/no.ngl 75623. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
| Legal charge | Créé le 22 oct. 1990 Livré le 08 nov. 1990 | Totalement satisfaite | Montant garanti All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brèves mentions Filling station situate at harcog motor centre maldon road, witham, essex. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
| Legal charge | Créé le 06 août 1990 Livré le 14 août 1990 | Totalement satisfaite | Montant garanti All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brèves mentions Land situated in spital road, maldon essex, having a frontage thereto of 166 feet. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
| Legal charge | Créé le 06 août 1990 Livré le 14 août 1990 | Totalement satisfaite | Montant garanti All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brèves mentions Land situated in danbury having a frontage to the main road from chelmsford to danbury of approx. 33 feet. Essex. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
| Legal charge | Créé le 06 août 1990 Livré le 14 août 1990 | Totalement satisfaite | Montant garanti All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brèves mentions Land situate in danbury having a frontage to the main road from maldon to danbury k/a ashdown service station essex. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
| Debenture | Créé le 05 juil. 1990 Livré le 20 juil. 1990 | Totalement satisfaite | Montant garanti All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brèves mentions Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
| Legal charge | Créé le 06 déc. 1988 Livré le 22 déc. 1988 | Totalement satisfaite | Montant garanti All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brèves mentions Land situate in danbury having a frontage to the main road from chelmsford to danbury of approx 33 feet, essex. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
| Legal charge | Créé le 06 déc. 1988 Livré le 22 déc. 1988 | Totalement satisfaite | Montant garanti All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brèves mentions Land situate in danbury having a frontage to the main road from maldon to danbury, essex k/as ashdown service station. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
| Legal charge | Créé le 22 juin 1984 Livré le 03 juil. 1984 | Totalement satisfaite | Montant garanti All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brèves mentions F/H ashdown service station, danbury, essex. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
| Legal charge | Créé le 22 juin 1984 Livré le 03 juil. 1984 | Totalement satisfaite | Montant garanti All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brèves mentions Piece or parcel of f/h land, danbury, essex, frontage to the main road leading from chelmsford to danbury approx. 33 feet. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
| Legal charge | Créé le 29 mars 1983 Livré le 08 avr. 1983 | Totalement satisfaite | Montant garanti All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brèves mentions F/H land situated in spital road maldon, essex having a frontage thereto of 166 feet. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
| Legal charge | Créé le 13 oct. 1981 Livré le 22 oct. 1981 | Totalement satisfaite | Montant garanti All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brèves mentions F/H spital road, maldon, essex having a frontage of 166 feet. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
| Legal charge | Créé le 24 mai 1972 Livré le 30 mai 1972 | Totalement satisfaite | Montant garanti All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brèves mentions Land to rear of bates motors showrooms, spital road, maldon. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
Source de données
- Companies House du Royaume-Uni
Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers. - Licence: CC0