BISICHI PLC

  • Vue d'ensemble
  • Résumé
  • Objet social
  • Adresse
  • Dénominations sociales précédentes
  • Comptes
  • Déclaration de confirmation
  • Dépôts
  • Dirigeants
  • Charges
  • Source de données
  • Vue d'ensemble

    Nom de la sociétéBISICHI PLC
    Statut de la sociétéActive
    Forme juridiqueSociété anonyme cotée en bourse
    Numéro de société 00112155
    JuridictionAngleterre/Pays de Galles
    Date de création

    Résumé

    A des PSCs super sécurisésNon
    A des chargesOui
    A un historique d'insolvabilitéNon
    Le siège social est contestéNon

    Quel est l'objet de BISICHI PLC ?

    • Autres activités extractives n.c.a. (08990) / Exploitation de mines et carrières
    • Location et exploitation de biens immobiliers des sociétés de logement (68201) / Activités immobilières

    Où se situe BISICHI PLC ?

    Adresse du siège social
    12 Little Portland Street
    2nd Floor
    W1W 8BJ London
    England
    Adresse du siège social non livrableNon

    Quels étaient les noms précédents de BISICHI PLC ?

    Dénominations sociales précédentes
    Nom de la sociétéDeJusqu'au
    BISICHI MINING PUBLIC LIMITED COMPANY04 juil. 198804 juil. 1988
    BISICHI TIN COMPANY PUBLIC LIMITED COMPANY13 oct. 191013 oct. 1910

    Quels sont les derniers comptes de BISICHI PLC ?

    En retardNon
    Prochains comptes
    Fin de la prochaine période comptable le31 déc. 2024
    Date d'échéance des prochains comptes30 juin 2025
    Derniers comptes
    Derniers comptes arrêtés au31 déc. 2023

    Quel est le statut de la dernière déclaration de confirmation pour BISICHI PLC ?

    Dernière déclaration de confirmation établie jusqu'au15 juin 2025
    Date d'échéance de la prochaine déclaration de confirmation29 juin 2025
    Dernière déclaration de confirmation
    Prochaine déclaration de confirmation établie jusqu'au15 juin 2024
    En retardNon

    Quels sont les derniers dépôts pour BISICHI PLC ?

    Dépôts
    DateDescriptionDocumentType

    Nomination de Mr Stephen Crabb en tant qu'administrateur le 01 nov. 2024

    2 pagesAP01

    Cessation de la nomination de John Alexander Sibbald en tant que directeur le 03 oct. 2024

    1 pagesTM01

    Nomination de Mr Clement Robin Woodbine Parish en tant qu'administrateur le 01 juil. 2024

    2 pagesAP01

    Comptes consolidés établis au 31 déc. 2023

    115 pagesAA

    Résolutions

    Resolutions
    2 pagesRESOLUTIONS
    Résolutions
    CatégorieDateDescriptionType
    capital

    Résolution d'attribution de valeurs mobilières

    RES10

    Déclaration de confirmation établie le 15 juin 2024 sans mise à jour

    3 pagesCS01

    Cessation de la nomination de Christopher Andrew Joll en tant que directeur le 18 avr. 2024

    1 pagesTM01

    Résolutions

    Resolutions
    1 pagesRESOLUTIONS
    Résolutions
    CatégorieDateDescriptionType
    capital

    Résolution d'attribution de valeurs mobilières

    RES10

    Comptes consolidés établis au 31 déc. 2022

    115 pagesAA

    Déclaration de confirmation établie le 15 juin 2023 sans mise à jour

    3 pagesCS01

    Nomination de Mr John Alexander Heller en tant qu'administrateur le 29 mars 2023

    2 pagesAP01

    Cessation de la nomination de Michael Aron Heller en tant que directeur le 30 janv. 2023

    1 pagesTM01

    Résolutions

    Resolutions
    2 pagesRESOLUTIONS
    Résolutions
    CatégorieDateDescriptionType
    capital

    Résolution d'attribution de valeurs mobilières

    RES10

    Comptes consolidés établis au 31 déc. 2021

    102 pagesAA

    Déclaration de confirmation établie le 15 juin 2022 sans mise à jour

    3 pagesCS01

    Changement d'adresse du siège social de 24 Bruton Place London W1J 6NE à 12 Little Portland Street 2nd Floor London W1W 8BJ le 05 nov. 2021

    1 pagesAD01

    Démission de l'auditeur

    2 pagesAUD

    Comptes consolidés établis au 31 déc. 2020

    99 pagesAA

    Résolutions

    Resolutions
    2 pagesRESOLUTIONS
    Résolutions
    CatégorieDateDescriptionType
    capital

    Résolution d'attribution de valeurs mobilières

    RES10

    Déclaration de confirmation établie le 15 juin 2021 sans mise à jour

    3 pagesCS01

    L'adresse d'inspection du registre a été modifiée de Northern House Woodsome Park Fenay Bridge Huddersfield West Yorkshire HD8 0LA à 10th Floor Central Square 29 Wellington Street Leeds LS1 4DL

    1 pagesAD02

    Nomination de Mr John Chan Wai Wong en tant qu'administrateur le 15 oct. 2020

    2 pagesAP01

    Comptes consolidés établis au 31 déc. 2019

    100 pagesAA

    Résolutions

    Resolutions
    2 pagesRESOLUTIONS
    Résolutions
    CatégorieDateDescriptionType
    capital

    Résolution d'attribution de valeurs mobilières

    RES10

    Déclaration de confirmation établie le 15 juin 2020 sans mise à jour

    3 pagesCS01

    Qui sont les dirigeants de BISICHI PLC ?

    Dirigeants
    NomNommé leDate de démissionRôleAdresseIdentification de la sociétéPays de résidenceNationalitéDate de naissanceProfessionNuméro
    CASEY, Garrett John
    Little Portland Street
    2nd Floor
    W1W 8BJ London
    12
    England
    Secrétaire
    Little Portland Street
    2nd Floor
    W1W 8BJ London
    12
    England
    194058970001
    CASEY, Garrett John
    Little Portland Street
    2nd Floor
    W1W 8BJ London
    12
    England
    Administrateur
    Little Portland Street
    2nd Floor
    W1W 8BJ London
    12
    England
    United KingdomIrishNone194059630004
    CRABB, Stephen
    Little Portland Street
    2nd Floor
    W1W 8BJ London
    12
    England
    Administrateur
    Little Portland Street
    2nd Floor
    W1W 8BJ London
    12
    England
    United KingdomBritishDirector132032360001
    GROBLER, Robert John
    18 Lava Street
    Benfleur
    Witbank
    Mpumalanga
    South Africa
    Administrateur
    18 Lava Street
    Benfleur
    Witbank
    Mpumalanga
    South Africa
    South AfricaSouth AfricanCoal Mining130079430001
    HELLER, Andrew Robert
    Little Portland Street
    2nd Floor
    W1W 8BJ London
    12
    England
    Administrateur
    Little Portland Street
    2nd Floor
    W1W 8BJ London
    12
    England
    United KingdomBritishInvestment Mining62899960002
    HELLER, John Alexander
    Little Portland Street
    2nd Floor
    W1W 8BJ London
    12
    England
    Administrateur
    Little Portland Street
    2nd Floor
    W1W 8BJ London
    12
    England
    United KingdomBritishCompany Director72581650001
    PARISH, Clement Robin Woodbine
    Little Portland Street
    2nd Floor
    W1W 8BJ London
    12
    England
    Administrateur
    Little Portland Street
    2nd Floor
    W1W 8BJ London
    12
    England
    United KingdomBritishDirector324625150001
    WONG, John Chan Wai
    Little Portland Street
    2nd Floor
    W1W 8BJ London
    12
    England
    Administrateur
    Little Portland Street
    2nd Floor
    W1W 8BJ London
    12
    England
    EnglandBritishNon-Executive Director70555260001
    CURTIS, Heather Anne
    Bruton Place
    W1J 6NE London
    24
    United Kingdom
    Secrétaire
    Bruton Place
    W1J 6NE London
    24
    United Kingdom
    British159673330001
    STEVENS, Michael Cecil
    31 Wallace Fields
    Ewell
    KT17 3AX Epsom
    Surrey
    Secrétaire
    31 Wallace Fields
    Ewell
    KT17 3AX Epsom
    Surrey
    British14672850001
    BROWN, Louis Charles John
    Annes Orchard Crawley Down Road
    Felbridge
    RH19 2PP East Grinstead
    West Sussex
    Administrateur
    Annes Orchard Crawley Down Road
    Felbridge
    RH19 2PP East Grinstead
    West Sussex
    BritishDirector/Chartered Accountant14998540001
    DENT-YOUNG, David Michael
    Cloisters Cottage Perrymead
    BA2 5AY Bath
    Avon
    Administrateur
    Cloisters Cottage Perrymead
    BA2 5AY Bath
    Avon
    BritishMining Engineer15483950001
    HELLER, Michael Aron, Sir
    Little Portland Street
    2nd Floor
    W1W 8BJ London
    12
    England
    Administrateur
    Little Portland Street
    2nd Floor
    W1W 8BJ London
    12
    England
    United KingdomBritishCompany Chairman/Chartered Accountant44677700001
    JOLL, Christopher Andrew
    Little Portland Street
    2nd Floor
    W1W 8BJ London
    12
    England
    Administrateur
    Little Portland Street
    2nd Floor
    W1W 8BJ London
    12
    England
    United KingdomBritishCompany Director85565430004
    KEARNEY, Thomas Myer
    56 Flask Walk
    NW3 1HE London
    Administrateur
    56 Flask Walk
    NW3 1HE London
    United KingdomIrishManager53835770002
    MACKILLIGIN, Robert Guy Walter
    Walnut Tree Cottage Woodlands 5 Pembury Road
    TN2 3QY Tunbridge Wells
    Kent
    Administrateur
    Walnut Tree Cottage Woodlands 5 Pembury Road
    TN2 3QY Tunbridge Wells
    Kent
    BritishMining Engineer15691050001
    PARISH, Michael Woodbine
    Walcot Hall
    SY7 8AZ Lydbury North
    Shropshire
    Administrateur
    Walcot Hall
    SY7 8AZ Lydbury North
    Shropshire
    BritishCompany Director13931190001
    SIBBALD, John Alexander
    1 Shrewsbury Court
    EC1Y 8JE London
    Administrateur
    1 Shrewsbury Court
    EC1Y 8JE London
    United KingdomBritishRetired Chartered Accountant15483940001

    BISICHI PLC a-t-elle des charges ?

    Charges
    ClassificationDatesStatutDétails
    A registered charge
    Créé le 26 juin 2015
    Livré le 01 juil. 2015
    Totalement satisfaite
    Contient une promesse négative: Oui
    Contient une charge fixe: Oui
    Personnes ayant droit
    • Santander UK PLC as Security Trustee for Each Group Member
    Transactions
    • 01 juil. 2015Enregistrement d'une charge (MR01)
    • 16 déc. 2019Satisfaction d'une charge (MR04)
    A registered charge
    Créé le 23 déc. 2014
    Livré le 09 janv. 2015
    Totalement satisfaite
    Contient une promesse négative: Oui
    Contient une charge fixe: Oui
    Personnes ayant droit
    • Santander UK PLC as Security Trustee for Each Group Member
    Transactions
    • 09 janv. 2015Enregistrement d'une charge (MR01)
    • 16 déc. 2019Satisfaction d'une charge (MR04)
    Security interest agreement
    Créé le 24 juin 2011
    Livré le 06 juil. 2011
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the secured party on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    A continuing, first priority security interest in the collateral, see image for full details.
    Personnes ayant droit
    • Abbey National Treasury Services PLC (The Secured Party)
    Transactions
    • 06 juil. 2011Enregistrement d'une charge (MG01)
    • 16 déc. 2019Satisfaction d'une charge (MR04)
    Charge of deposit
    Créé le 11 juin 2010
    Livré le 16 juin 2010
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    All deposits now and in the future credited to account designation nxnfpsgp-ZAR01 with the bank and any deposit or account of any other description or designation which derives in whole or in part from such deposits or account.
    Personnes ayant droit
    • National Westminster Bank PLC
    Transactions
    • 16 juin 2010Enregistrement d'une charge (MG01)
    • 15 janv. 2015Satisfaction d'une charge (MR04)
    Deed of charge over credit balances
    Créé le 13 nov. 2006
    Livré le 21 nov. 2006
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Barclays bank PLC re bisichi mining public limited company current account, account number 20812927. the charge creates a fixed charge over all the deposit(s) referred to in the schedule to the form 395 (including all or any part of the money payable pursuant to such deposit(s) and the debts represented thereby) together with all interest from time to time accruing thereon it also creates an assignment by the chargor for the purposes of and to give effect to the security over the right of the chargor to require repayment of such deposit(s) and interest thereon.
    Personnes ayant droit
    • Barclays Bank PLC
    Transactions
    • 21 nov. 2006Enregistrement d'une charge (395)
    • 08 nov. 2014Satisfaction d'une charge (MR04)
    Charge of agreement
    Créé le 06 nov. 2002
    Livré le 25 nov. 2002
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    The agreement and all the mortgagor's interest in the property present and future subject to re-assignment on redemption, by way of fixed charge all plant machinery and fixtures and fittings, all the furniture furnishings equipment tools and other chattels the proceeds of any insurance. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • National Westminster Bank PLC
    Transactions
    • 25 nov. 2002Enregistrement d'une charge (395)
    • 15 janv. 2015Satisfaction d'une charge (MR04)
    Legal charge
    Créé le 06 nov. 2002
    Livré le 25 nov. 2002
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Fountain arcade 224 and 225 market place and 64 tower street brierly hill dudley. By way of fixed charge the benefit of all covenants and rights concerning the property and plant machinery fixtures fittings furniture equipment implements and utensils the goodwill of any business carried on at the property and the proceeds of any insurance affecting the property or assets.
    Personnes ayant droit
    • National Westminster Bank PLC
    Transactions
    • 25 nov. 2002Enregistrement d'une charge (395)
    • 15 janv. 2015Satisfaction d'une charge (MR04)
    Charge of securities (UK)
    Créé le 06 nov. 2002
    Livré le 25 nov. 2002
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    All the issued share capital of urban first northampton limited and all income derived from the securities and all rights attaching to the securities. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • National Westminster Bank PLC
    Transactions
    • 25 nov. 2002Enregistrement d'une charge (395)
    • 15 janv. 2015Satisfaction d'une charge (MR04)
    Legal mortgage
    Créé le 27 juin 2000
    Livré le 30 juin 2000
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    L/Hold property known as 16/28 parker lane,35-49 croft street 1 boot way,12 red lion st,burnley,lancashire; LA837023. And the proceeds of sale thereof floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment and an assignment of the goodwill and connection of any business together with the full benefit of all licences.
    Personnes ayant droit
    • National Westminster Bank PLC
    Transactions
    • 30 juin 2000Enregistrement d'une charge (395)
    • 15 janv. 2015Satisfaction d'une charge (MR04)
    Legal mortgage
    Créé le 27 juin 2000
    Livré le 30 juin 2000
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    222/223 high street dudley west midlands; WM331755. And the proceeds of sale thereof floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment and an assignment of the goodwill and connection of any business together with the full benefit of all licences.
    Personnes ayant droit
    • National Westminster Bank PLC
    Transactions
    • 30 juin 2000Enregistrement d'une charge (395)
    • 15 janv. 2015Satisfaction d'une charge (MR04)
    Legal mortgage
    Créé le 11 oct. 1995
    Livré le 16 oct. 1995
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    The f/h property k/a 188-216 bawtry road wickersley rotherham south yorkshire t/n SYK313028 and the proceeds of sale thereof. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment and an assignment of the goodwill and connection of any business together with the full benefit of all licences.
    Personnes ayant droit
    • National Westminster Bank PLC
    Transactions
    • 16 oct. 1995Enregistrement d'une charge (395)
    • 15 janv. 2015Satisfaction d'une charge (MR04)
    Legal mortgage
    Créé le 29 août 1989
    Livré le 08 sept. 1989
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Ritz site bradford, west yorkshire title no wyk 158345 and or the proceeds of sale thereof. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Personnes ayant droit
    • National Westminster Bank PLC
    Transactions
    • 08 sept. 1989Enregistrement d'une charge
    • 15 oct. 2007Déclaration que tout ou partie de la propriété d'une charge flottante a été libérée (403b)
    • 15 janv. 2015Satisfaction d'une charge (MR04)

    Source de données

    • Companies House du Royaume-Uni
      Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers.
    • Licence: CC0