BISICHI PLC
Vue d'ensemble
Nom de la société | BISICHI PLC |
---|---|
Statut de la société | Active |
Forme juridique | Société anonyme cotée en bourse |
Numéro de société | 00112155 |
Juridiction | Angleterre/Pays de Galles |
Date de création |
Résumé
A des PSCs super sécurisés | Non |
---|---|
A des charges | Oui |
A un historique d'insolvabilité | Non |
Le siège social est contesté | Non |
Où se situe BISICHI PLC ?
Adresse du siège social | 12 Little Portland Street 2nd Floor W1W 8BJ London England |
---|---|
Adresse du siège social non livrable | Non |
Quels sont les derniers comptes de BISICHI PLC ?
En retard | Non |
---|---|
Prochains comptes | |
Fin de la prochaine période comptable le | 31 déc. 2024 |
Date d'échéance des prochains comptes | 30 juin 2025 |
Derniers comptes | |
Derniers comptes arrêtés au | 31 déc. 2023 |
Quel est le statut de la dernière déclaration de confirmation pour BISICHI PLC ?
Dernière déclaration de confirmation établie jusqu'au | 15 juin 2025 |
---|---|
Date d'échéance de la prochaine déclaration de confirmation | 29 juin 2025 |
Dernière déclaration de confirmation | |
Prochaine déclaration de confirmation établie jusqu'au | 15 juin 2024 |
En retard | Non |
Quels sont les derniers dépôts pour BISICHI PLC ?
Date | Description | Document | Type | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nomination de Mr Stephen Crabb en tant qu'administrateur le 01 nov. 2024 | 2 pages | AP01 | ||||||||||
Cessation de la nomination de John Alexander Sibbald en tant que directeur le 03 oct. 2024 | 1 pages | TM01 | ||||||||||
Nomination de Mr Clement Robin Woodbine Parish en tant qu'administrateur le 01 juil. 2024 | 2 pages | AP01 | ||||||||||
Comptes consolidés établis au 31 déc. 2023 | 115 pages | AA | ||||||||||
Résolutions Resolutions | 2 pages | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
Déclaration de confirmation établie le 15 juin 2024 sans mise à jour | 3 pages | CS01 | ||||||||||
Cessation de la nomination de Christopher Andrew Joll en tant que directeur le 18 avr. 2024 | 1 pages | TM01 | ||||||||||
Résolutions Resolutions | 1 pages | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
Comptes consolidés établis au 31 déc. 2022 | 115 pages | AA | ||||||||||
Déclaration de confirmation établie le 15 juin 2023 sans mise à jour | 3 pages | CS01 | ||||||||||
Nomination de Mr John Alexander Heller en tant qu'administrateur le 29 mars 2023 | 2 pages | AP01 | ||||||||||
Cessation de la nomination de Michael Aron Heller en tant que directeur le 30 janv. 2023 | 1 pages | TM01 | ||||||||||
Résolutions Resolutions | 2 pages | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
Comptes consolidés établis au 31 déc. 2021 | 102 pages | AA | ||||||||||
Déclaration de confirmation établie le 15 juin 2022 sans mise à jour | 3 pages | CS01 | ||||||||||
Changement d'adresse du siège social de 24 Bruton Place London W1J 6NE à 12 Little Portland Street 2nd Floor London W1W 8BJ le 05 nov. 2021 | 1 pages | AD01 | ||||||||||
Démission de l'auditeur | 2 pages | AUD | ||||||||||
Comptes consolidés établis au 31 déc. 2020 | 99 pages | AA | ||||||||||
Résolutions Resolutions | 2 pages | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
Déclaration de confirmation établie le 15 juin 2021 sans mise à jour | 3 pages | CS01 | ||||||||||
L'adresse d'inspection du registre a été modifiée de Northern House Woodsome Park Fenay Bridge Huddersfield West Yorkshire HD8 0LA à 10th Floor Central Square 29 Wellington Street Leeds LS1 4DL | 1 pages | AD02 | ||||||||||
Nomination de Mr John Chan Wai Wong en tant qu'administrateur le 15 oct. 2020 | 2 pages | AP01 | ||||||||||
Comptes consolidés établis au 31 déc. 2019 | 100 pages | AA | ||||||||||
Résolutions Resolutions | 2 pages | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
Déclaration de confirmation établie le 15 juin 2020 sans mise à jour | 3 pages | CS01 | ||||||||||
Qui sont les dirigeants de BISICHI PLC ?
Nom | Nommé le | Date de démission | Rôle | Adresse | Identification de la société | Pays de résidence | Nationalité | Date de naissance | Profession | Numéro |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CASEY, Garrett John | Secrétaire | Little Portland Street 2nd Floor W1W 8BJ London 12 England | 194058970001 | |||||||
CASEY, Garrett John | Administrateur | Little Portland Street 2nd Floor W1W 8BJ London 12 England | United Kingdom | Irish | None | 194059630004 | ||||
CRABB, Stephen | Administrateur | Little Portland Street 2nd Floor W1W 8BJ London 12 England | United Kingdom | British | Director | 132032360001 | ||||
GROBLER, Robert John | Administrateur | 18 Lava Street Benfleur Witbank Mpumalanga South Africa | South Africa | South African | Coal Mining | 130079430001 | ||||
HELLER, Andrew Robert | Administrateur | Little Portland Street 2nd Floor W1W 8BJ London 12 England | United Kingdom | British | Investment Mining | 62899960002 | ||||
HELLER, John Alexander | Administrateur | Little Portland Street 2nd Floor W1W 8BJ London 12 England | United Kingdom | British | Company Director | 72581650001 | ||||
PARISH, Clement Robin Woodbine | Administrateur | Little Portland Street 2nd Floor W1W 8BJ London 12 England | United Kingdom | British | Director | 324625150001 | ||||
WONG, John Chan Wai | Administrateur | Little Portland Street 2nd Floor W1W 8BJ London 12 England | England | British | Non-Executive Director | 70555260001 | ||||
CURTIS, Heather Anne | Secrétaire | Bruton Place W1J 6NE London 24 United Kingdom | British | 159673330001 | ||||||
STEVENS, Michael Cecil | Secrétaire | 31 Wallace Fields Ewell KT17 3AX Epsom Surrey | British | 14672850001 | ||||||
BROWN, Louis Charles John | Administrateur | Annes Orchard Crawley Down Road Felbridge RH19 2PP East Grinstead West Sussex | British | Director/Chartered Accountant | 14998540001 | |||||
DENT-YOUNG, David Michael | Administrateur | Cloisters Cottage Perrymead BA2 5AY Bath Avon | British | Mining Engineer | 15483950001 | |||||
HELLER, Michael Aron, Sir | Administrateur | Little Portland Street 2nd Floor W1W 8BJ London 12 England | United Kingdom | British | Company Chairman/Chartered Accountant | 44677700001 | ||||
JOLL, Christopher Andrew | Administrateur | Little Portland Street 2nd Floor W1W 8BJ London 12 England | United Kingdom | British | Company Director | 85565430004 | ||||
KEARNEY, Thomas Myer | Administrateur | 56 Flask Walk NW3 1HE London | United Kingdom | Irish | Manager | 53835770002 | ||||
MACKILLIGIN, Robert Guy Walter | Administrateur | Walnut Tree Cottage Woodlands 5 Pembury Road TN2 3QY Tunbridge Wells Kent | British | Mining Engineer | 15691050001 | |||||
PARISH, Michael Woodbine | Administrateur | Walcot Hall SY7 8AZ Lydbury North Shropshire | British | Company Director | 13931190001 | |||||
SIBBALD, John Alexander | Administrateur | 1 Shrewsbury Court EC1Y 8JE London | United Kingdom | British | Retired Chartered Accountant | 15483940001 |
BISICHI PLC a-t-elle des charges ?
Classification | Dates | Statut | Détails | |
---|---|---|---|---|
A registered charge | Créé le 26 juin 2015 Livré le 01 juil. 2015 | Totalement satisfaite | ||
Contient une promesse négative: Oui Contient une charge fixe: Oui | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
A registered charge | Créé le 23 déc. 2014 Livré le 09 janv. 2015 | Totalement satisfaite | ||
Contient une promesse négative: Oui Contient une charge fixe: Oui | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
Security interest agreement | Créé le 24 juin 2011 Livré le 06 juil. 2011 | Totalement satisfaite | Montant garanti All monies due or to become due from the company to the secured party on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Brèves mentions A continuing, first priority security interest in the collateral, see image for full details. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
Charge of deposit | Créé le 11 juin 2010 Livré le 16 juin 2010 | Totalement satisfaite | Montant garanti All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brèves mentions All deposits now and in the future credited to account designation nxnfpsgp-ZAR01 with the bank and any deposit or account of any other description or designation which derives in whole or in part from such deposits or account. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
Deed of charge over credit balances | Créé le 13 nov. 2006 Livré le 21 nov. 2006 | Totalement satisfaite | Montant garanti All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brèves mentions Barclays bank PLC re bisichi mining public limited company current account, account number 20812927. the charge creates a fixed charge over all the deposit(s) referred to in the schedule to the form 395 (including all or any part of the money payable pursuant to such deposit(s) and the debts represented thereby) together with all interest from time to time accruing thereon it also creates an assignment by the chargor for the purposes of and to give effect to the security over the right of the chargor to require repayment of such deposit(s) and interest thereon. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
Charge of agreement | Créé le 06 nov. 2002 Livré le 25 nov. 2002 | Totalement satisfaite | Montant garanti All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brèves mentions The agreement and all the mortgagor's interest in the property present and future subject to re-assignment on redemption, by way of fixed charge all plant machinery and fixtures and fittings, all the furniture furnishings equipment tools and other chattels the proceeds of any insurance. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
Legal charge | Créé le 06 nov. 2002 Livré le 25 nov. 2002 | Totalement satisfaite | Montant garanti All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brèves mentions Fountain arcade 224 and 225 market place and 64 tower street brierly hill dudley. By way of fixed charge the benefit of all covenants and rights concerning the property and plant machinery fixtures fittings furniture equipment implements and utensils the goodwill of any business carried on at the property and the proceeds of any insurance affecting the property or assets. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
Charge of securities (UK) | Créé le 06 nov. 2002 Livré le 25 nov. 2002 | Totalement satisfaite | Montant garanti All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brèves mentions All the issued share capital of urban first northampton limited and all income derived from the securities and all rights attaching to the securities. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
Legal mortgage | Créé le 27 juin 2000 Livré le 30 juin 2000 | Totalement satisfaite | Montant garanti All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brèves mentions L/Hold property known as 16/28 parker lane,35-49 croft street 1 boot way,12 red lion st,burnley,lancashire; LA837023. And the proceeds of sale thereof floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment and an assignment of the goodwill and connection of any business together with the full benefit of all licences. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
Legal mortgage | Créé le 27 juin 2000 Livré le 30 juin 2000 | Totalement satisfaite | Montant garanti All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brèves mentions 222/223 high street dudley west midlands; WM331755. And the proceeds of sale thereof floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment and an assignment of the goodwill and connection of any business together with the full benefit of all licences. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
Legal mortgage | Créé le 11 oct. 1995 Livré le 16 oct. 1995 | Totalement satisfaite | Montant garanti All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brèves mentions The f/h property k/a 188-216 bawtry road wickersley rotherham south yorkshire t/n SYK313028 and the proceeds of sale thereof. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment and an assignment of the goodwill and connection of any business together with the full benefit of all licences. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
Legal mortgage | Créé le 29 août 1989 Livré le 08 sept. 1989 | Totalement satisfaite | Montant garanti All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brèves mentions Ritz site bradford, west yorkshire title no wyk 158345 and or the proceeds of sale thereof. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
|
Source de données
- Companies House du Royaume-Uni
Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers. - Licence: CC0