LIZARD AND DISTRICT HYGIENIC STEAM LAUNDRY COMPANY,LIMITED(THE)

LIZARD AND DISTRICT HYGIENIC STEAM LAUNDRY COMPANY,LIMITED(THE)

  • Vue d'ensemble
  • Résumé
  • Objet social
  • Adresse
  • Comptes
  • Dépôts
  • Dirigeants
  • Charges
  • Source de données
  • Vue d'ensemble

    Nom de la sociétéLIZARD AND DISTRICT HYGIENIC STEAM LAUNDRY COMPANY,LIMITED(THE)
    Statut de la sociétéDissoute
    Forme juridiqueSociété à responsabilité limitée
    Numéro de société 00120774
    JuridictionAngleterre/Pays de Galles
    Date de création
    Date de cessation d'activité

    Résumé

    A des PSCs super sécurisésNon
    A des chargesOui
    A un historique d'insolvabilitéNon
    Le siège social est contestéNon

    Quel est l'objet de LIZARD AND DISTRICT HYGIENIC STEAM LAUNDRY COMPANY,LIMITED(THE) ?

    • Société non marchande non marchande (74990) / Activités spécialisées, scientifiques et techniques

    Où se situe LIZARD AND DISTRICT HYGIENIC STEAM LAUNDRY COMPANY,LIMITED(THE) ?

    Adresse du siège social
    4 Grosvenor Place
    London
    SW1X 7DL
    Adresse du siège social non livrableNon

    Quels sont les derniers comptes de LIZARD AND DISTRICT HYGIENIC STEAM LAUNDRY COMPANY,LIMITED(THE) ?

    En retardOui
    Prochains comptes
    Fin de la prochaine période comptable le31 déc. 2016
    Date d'échéance des prochains comptes30 sept. 2017
    Derniers comptes
    Derniers comptes arrêtés au31 déc. 2015

    Quels sont les derniers dépôts pour LIZARD AND DISTRICT HYGIENIC STEAM LAUNDRY COMPANY,LIMITED(THE) ?

    Dépôts
    DateDescriptionDocumentType

    Bulletin officiel final dissous par radiation volontaire

    1 pagesGAZ2(A)

    Premier avis au Bulletin officiel pour la radiation volontaire

    1 pagesGAZ1(A)

    Résolutions

    Resolutions
    1 pagesRESOLUTIONS
    Résolutions
    CatégorieDateDescriptionType
    capital

    Résolutions

    Company business 17/02/2017
    RES13

    Demande de radiation de la société du registre du commerce

    3 pagesDS01

    Nomination de Mr Mark South en tant qu'administrateur le 23 déc. 2016

    2 pagesAP01

    Cessation de la nomination de Nigel James Hiorns en tant que secrétaire le 22 déc. 2016

    1 pagesTM02

    Cessation de la nomination de Steven Richard Finch en tant que directeur le 22 déc. 2016

    1 pagesTM01

    Nomination de Mr David Andrew Lawler en tant que secrétaire le 22 déc. 2016

    2 pagesAP03

    Comptes pour une société dormante établis au 31 déc. 2015

    3 pagesAA

    Déclaration annuelle jusqu'au 20 juin 2016 avec liste complète des actionnaires

    6 pagesAR01
    Dépôts associés
    CatégorieDateDescriptionType
    capital28 juin 2016

    État du capital au 28 juin 2016

    • Capital: GBP 1
    SH01

    Les registres ont été transférés à l'adresse du siège social enregistré 4 Grosvenor Place London SW1X 7DL

    1 pagesAD04

    Comptes pour une société dormante établis au 31 déc. 2014

    3 pagesAA

    Déclaration annuelle jusqu'au 20 juin 2015 avec liste complète des actionnaires

    6 pagesAR01
    Dépôts associés
    CatégorieDateDescriptionType
    capital16 juil. 2015

    État du capital au 16 juil. 2015

    • Capital: GBP 1
    SH01

    Cessation de la nomination de Denis Michael Embleton en tant que directeur le 27 févr. 2015

    1 pagesTM01

    Modification des coordonnées de l'administrateur Kevin Quinn le 17 nov. 2014

    2 pagesCH01

    Comptes pour une société dormante établis au 31 déc. 2013

    4 pagesAA

    Déclaration annuelle jusqu'au 20 juin 2014 avec liste complète des actionnaires

    7 pagesAR01
    Dépôts associés
    CatégorieDateDescriptionType
    capital15 juil. 2014

    État du capital au 15 juil. 2014

    • Capital: GBP 1
    SH01

    Déclaration annuelle jusqu'au 20 juin 2013 avec liste complète des actionnaires

    7 pagesAR01
    Dépôts associés
    CatégorieDateDescriptionType
    capital16 juil. 2013

    État du capital après une attribution d'actions au 16 juil. 2013

    SH01

    Comptes annuels établis au 31 déc. 2012

    11 pagesAA

    legacy

    1 pagesSH20

    État du capital au 12 nov. 2012

    • Capital: GBP 1.00
    4 pagesSH19

    legacy

    1 pagesCAP-SS

    Résolutions

    Resolutions
    1 pagesRESOLUTIONS
    Résolutions
    CatégorieDateDescriptionType
    capital

    Résolution de réduction du capital social émis

    RES06

    Comptes pour une société dormante établis au 31 déc. 2011

    4 pagesAA

    Déclaration annuelle jusqu'au 20 juin 2012 avec liste complète des actionnaires

    7 pagesAR01

    Qui sont les dirigeants de LIZARD AND DISTRICT HYGIENIC STEAM LAUNDRY COMPANY,LIMITED(THE) ?

    Dirigeants
    NomNommé leDate de démissionRôleAdresseIdentification de la sociétéPays de résidenceNationalitéDate de naissanceProfessionNuméro
    LAWLER, David Andrew
    4 Grosvenor Place
    London
    SW1X 7DL
    Secrétaire
    4 Grosvenor Place
    London
    SW1X 7DL
    221227530001
    QUINN, Kevin
    4 Grosvenor Place
    London
    SW1X 7DL
    Administrateur
    4 Grosvenor Place
    London
    SW1X 7DL
    EnglandBritishDirector89902020003
    SOUTH, Mark
    4 Grosvenor Place
    London
    SW1X 7DL
    Administrateur
    4 Grosvenor Place
    London
    SW1X 7DL
    United KingdomBritishDirector221291190001
    HIORNS, Nigel James
    62 Church Road
    CR0 1SB Croydon
    Surrey
    Secrétaire
    62 Church Road
    CR0 1SB Croydon
    Surrey
    British11524610002
    VOSPER, Iain Andrew
    26 Gweal Pawl
    TR15 3DN Redruth
    Cornwall
    Secrétaire
    26 Gweal Pawl
    TR15 3DN Redruth
    Cornwall
    BritishHead Of Finance102782980002
    WOOD, Samuel Lewis
    Brook House
    Skyburriowe Mill Garras
    TR12 6LP Helston
    Cornwall
    Secrétaire
    Brook House
    Skyburriowe Mill Garras
    TR12 6LP Helston
    Cornwall
    British11519720001
    EMBLETON, Denis Michael
    9 Leydene Park
    Hyden Farm Lane East Meon
    GU32 1HF Petersfield
    Hampshire
    Administrateur
    9 Leydene Park
    Hyden Farm Lane East Meon
    GU32 1HF Petersfield
    Hampshire
    EnglandBritishDirector12722390003
    FINCH, Steven Richard
    2 Regency Court
    Langley Road
    WD17 4RG Watford
    Hertfordshire
    Administrateur
    2 Regency Court
    Langley Road
    WD17 4RG Watford
    Hertfordshire
    United KingdomBritishDirector38003430003
    ROWE, Benjamin Gerald
    Woodlands
    Cot Road Illogan
    TR16 4PS Redruth
    Cornwall
    Administrateur
    Woodlands
    Cot Road Illogan
    TR16 4PS Redruth
    Cornwall
    BritishDirector11519740001
    ROWE, Colin Stuart
    Trevarrack
    West Trewirgie Road
    TR15 2TJ Redruth
    Cornwall
    Administrateur
    Trevarrack
    West Trewirgie Road
    TR15 2TJ Redruth
    Cornwall
    EnglandBritishDirector89869750001
    ROWE, Richard Alexander
    1 Ashwick Court
    Broadhempston
    TQ9 6BD Totnes
    Devon
    Administrateur
    1 Ashwick Court
    Broadhempston
    TQ9 6BD Totnes
    Devon
    BritishDirector11519730003

    LIZARD AND DISTRICT HYGIENIC STEAM LAUNDRY COMPANY,LIMITED(THE) a-t-elle des charges ?

    Charges
    ClassificationDatesStatutDétails
    Mortgage
    Créé le 15 mars 2005
    Livré le 17 mars 2005
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    The f/h property k/a or being the laundry premises the praze, penryn, cornwall t/no CL176781. Together with all buildings and fixtures (including trade fixtures) fixed plant and machinery by way of fixed charge all present and future book and other debts floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment by way of assignment the goodwill of the business (if any) the full benefit of all licences and all guarantees.
    Personnes ayant droit
    • Lloyds Tsb Bank PLC
    Transactions
    • 17 mars 2005Enregistrement d'une charge (395)
    • 27 janv. 2006Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Debenture
    Créé le 15 mars 2005
    Livré le 17 mars 2005
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Lloyds Tsb Bank PLC
    Transactions
    • 17 mars 2005Enregistrement d'une charge (395)
    • 27 janv. 2006Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Omnibus guarantee and set-off agreement
    Créé le 15 mars 2005
    Livré le 17 mars 2005
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Any sum standing to the credit of any one or more of any present or future accounts of the companies or any of them with the bank (including any accounts held in the bank's name with any designation which includes the name(s) of the companies or any of them) whether such accounts be denominated in sterling or in a currency or currencies other than sterling.
    Personnes ayant droit
    • Lloyds Tsb Bank PLC
    Transactions
    • 17 mars 2005Enregistrement d'une charge (395)
    • 27 janv. 2006Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Legal mortgage
    Créé le 16 août 2001
    Livré le 22 août 2001
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    The freehold property known as the laundry the praze penryn cornwall. With the benefit of all rights licences guarantees rent deposits contracts deeds undertakings and warranties relating. To the property any shares or membership rights in any management company for the property any goodwill of any business from time to time carried on at the property any rental and other money payable under any lease licence or other interest created in respect of the property and all other payments whatever in respect of the property.
    Personnes ayant droit
    • Hsbc Bank PLC
    Transactions
    • 22 août 2001Enregistrement d'une charge (395)
    • 02 avr. 2005Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Debenture
    Créé le 16 août 2001
    Livré le 22 août 2001
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personnes ayant droit
    • Hsbc Bank PLC
    Transactions
    • 22 août 2001Enregistrement d'une charge (395)
    • 02 avr. 2005Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Debenture
    Créé le 30 oct. 1989
    Livré le 20 nov. 1989
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personnes ayant droit
    • Barclays Bank PLC
    Transactions
    • 20 nov. 1989Enregistrement d'une charge
    • 22 févr. 2002Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Legal charge
    Créé le 13 juin 1967
    Livré le 27 juin 1967
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All moneys due etc
    Brèves mentions
    Falmouth model laundry and premises, penryn, as comprised in a conveyance dated 31/3/67.
    Personnes ayant droit
    • Barclays Bank PLC
    Transactions
    • 27 juin 1967Enregistrement d'une charge
    • 22 févr. 2002Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Legal charge
    Créé le 17 mars 1967
    Livré le 29 mars 1967
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All moneys due etc
    Brèves mentions
    Falmouth and district laundry, prase, penryn.
    Personnes ayant droit
    • Barclays Bank PLC
    Transactions
    • 29 mars 1967Enregistrement d'une charge
    • 22 févr. 2002Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Debenture
    Créé le 22 juin 1962
    Livré le 09 juil. 1962
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All money's due etc.
    Brèves mentions
    Undertaking and goodwill all property present and future including uncalled capital. (For full details see doc 87).
    Personnes ayant droit
    • Barclays Bank PLC
    Transactions
    • 09 juil. 1962Enregistrement d'une charge
    • 22 févr. 2002Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)

    Source de données

    • Companies House du Royaume-Uni
      Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers.
    • Licence: CC0