DISC DISTRIBUTION LIMITED

  • Vue d'ensemble
  • Résumé
  • Objet social
  • Adresse
  • Dénominations sociales précédentes
  • Comptes
  • Déclaration de confirmation
  • Bilan annuel
  • Dépôts
  • Dirigeants
  • Charges
  • Insolvabilité
  • Source de données
  • Vue d'ensemble

    Nom de la sociétéDISC DISTRIBUTION LIMITED
    Statut de la sociétéLiquidation
    Forme juridiqueSociété à responsabilité limitée
    Numéro de société 00125787
    JuridictionAngleterre/Pays de Galles
    Date de création
    Date de cessation d'activité

    Résumé

    A des PSCs super sécurisésNon
    A des chargesOui
    A un historique d'insolvabilitéOui
    Le siège social est contestéNon

    Quel est l'objet de DISC DISTRIBUTION LIMITED ?

    • (6312) /
    • (7415) /

    Où se situe DISC DISTRIBUTION LIMITED ?

    Adresse du siège social
    242 Marylebone Road
    London
    NW1 6JL
    Adresse du siège social non livrableNon

    Quels étaient les noms précédents de DISC DISTRIBUTION LIMITED ?

    Dénominations sociales précédentes
    Nom de la sociétéDeJusqu'au
    VCI UK LIMITED25 juin 199625 juin 1996
    STRAND VCI UK LIMITED29 oct. 198429 oct. 1984
    PRESTWICH PARKER HOLDINGS P.L.C.31 déc. 198131 déc. 1981
    PRESTWICH PARKER LIMITED07 déc. 191207 déc. 1912

    Quels sont les derniers comptes de DISC DISTRIBUTION LIMITED ?

    En retardOui
    Prochains comptes
    Fin de la prochaine période comptable le31 janv. 2012
    Date d'échéance des prochains comptes31 oct. 2012
    Derniers comptes
    Derniers comptes arrêtés au31 janv. 2011

    Quel est le statut de la dernière déclaration de confirmation pour DISC DISTRIBUTION LIMITED ?

    En retardOui
    Dernière déclaration de confirmation établie jusqu'au28 déc. 2016
    Date d'échéance de la prochaine déclaration de confirmation11 janv. 2017
    En retardOui

    Quel est le statut du dernier bilan annuel pour DISC DISTRIBUTION LIMITED ?

    Bilan annuel
    Dernier bilan annuel
    En retardOui

    Quels sont les derniers dépôts pour DISC DISTRIBUTION LIMITED ?

    Dépôts
    DateDescriptionDocumentType

    Restauration par ordonnance du tribunal

    3 pagesAC92

    Gazette finale dissoute à la suite d'une liquidation

    1 pagesGAZ2

    Achèvement de la liquidation

    1 pagesL64.07

    Ordonnance du tribunal pour liquider

    2 pagesCOCOMP

    Comptes annuels établis au 31 janv. 2011

    13 pagesAA

    Déclaration annuelle jusqu'au 28 déc. 2010 avec liste complète des actionnaires

    14 pagesAR01
    Dépôts associés
    CatégorieDateDescriptionType
    capital21 mars 2011

    État du capital au 21 mars 2011

    • Capital: GBP 9,167,313.5
    SH01

    Comptes annuels établis au 31 janv. 2010

    14 pagesAA

    Comptes annuels établis au 31 janv. 2009

    14 pagesAA

    Déclaration annuelle jusqu'au 28 déc. 2009 avec liste complète des actionnaires

    14 pagesAR01

    La procédure de radiation d'office a été suspendue

    1 pagesDISS16(SOAS)

    Premier avis au Bulletin officiel pour la radiation d'office

    1 pagesGAZ1

    legacy

    1 pages288b

    legacy

    3 pages363a

    legacy

    1 pages288b

    legacy

    3 pages288a

    legacy

    1 pages288c

    Comptes annuels établis au 02 févr. 2008

    14 pagesAA

    legacy

    7 pages363s
    Dépôts associés
    CatégorieDateDescriptionType
    annual-return18 juin 2008

    legacy

    363(353)

    legacy

    15 pages395

    Résolutions

    Resolutions
    2 pagesRESOLUTIONS
    Résolutions
    CatégorieDateDescriptionType
    capital

    Résolutions

    Facility agree 29/01/08
    RES13

    legacy

    1 pages287

    Comptes annuels établis au 03 févr. 2007

    14 pagesAA

    legacy

    1 pages288b

    legacy

    1 pages288a

    legacy

    7 pages363s

    Qui sont les dirigeants de DISC DISTRIBUTION LIMITED ?

    Dirigeants
    NomNommé leDate de démissionRôleAdresseIdentification de la sociétéPays de résidenceNationalitéDate de naissanceProfessionNuméro
    EAST, Stephen John
    White Ladies
    Birch Hill Shirley Hills
    CR0 5HT Surrey
    Administrateur
    White Ladies
    Birch Hill Shirley Hills
    CR0 5HT Surrey
    EnglandBritish108586450001
    BISH JONES, Trevor Charles
    Salford Manor
    Wavendon Road, Salford
    MK17 8BB Milton Keynes
    Secrétaire
    Salford Manor
    Wavendon Road, Salford
    MK17 8BB Milton Keynes
    British89529490001
    BLOOM, Jonathan Simon
    8 Wavel Mews
    South Hampstead
    NW6 3AB London
    Secrétaire
    8 Wavel Mews
    South Hampstead
    NW6 3AB London
    British78140960001
    CHASTON, David Carl Anthony
    67 Darlands Drive
    EN5 2DE Barnet
    Hertfordshire
    Secrétaire
    67 Darlands Drive
    EN5 2DE Barnet
    Hertfordshire
    British55677580003
    HARVEY, George Kenneth
    22 Hillcroft Avenue
    HA5 5AW Pinner
    Middlesex
    Secrétaire
    22 Hillcroft Avenue
    HA5 5AW Pinner
    Middlesex
    British17771640001
    PRAILL, Penelope
    5 Trout Hollow Bledlow Road
    Saunderton
    HP27 9UA Princes Risborough
    Buckinghamshire
    Secrétaire
    5 Trout Hollow Bledlow Road
    Saunderton
    HP27 9UA Princes Risborough
    Buckinghamshire
    British57322940001
    SCHOFIELD, Brian Beaumont
    Badgers Bigfrith Lane
    Cookham
    SL6 9UQ Maidenhead
    Berkshire
    Secrétaire
    Badgers Bigfrith Lane
    Cookham
    SL6 9UQ Maidenhead
    Berkshire
    British47050440001
    SCOTT, Christopher David
    Copenhagen Street
    N1 0JD London
    2b
    Secrétaire
    Copenhagen Street
    N1 0JD London
    2b
    British118895720002
    SWENY, Susan
    36 Halifax Street
    Sydenham
    SE26 6JA London
    Secrétaire
    36 Halifax Street
    Sydenham
    SE26 6JA London
    British85387430001
    AYRES, Stephen Thomas
    Charringworth Grange
    GL55 6XY Chipping Campden
    Gloucestershire
    Administrateur
    Charringworth Grange
    GL55 6XY Chipping Campden
    Gloucestershire
    United KingdomBritish66870470001
    BAYLISS, Colin Charles Macarthur
    2038 Channelford Road
    CA 91361 Westlake Village
    California
    Administrateur
    2038 Channelford Road
    CA 91361 Westlake Village
    California
    British68243990002
    BISH JONES, Trevor Charles
    Salford Manor
    Wavendon Road, Salford
    MK17 8BB Milton Keynes
    Administrateur
    Salford Manor
    Wavendon Road, Salford
    MK17 8BB Milton Keynes
    United KingdomBritish89529490001
    BROOMAN, Richard John
    27 Rivermead Court
    Marlow Bridge Lane
    SL7 1SJ Marlow
    Buckinghamshire
    Administrateur
    27 Rivermead Court
    Marlow Bridge Lane
    SL7 1SJ Marlow
    Buckinghamshire
    United KingdomBritish11328600001
    BURGESS, Mark Geoffrey William
    5 The Ridgway
    Mount Ararat Road
    TW10 6PR Richmond
    Surrey
    Administrateur
    5 The Ridgway
    Mount Ararat Road
    TW10 6PR Richmond
    Surrey
    British28476620002
    CLARKE, Roger Grenville Quinton
    Whitebeam
    Wainhill
    OX39 4AB Chinnor
    Oxfordshire
    Administrateur
    Whitebeam
    Wainhill
    OX39 4AB Chinnor
    Oxfordshire
    British63850730001
    DUNLEAVY, Ivan Patrick
    Bois Heath Farm
    Watchet Lane Little Kingshill
    HP16 0DR Great Missenden
    Buckinghamshire
    Administrateur
    Bois Heath Farm
    Watchet Lane Little Kingshill
    HP16 0DR Great Missenden
    Buckinghamshire
    British17771660002
    GREEN, Richard John
    Aston House
    12a Stratton Road
    HP9 1HR Beaconsfield
    Buckinghamshire
    Administrateur
    Aston House
    12a Stratton Road
    HP9 1HR Beaconsfield
    Buckinghamshire
    EnglandEnglish41785690003
    HANKS, Terence James
    Holcombe
    Crown Lane
    SL2 3SF Farnham Royal
    Bucks
    Administrateur
    Holcombe
    Crown Lane
    SL2 3SF Farnham Royal
    Bucks
    British21917480001
    HARVEY, George Kenneth
    22 Hillcroft Avenue
    HA5 5AW Pinner
    Middlesex
    Administrateur
    22 Hillcroft Avenue
    HA5 5AW Pinner
    Middlesex
    British17771640001
    HEMBURY, Paul Brian
    St Margarets House
    St Margarets
    HP1 3BZ Great Gaddesden
    Hertfordshire
    Administrateur
    St Margarets House
    St Margarets
    HP1 3BZ Great Gaddesden
    Hertfordshire
    EnglandBritish34925020002
    HYNDMAN, Ruth Jennifer
    15 Cedars Road
    SW13 0HP London
    Administrateur
    15 Cedars Road
    SW13 0HP London
    British34562530002
    OGILVIE, Alasdair Mcdonald
    11 Gibsons Road
    SK4 4JX Stockport
    Cheshire
    Administrateur
    11 Gibsons Road
    SK4 4JX Stockport
    Cheshire
    EnglandBritish67412910001
    ROBERTS, David Benjamin
    Thatched Cottage
    Rake Lane Milford
    GU8 5AB Godalming
    Surrey
    Administrateur
    Thatched Cottage
    Rake Lane Milford
    GU8 5AB Godalming
    Surrey
    EnglandBritish49657510003
    ROGERS, Christopher Charles Bevan
    Mill House
    Turville
    RG9 6QL Henley On Thames
    Oxfordshire
    Administrateur
    Mill House
    Turville
    RG9 6QL Henley On Thames
    Oxfordshire
    United KingdomBritish34678510004
    SANKEY, Brian William
    21 Parkland Avenue
    RM14 2HA Upminster
    Essex
    Administrateur
    21 Parkland Avenue
    RM14 2HA Upminster
    Essex
    British17771680001
    SCHOLFIELD, Brian Beaumont
    Badgers Bigfrith Lane
    SL6 9UQ Cookham Dean
    Berkshire
    Administrateur
    Badgers Bigfrith Lane
    SL6 9UQ Cookham Dean
    Berkshire
    British55318250001
    SCOTT, Christopher David
    Copenhagen Street
    N1 0JD London
    2b
    Administrateur
    Copenhagen Street
    N1 0JD London
    2b
    British118895720002
    TOOMEY, Thomas Patrick
    23 Hillrise
    SL9 9BN Chalfont St Peter
    Buckinghamshire
    Administrateur
    23 Hillrise
    SL9 9BN Chalfont St Peter
    Buckinghamshire
    British114191860001
    WILLITS, Giles Kirkley
    11 Buckingham Street
    WC2N 6DF London
    Administrateur
    11 Buckingham Street
    WC2N 6DF London
    United KingdomBritish123734120001

    DISC DISTRIBUTION LIMITED a-t-elle des charges ?

    Charges
    ClassificationDatesStatutDétails
    Debenture
    Créé le 30 janv. 2008
    Livré le 08 févr. 2008
    En cours
    Montant garanti
    Under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge all sums due or to become due
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Gmac Commercial Finance PLC as Trustee for the Secured Creditors
    Transactions
    • 08 févr. 2008Enregistrement d'une charge (395)
    Rent deposit deed
    Créé le 01 sept. 2000
    Livré le 07 sept. 2000
    En cours
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee under a lease of even date and the rent deposit deed
    Brèves mentions
    The deposit sum is £24,510 or such funds as may from time to time stand to the credit of the account.
    Personnes ayant droit
    • Derwent Valley Property Developments Limited
    Transactions
    • 07 sept. 2000Enregistrement d'une charge (395)
    Rent deposit deed
    Créé le 09 févr. 2000
    Livré le 14 févr. 2000
    En cours
    Montant garanti
    The performance of the company's (the tenant) obligations to the chargee in a lease of even date and this deed
    Brèves mentions
    A separate interest bearing designated business premium account in the name of the chargee's managing agents,pilcher hershman re: disc distribution limited rent deposit account containing £139,188 or such funds as may from time to time stand to the credit of the account.
    Personnes ayant droit
    • Derwent Valley Property Developments Limited
    Transactions
    • 14 févr. 2000Enregistrement d'une charge (395)
    Deed of variation supplemental to debenture of even date
    Créé le 30 juil. 1998
    Livré le 12 août 1998
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the original debenture
    Brèves mentions
    Floating charge such of the company's property as shall from time to time be subject to legal charges in favour of the chargee but not otherwise. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Nationwide Building Society
    Transactions
    • 12 août 1998Enregistrement d'une charge (395)
    • 11 oct. 2000Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Legal charge
    Créé le 30 juil. 1998
    Livré le 04 août 1998
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee
    Brèves mentions
    The f/h property k/a 76 dean street city of westminster t/n NGL129044. Together with all buildings fixtures (including trade fixtures) fixed plant and machinery thereon the goodwill of any business carried on at the property the benefit of any licences and registrations required in the running of such business.
    Personnes ayant droit
    • Nationwide Building Society
    Transactions
    • 04 août 1998Enregistrement d'une charge (395)
    • 11 oct. 2000Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Debenture
    Créé le 30 juil. 1998
    Livré le 04 août 1998
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Nationwide Building Society
    Transactions
    • 04 août 1998Enregistrement d'une charge (395)
    • 11 oct. 2000Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Composite debenture
    Créé le 28 juil. 1998
    Livré le 11 août 1998
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever under each finance document (as defined)
    Brèves mentions
    L/Hold land/blds known as 1 watford business park,caxton way,watford,hertfordshire,barnet; t/no hd 264019 and unit 12,brunswick park estate,brunswick park rd,new southgate,barnet; ngl 385108; see form 395. fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personnes ayant droit
    • Paribas,as Agent and Trustee for the Finance Parties (As Defined)
    Transactions
    • 11 août 1998Enregistrement d'une charge (395)
    • 09 avr. 1999Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Composite debenture
    Créé le 04 oct. 1995
    Livré le 05 oct. 1995
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company and/or all or any other companies named therein to the chargee under the terms of each finance document to which each obligor is a party except for any obligation which, if it were so included, would result in the debenture contravening section 151 of the companies act 1985
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Samuel Montagu & Co.Limited
    Transactions
    • 05 oct. 1995Enregistrement d'une charge (395)
    • 09 avr. 1999Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Debenture
    Créé le 09 juin 1994
    Livré le 20 juin 1994
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due friom the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee under the terms of the facility agreement and this deed both dated 9TH june 1994
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • National Westminster Bank PLC
    Transactions
    • 20 juin 1994Enregistrement d'une charge (395)
    • 15 nov. 1995Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Debenture
    Créé le 26 avr. 1990
    Livré le 26 avr. 1990
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee as agent and turstee for the beneficianies (s defined) under the terms of a guarantee of even date.
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personnes ayant droit
    • National Westminster Bank PLC
    Transactions
    • 26 avr. 1990Enregistrement d'une charge
    • 21 juin 1995Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Guarantee debenture
    Créé le 27 févr. 1989
    Livré le 06 mars 1989
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personnes ayant droit
    • Barclays Bank PLC
    Transactions
    • 06 mars 1989Enregistrement d'une charge
    Debenture
    Créé le 22 févr. 1989
    Livré le 28 févr. 1989
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personnes ayant droit
    • The Royal Bank of Scotland
    Transactions
    • 28 févr. 1989Enregistrement d'une charge
    Debenture
    Créé le 11 oct. 1982
    Livré le 27 oct. 1982
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Fixed & floating charg on the undertaking and all property and assets present and future including goodwill & book debts uncalled capitl.. Together with fixed and moveable plant machinery fixtures implements and utensils.
    Personnes ayant droit
    • Williams & Glyn's Bank PLC
    Transactions
    • 27 oct. 1982Enregistrement d'une charge

    DISC DISTRIBUTION LIMITED a-t-elle des procédures d'insolvabilité ?

    Numéro de dossierDatesTypePraticiensAutre
    1
    DateType
    07 déc. 2011Petition date
    05 mars 2014Conclusion of winding up
    06 févr. 2012Commencement of winding up
    11 juin 2014Dissolved on
    Compulsory liquidation
    NomRôleAdresseNommé leCessé le
    The Official Receiver Or London
    21 Bloomsbury Street
    London
    WC1B 3SS
    practitioner
    21 Bloomsbury Street
    London
    WC1B 3SS

    Source de données

    • Companies House du Royaume-Uni
      Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers.
    • Licence: CC0