LEIGH ESTATES (U.K.) LIMITED

LEIGH ESTATES (U.K.) LIMITED

  • Vue d'ensemble
  • Résumé
  • Objet social
  • Adresse
  • Dénominations sociales précédentes
  • Comptes
  • Dépôts
  • Dirigeants
  • Charges
  • Insolvabilité
  • Source de données
  • Vue d'ensemble

    Nom de la sociétéLEIGH ESTATES (U.K.) LIMITED
    Statut de la sociétéDissoute
    Forme juridiqueSociété à responsabilité limitée
    Numéro de société 00127181
    JuridictionAngleterre/Pays de Galles
    Date de création
    Date de cessation d'activité

    Résumé

    A des PSCs super sécurisésNon
    A des chargesOui
    A un historique d'insolvabilitéOui
    Le siège social est contestéNon

    Quel est l'objet de LEIGH ESTATES (U.K.) LIMITED ?

    • (7011) /

    Où se situe LEIGH ESTATES (U.K.) LIMITED ?

    Adresse du siège social
    PO BOX 695
    8 Salisbury Square
    EC4Y 8BB London
    Adresse du siège social non livrableNon

    Quels étaient les noms précédents de LEIGH ESTATES (U.K.) LIMITED ?

    Dénominations sociales précédentes
    Nom de la sociétéDeJusqu'au
    HERBERT CRABTREE & BRIGGS LIMITED14 févr. 191314 févr. 1913

    Quels sont les derniers comptes de LEIGH ESTATES (U.K.) LIMITED ?

    Derniers comptes
    Derniers comptes arrêtés au

    Quels sont les derniers dépôts pour LEIGH ESTATES (U.K.) LIMITED ?

    Dépôts
    DateDescriptionDocumentType

    Déclaration de biens vacants

    1 pagesBONA

    Déclaration de biens vacants

    1 pagesBONA

    Bulletin officiel final dissous par radiation d'office

    1 pagesGAZ2

    Premier avis au Bulletin officiel pour la radiation d'office

    1 pagesGAZ1

    legacy

    2 pagesLQ02

    legacy

    2 pagesLQ02

    legacy

    2 pagesLQ02

    Résumé des recettes et paiements du récepteur jusqu'au 09 déc. 2010

    2 pages3.6

    legacy

    2 pagesLQ02

    Résumé des recettes et paiements du récepteur jusqu'au 25 mai 2010

    2 pages3.6

    Résumé des recettes et paiements du récepteur jusqu'au 25 mai 2009

    2 pages3.6

    Résumé des recettes et paiements du récepteur jusqu'au 25 mai 2008

    2 pages3.6

    Résumé des recettes et paiements du récepteur

    2 pages3.6

    Résumé des recettes et paiements du récepteur

    2 pages3.6

    Résumé des recettes et paiements du récepteur

    2 pages3.6

    Résumé des recettes et paiements du récepteur

    2 pages3.6

    Résumé des recettes et paiements du récepteur

    2 pages3.6

    Résumé des recettes et paiements du récepteur

    2 pages3.6

    legacy

    1 pages287

    Résumé des recettes et paiements du récepteur

    2 pages3.6

    Résumé des recettes et paiements du récepteur

    2 pages3.6

    Résumé des recettes et paiements du récepteur

    2 pages3.6

    Résumé des recettes et paiements du récepteur

    2 pages3.6

    Résumé des recettes et paiements du récepteur

    2 pages3.6

    Résumé des recettes et paiements du récepteur

    2 pages3.6

    Qui sont les dirigeants de LEIGH ESTATES (U.K.) LIMITED ?

    Dirigeants
    NomNommé leDate de démissionRôleAdresseIdentification de la sociétéPays de résidenceNationalitéDate de naissanceProfessionNuméro
    BLYTHE-TINKER, Sarah
    Finchwood House
    Hyde Lane
    CM3 4QS Danbury
    Essex
    Secrétaire
    Finchwood House
    Hyde Lane
    CM3 4QS Danbury
    Essex
    British780760002
    COOK, Kenneth Alan
    27 Glendower Road
    East Sheen
    SW14 8NY London
    Secrétaire
    27 Glendower Road
    East Sheen
    SW14 8NY London
    British100000003
    STANSFIELD, Robert Alan
    St Annes Cottage
    Main Street Welburn
    YO6 7DX York
    North Yorkshire
    Administrateur
    St Annes Cottage
    Main Street Welburn
    YO6 7DX York
    North Yorkshire
    United KingdomBritishChartered Surveyor35238730001
    BOSSOM, Bruce Charles
    Overbury Court
    GL20 7NP Tewkesbury
    Gloucestershire
    Administrateur
    Overbury Court
    GL20 7NP Tewkesbury
    Gloucestershire
    United KingdomBritishCompany Director32773150001
    GOODWILL, Geoffrey Mortimer
    White Court
    5 Foxhill Drive, Weetwood
    LS16 5PG Leeds
    West Yorkshire
    Administrateur
    White Court
    5 Foxhill Drive, Weetwood
    LS16 5PG Leeds
    West Yorkshire
    United KingdomBritishChartered Surveyor100020003
    GREGORY, Kevin John
    20 Edward Road
    BR1 3NQ Bromley
    Kent
    Administrateur
    20 Edward Road
    BR1 3NQ Bromley
    Kent
    United KingdomBritishChartered Accountant68160540002
    MAY, Peter
    895 Park Avenue
    FOREIGN New York
    Ny 10021
    Usa
    Administrateur
    895 Park Avenue
    FOREIGN New York
    Ny 10021
    Usa
    AmericanDirector17839720001
    PELTZ, Nelson
    548 North County Road
    Palm Beach
    FOREIGN
    Florida 33480
    Usa
    Administrateur
    548 North County Road
    Palm Beach
    FOREIGN
    Florida 33480
    Usa
    United StatesCitizen Of UsaCompany Director298235830001
    WARREN, Jeffrey Roger
    3 Golden Yard
    NW3 6UH London
    Administrateur
    3 Golden Yard
    NW3 6UH London
    EnglishFinance Director54089640002
    WATKINS, David
    Cherry Trees Thorley Close
    KT14 6JE West Byfleet
    Surrey
    Administrateur
    Cherry Trees Thorley Close
    KT14 6JE West Byfleet
    Surrey
    AmericanCompany Director10282610001
    WATSON, John Harrison
    Scotton Lodge
    Scotton
    HG5 9HW Knaresborough
    North Yorks
    Administrateur
    Scotton Lodge
    Scotton
    HG5 9HW Knaresborough
    North Yorks
    BritishChartered Surveyor3592920001

    LEIGH ESTATES (U.K.) LIMITED a-t-elle des charges ?

    Charges
    ClassificationDatesStatutDétails
    Deed of rectification
    Créé le 31 janv. 1992
    Livré le 21 févr. 1992
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from thecompany and/or all or any of the other companies to the chargee under the terms of the facility agreements (as defined)
    Brèves mentions
    Land and premises on the south side of pavillions way brackley northamptonshire t/n nn 95291.
    Personnes ayant droit
    • Barclays Bank PLC
    Transactions
    • 21 févr. 1992Enregistrement d'une charge (395)
    • 26 mars 1992Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Assignment
    Créé le 30 juil. 1991
    Livré le 13 août 1991
    En cours
    Montant garanti
    All monies due or to become due from mountleigh estates PLC to the chargee not exceeding £7,000,000 under the terms of a facility letter of even date
    Brèves mentions
    All monies due or owing or from time to time due or owing to the assignor under or by virtue of the assignment. (Please see doc. 395/M/8/158 for full details).
    Personnes ayant droit
    • Barclays Bank PLC
    Transactions
    • 13 août 1991Enregistrement d'une charge
    Debenture
    Créé le 29 juil. 1991
    Livré le 15 août 1991
    En cours
    Montant garanti
    All moneys due or to become due from the company or any of the borrowers (as therein defined) to any one or more of the beneficiaries (as therein defined) or barclays bank PLC as security trustee foe and on behalf of the beneficiaries (as therein defined) under or pursuant to any one or more of the facility agreements, the guarantees or other finance documents (as therein defined)
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personnes ayant droit
    • Barclays Bank PLC
    Transactions
    • 15 août 1991Enregistrement d'une charge
    Floating charge
    Créé le 29 juil. 1991
    Livré le 12 août 1991
    En cours
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company and/or the lloyds borrowers (as therein defined) to lloyds bank PLC under or pursuant to the facility agreement dated 4/7/91 and/or under any guarantees given by the mountleigh group PLC in relation to the facility agreement (as defined) and on any account whatsoever under the terms of such mortgage or charge.
    Brèves mentions
    By way of floating charge and to the intent that the security so constitued shall be a continuing security in favour of the bank in accordance with its rights under the facilities agreements extending to all beneficial interests of the company in the assets so charged see doc 395/m/59/l/138 for full details.
    Personnes ayant droit
    • Lloyds Bank PLC
    Transactions
    • 12 août 1991Enregistrement d'une charge
    • 411 déc. 2010Avis de cessation d'exercer en tant qu'administrateur ou gestionnaire (LQ02)
      • Numéro de dossier 4
    Debenture
    Créé le 29 juil. 1991
    Livré le 12 août 1991
    En cours
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company or any of the borrowers (as therein defined) to any one or more of the beneficiaries (as therein defined) or barclays bank PLC under or pursuant to any one or more of the facility agreements, the guarantees or other finance documents (as therein defined)
    Brèves mentions
    F/H property k/a 2 albert gate city of westminster t/n:- ngl 511287 l/h property k/a 60/60A knightbridge city of westminster t/n: ln 240264 (please see doc 395/m/60/l/13.8 For full details).. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personnes ayant droit
    • Barclays Bank PLC
    Transactions
    • 12 août 1991Enregistrement d'une charge
    • 01 juin 1992Nomination d'un administrateur ou d'un gestionnaire (405 (1))
    • 326 janv. 2011Avis de cessation d'exercer en tant qu'administrateur ou gestionnaire (LQ02)
      • Numéro de dossier 3
    Floating charge
    Créé le 27 juil. 1990
    Livré le 15 août 1990
    En cours
    Montant garanti
    All monies due or to be come due from the company to and mountleight group PLC and certain of its subsidiaries under the terms of the facility agreement and/or this charge to the chargee
    Brèves mentions
    Floating charge over the:- (please see doc 395/m/9/6 16/8 for complete details). Undertaking and all property and assets present and future including uncalled capital.
    Personnes ayant droit
    • Barclays Bank PLC
    Transactions
    • 15 août 1990Enregistrement d'une charge
    • 226 janv. 2011Avis de cessation d'exercer en tant qu'administrateur ou gestionnaire (LQ02)
      • Numéro de dossier 2
    Floating charge
    Créé le 27 juil. 1990
    Livré le 15 août 1990
    En cours
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to and/or mountleigh group PLC under the terms of the facility agreement and/or this charge the chargee
    Brèves mentions
    By way of a floating charge over the:- (please see doc 395/m/8/l/16/8 for complete details).. Undertaking and all property and assets present and future including uncalled capital.
    Personnes ayant droit
    • Barclays Bank PLC
    Transactions
    • 15 août 1990Enregistrement d'une charge
    Floating charge
    Créé le 27 juil. 1990
    Livré le 15 août 1990
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to be come due from M.G.P. holding S.A. to the chargee under the terms of the facility agreement and/or this charge
    Brèves mentions
    Floating charge over the:- (please doc 395/m/10/6/16/8 for complete details). Undertaking and all property and assets present and future including uncalled capital.
    Personnes ayant droit
    • Citybank N.A. Spanish Branch
    Transactions
    • 15 août 1990Enregistrement d'une charge
    • 01 juin 1992Nomination d'un administrateur ou d'un gestionnaire (405 (1))
    • 01 juin 1992Nomination d'un administrateur ou d'un gestionnaire (405 (1))
    • 26 oct. 1995Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    • 126 janv. 2011Avis de cessation d'exercer en tant qu'administrateur ou gestionnaire (LQ02)
      • Numéro de dossier 1
    Legal charge
    Créé le 24 avr. 1987
    Livré le 06 mai 1987
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    Sterling pounds 750,000
    Brèves mentions
    F/Hold lahnd situate at chatlewood farm, glen road, plymouth, city of plymouth t/no - dn 200084.
    Personnes ayant droit
    • The Council of the City of Plymouth
    Transactions
    • 06 mai 1987Enregistrement d'une charge
    Legal charge
    Créé le 03 mars 1987
    Livré le 04 mars 1987
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of a facility letter dated 2/3/87.
    Brèves mentions
    F/Hold 28/36 (inclusive) sackville street, london w 1 t/no - ngl 514750 f/hold land at bankside & on the east side of southwark bridge road & north side of park street, l/b o fsouthwark t/no - sgl 327190 & adjoining l/hold land on the north side of park street aforesaid t/no - sgl 339200. (plesase refer to doc m 199/4 mar/ln for full details). Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Personnes ayant droit
    • Union Bank of Switzerland
    Transactions
    • 04 mars 1987Enregistrement d'une charge
    First legal charge
    Créé le 30 sept. 1986
    Livré le 07 oct. 1986
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    All that property rested in the company k/a or being land on the north west side of kings road chelsea t/n - ngl 35658. , building materials of all kinds (see form 395 m 265 /7 oct/ln for full details). Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Personnes ayant droit
    • First Interestate Bank of California
    Transactions
    • 07 oct. 1986Enregistrement d'une charge
    First legal charge
    Créé le 30 sept. 1986
    Livré le 07 oct. 1986
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    All that property rested in the company k/a or being 120 and part of 122 kings road chelsea t/n - 265,605 , building materials of all kinds. (See form 395 m 265/7 oct/ln for full details). Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Personnes ayant droit
    • First Interstate Bank of California
    Transactions
    • 07 oct. 1986Enregistrement d'une charge
    Legal charge
    Créé le 04 sept. 1986
    Livré le 10 sept. 1986
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Land on the northwest side of cornwood road plympton T.n dn 38762 (part) and dn 158878 (see form 395 for details) m 2/1/sep/ln refers). Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Personnes ayant droit
    • First Inter-State Bank of California
    Transactions
    • 10 sept. 1986Enregistrement d'une charge
    Legal charge
    Créé le 23 mai 1986
    Livré le 10 juin 1986
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Land at dagenham dock industrial estate dagenham essex.
    Personnes ayant droit
    • Barclays Bank PLC
    Transactions
    • 10 juin 1986Enregistrement d'une charge
    Legal charge
    Créé le 31 janv. 1986
    Livré le 19 févr. 1986
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    L/H, 25 old bond street, london W1 title no ngl 145452. together with all buildings and erections thereon and all fixtures whatsoever now or at any time hereafter affixed or attached to the property or any part thereof other than trade machinery as defined by section 5 of the bills of sale act 1878.
    Personnes ayant droit
    • The Royal Trust Company of Cananda
    Transactions
    • 19 févr. 1986Enregistrement d'une charge
    Legal charge
    Créé le 14 janv. 1986
    Livré le 30 janv. 1986
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    7B palace court, londn W2 t/n ngl 161737 together with buildings and all fixed plant and machinery and fixtures.
    Personnes ayant droit
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transactions
    • 30 janv. 1986Enregistrement d'une charge
    Legal charge
    Créé le 02 janv. 1986
    Livré le 06 janv. 1986
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    The passfield reseach laboratories and contiguous vacantland, passfield, nr liphook, hants.
    Personnes ayant droit
    • The Royal Bank O Fscotland PLC
    Transactions
    • 06 janv. 1986Enregistrement d'une charge
    Letter
    Créé le 30 août 1985
    Livré le 05 sept. 1985
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    The principal sum of sterling pounds 2,000.000 and or other moneys due or to beccome due under the terms of a secured loan agreements dated 30/08/85
    Brèves mentions
    First equitable mortgage of att-the f/h & l/h properties more particularly described in the attached schedule. (See doc m 126).
    Personnes ayant droit
    • First Interstate Bank of California
    Transactions
    • 05 sept. 1985Enregistrement d'une charge
    Legal charge
    Créé le 24 juin 1985
    Livré le 28 juin 1985
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    The dagenham dock industrial estate, dagenham, l/b of banking & dagenham tns:- egl 106380 egl 105923 egl 28403.
    Personnes ayant droit
    • Barclays Bank PLC
    Transactions
    • 28 juin 1985Enregistrement d'une charge

    LEIGH ESTATES (U.K.) LIMITED a-t-elle des procédures d'insolvabilité ?

    Numéro de dossierDatesTypePraticiensAutre
    1
    DateType
    27 juil. 1990Instrument date
    Receiver/Manager appointed
    NomRôleAdresseNommé leCessé le
    R.H. H Oldfield
    Kpmg
    P O Box 730
    EC4V 4PP 20 Farringdon Street
    London
    practitioner
    Kpmg
    P O Box 730
    EC4V 4PP 20 Farringdon Street
    London
    Ss James
    20 Farringdon Street
    London
    EC4A 4PP
    practitioner
    20 Farringdon Street
    London
    EC4A 4PP
    2
    DateType
    27 juil. 1990Instrument date
    Administrative receiver appointed
    NomRôleAdresseNommé leCessé le
    R.H. H Oldfield
    Kpmg
    P O Box 730
    EC4V 4PP 20 Farringdon Street
    London
    practitioner
    Kpmg
    P O Box 730
    EC4V 4PP 20 Farringdon Street
    London
    Ss James
    20 Farringdon Street
    London
    EC4A 4PP
    practitioner
    20 Farringdon Street
    London
    EC4A 4PP
    3
    DateType
    29 juil. 1991Instrument date
    Administrative receiver appointed
    NomRôleAdresseNommé leCessé le
    R.H. H Oldfield
    Kpmg
    P O Box 730
    EC4V 4PP 20 Farringdon Street
    London
    practitioner
    Kpmg
    P O Box 730
    EC4V 4PP 20 Farringdon Street
    London
    Ss James
    20 Farringdon Street
    London
    EC4A 4PP
    practitioner
    20 Farringdon Street
    London
    EC4A 4PP
    4
    DateType
    29 juil. 1991Instrument date
    Administrative receiver appointed
    NomRôleAdresseNommé leCessé le
    R.H. H Oldfield
    Kpmg
    P O Box 730
    EC4V 4PP 20 Farringdon Street
    London
    practitioner
    Kpmg
    P O Box 730
    EC4V 4PP 20 Farringdon Street
    London
    Ss James
    20 Farringdon Street
    London
    EC4A 4PP
    practitioner
    20 Farringdon Street
    London
    EC4A 4PP

    Source de données

    • Companies House du Royaume-Uni
      Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers.
    • Licence: CC0