HANDIGAS LIMITED

  • Vue d'ensemble
  • Résumé
  • Objet social
  • Adresse
  • Dénominations sociales précédentes
  • Comptes
  • Déclaration de confirmation
  • Dépôts
  • Dirigeants
  • Personnes ayant un contrôle significatif
  • Source de données
  • Vue d'ensemble

    Nom de la sociétéHANDIGAS LIMITED
    Statut de la sociétéActive
    Forme juridiqueSociété à responsabilité limitée
    Numéro de société 00131805
    JuridictionAngleterre/Pays de Galles
    Date de création

    Résumé

    A des PSCs super sécurisésNon
    A des chargesNon
    A un historique d'insolvabilitéNon
    Le siège social est contestéNon

    Quel est l'objet de HANDIGAS LIMITED ?

    • Activités des sièges sociaux (70100) / Activités spécialisées, scientifiques et techniques
    • Autres activités de soutien aux entreprises n.c.a. (82990) / Activités administratives et de soutien

    Où se situe HANDIGAS LIMITED ?

    Adresse du siège social
    Forge
    43 Church Street West
    GU21 6HT Woking
    Surrey
    England
    Adresse du siège social non livrableNon

    Quels étaient les noms précédents de HANDIGAS LIMITED ?

    Dénominations sociales précédentes
    Nom de la sociétéDeJusqu'au
    LIQUID OXYGEN LIMITED25 oct. 191325 oct. 1913

    Quels sont les derniers comptes de HANDIGAS LIMITED ?

    En retardNon
    Prochains comptes
    Fin de la prochaine période comptable le31 déc. 2024
    Date d'échéance des prochains comptes30 sept. 2025
    Derniers comptes
    Derniers comptes arrêtés au31 déc. 2023

    Quel est le statut de la dernière déclaration de confirmation pour HANDIGAS LIMITED ?

    Dernière déclaration de confirmation établie jusqu'au07 oct. 2025
    Date d'échéance de la prochaine déclaration de confirmation21 oct. 2025
    Dernière déclaration de confirmation
    Prochaine déclaration de confirmation établie jusqu'au07 oct. 2024
    En retardNon

    Quels sont les derniers dépôts pour HANDIGAS LIMITED ?

    Dépôts
    DateDescriptionDocumentType

    Nomination de Mrs Susan Kathleen Kelly en tant qu'administrateur le 01 nov. 2024

    2 pagesAP01

    Cessation de la nomination de Benjamin Patterson en tant que directeur le 09 oct. 2024

    1 pagesTM01

    Déclaration de confirmation établie le 07 oct. 2024 sans mise à jour

    3 pagesCS01

    Comptes annuels établis au 31 déc. 2023

    144 pagesAA

    Modification des coordonnées de l'administrateur Mr Christopher James Cossins le 04 mars 2024

    2 pagesCH01

    Déclaration de confirmation établie le 07 oct. 2023 sans mise à jour

    3 pagesCS01

    Comptes annuels établis au 31 déc. 2022

    137 pagesAA

    Modification des coordonnées de l'administrateur Mr Benjamin Patterson le 27 avr. 2023

    2 pagesCH01

    Déclaration de confirmation établie le 07 oct. 2022 sans mise à jour

    3 pagesCS01

    Comptes annuels établis au 31 déc. 2021

    144 pagesAA

    Modification des détails de The Boc Group Limited en tant que personne disposant d'un contrôle significatif le 01 avr. 2022

    2 pagesPSC05

    Changement d'adresse du siège social de The Priestley Centre 10 Priestley Road the Surrey Research Park, Guildford, Surrey GU2 7XY à Forge 43 Church Street West Woking Surrey GU21 6HT le 04 avr. 2022

    1 pagesAD01

    Modification des coordonnées de l'administrateur Mr Christopher James Cossins le 01 avr. 2022

    2 pagesCH01

    Modification des coordonnées de l'administrateur Mrs Sally Ann Williams le 01 avr. 2022

    2 pagesCH01

    Modification des coordonnées de l'administrateur Mr Julian Michael Bland le 01 avr. 2022

    2 pagesCH01

    Modification des coordonnées de l'administrateur Mr Benjamin Patterson le 01 avr. 2022

    2 pagesCH01

    Modification des coordonnées du secrétaire Mrs Susan Kathleen Kelly le 01 avr. 2022

    1 pagesCH03

    Nomination de Mr Christopher James Cossins en tant qu'administrateur le 15 nov. 2021

    2 pagesAP01

    Déclaration de confirmation établie le 07 oct. 2021 sans mise à jour

    3 pagesCS01

    Comptes annuels établis au 31 déc. 2020

    147 pagesAA

    Modification des coordonnées de l'administrateur Mr Julian Michael Bland le 28 juin 2021

    2 pagesCH01

    Modification des coordonnées de l'administrateur Mr Benjamin Patterson le 21 mai 2021

    2 pagesCH01

    Comptes annuels établis au 31 déc. 2019

    180 pagesAA

    Déclaration de confirmation établie le 07 oct. 2020 sans mise à jour

    3 pagesCS01

    Déclaration de confirmation établie le 07 oct. 2019 sans mise à jour

    3 pagesCS01

    Qui sont les dirigeants de HANDIGAS LIMITED ?

    Dirigeants
    NomNommé leDate de démissionRôleAdresseIdentification de la sociétéPays de résidenceNationalitéDate de naissanceProfessionNuméro
    KELLY, Susan Kathleen
    43 Church Street West
    GU21 6HT Woking
    Linde, Forge
    Surrey
    England
    Secrétaire
    43 Church Street West
    GU21 6HT Woking
    Linde, Forge
    Surrey
    England
    British71087960003
    BLAND, Julian Michael
    43 Church Street West
    GU21 6HT Woking
    Linde, Forge
    Surrey
    England
    Administrateur
    43 Church Street West
    GU21 6HT Woking
    Linde, Forge
    Surrey
    England
    EnglandBritishHead Of Accounting193502260038
    COSSINS, Christopher James
    43 Church Street West
    GU21 6HT Woking
    Linde, Forge
    Surrey
    England
    Administrateur
    43 Church Street West
    GU21 6HT Woking
    Linde, Forge
    Surrey
    England
    EnglandBritishTax Manager156918520058
    KELLY, Susan Kathleen
    43 Church Street West
    GU21 6HT Woking
    Linde, Forge
    Surrey
    England
    Administrateur
    43 Church Street West
    GU21 6HT Woking
    Linde, Forge
    Surrey
    England
    EnglandBritishCompany Secretary329050710001
    WILLIAMS, Sally Ann
    43 Church Street West
    GU21 6HT Woking
    Linde, Forge
    Surrey
    England
    Administrateur
    43 Church Street West
    GU21 6HT Woking
    Linde, Forge
    Surrey
    England
    EnglandBritishAccountant204065740002
    BRACKFIELD, Andrew Christopher
    The Linde Group, Priestley Centre 10 Priestley Rd
    Surrey Research Park
    GU2 7XY Guildford
    Surrey
    Secrétaire
    The Linde Group, Priestley Centre 10 Priestley Rd
    Surrey Research Park
    GU2 7XY Guildford
    Surrey
    BritishSolicitor118706260003
    HUNT, Carol Anne
    The Boc Group
    Chertsey Road
    GU20 6HJ Windlesham
    Surrey
    Secrétaire
    The Boc Group
    Chertsey Road
    GU20 6HJ Windlesham
    Surrey
    British40992870003
    HUNT, Carol Anne
    4 Alloway Close
    St Johns
    GU21 3HY Woking
    Surrey
    Secrétaire
    4 Alloway Close
    St Johns
    GU21 3HY Woking
    Surrey
    British40992870001
    LARKINS, Sarah Louise
    11 Bluebell Road
    Lindford
    GU35 0YN Bordon
    Hampshire
    Secrétaire
    11 Bluebell Road
    Lindford
    GU35 0YN Bordon
    Hampshire
    British99307280001
    PAVEY, David Gordon
    28 Malthouse Close
    Church Crookham
    GU13 0TB Fleet
    Hampshire
    Secrétaire
    28 Malthouse Close
    Church Crookham
    GU13 0TB Fleet
    Hampshire
    British3878440002
    SMALL, Jeremy Peter
    Cherry Trees
    West Heath
    GU24 0JQ Pirbright
    Surrey
    Secrétaire
    Cherry Trees
    West Heath
    GU24 0JQ Pirbright
    Surrey
    British67168210001
    BAKER, Ian Kenneth Hood
    33 Atfield Grove
    GU20 6DP Windlesham
    Surrey
    Administrateur
    33 Atfield Grove
    GU20 6DP Windlesham
    Surrey
    BritishChartered Secretary3994580001
    BRACKFIELD, Andrew Christopher
    The Linde Group, Priestley Centre 10 Priestley Rd
    Surrey Research Park
    GU2 7XY Guildford
    Surrey
    Administrateur
    The Linde Group, Priestley Centre 10 Priestley Rd
    Surrey Research Park
    GU2 7XY Guildford
    Surrey
    EnglandBritishSolicitor118706260003
    CHIPCHASE, Graham Andrew
    Brook Cottage
    Kings Saltern Road
    SO41 3QH Lymington
    Hampshire
    Administrateur
    Brook Cottage
    Kings Saltern Road
    SO41 3QH Lymington
    Hampshire
    BritishChartered Accountant64473880001
    CONNELL, William Edward
    Maedan Merrywood Copse
    65 Portsmouth Road
    GU15 1JD Camberley
    Surrey
    Administrateur
    Maedan Merrywood Copse
    65 Portsmouth Road
    GU15 1JD Camberley
    Surrey
    BritishGroup Controller21334820002
    DEEMING, Nicholas
    The Boc Group Plc
    Chertsey Road
    GU20 6HJ Windlesham
    Surrey
    Administrateur
    The Boc Group Plc
    Chertsey Road
    GU20 6HJ Windlesham
    Surrey
    BritishSolicitor64399320009
    DENNIS, Michael
    Boc Limited
    Priestley Centre, 10 Priestley Road
    GU2 7XY Guildford
    Surrey
    Administrateur
    Boc Limited
    Priestley Centre, 10 Priestley Road
    GU2 7XY Guildford
    Surrey
    BritishHead Of Marketing Uk & Ireland118951230001
    DEVERS, Dorian Kevin Thomas
    10 Priestley Road, Surrey Research Park
    GU2 7XY Guildford
    The Linde Group The Priestley Centre
    Surrey
    England
    Administrateur
    10 Priestley Road, Surrey Research Park
    GU2 7XY Guildford
    The Linde Group The Priestley Centre
    Surrey
    England
    EnglandBritishHead Of Finance, Africa & Uk208186510001
    FERGUSON, Alan Murray
    The Boc Group
    Chertsey Road
    GU20 6HJ Windlesham
    Surrey
    Administrateur
    The Boc Group
    Chertsey Road
    GU20 6HJ Windlesham
    Surrey
    BritishGroup Finance Director108042900001
    FINKEN, Thorben, Dr
    10 Priestley Road
    Surrey Research Park
    GU2 7XY Guildford
    The Linde Group, The Priestley Centre
    Surrey
    Administrateur
    10 Priestley Road
    Surrey Research Park
    GU2 7XY Guildford
    The Linde Group, The Priestley Centre
    Surrey
    EnglandGermanFinance Director Region Africa And Uk152685750001
    ISAAC, Anthony Eric
    The Boc Group
    Chertsey Road
    GU20 6HJ Windlesham
    Surrey
    Administrateur
    The Boc Group
    Chertsey Road
    GU20 6HJ Windlesham
    Surrey
    BritishChief Executive4882700004
    LEWIS, Nigel Andrew
    The Linde Group The Priestley
    Centre 10 Priestley Rd The Surrey, Research Park
    GU2 7XY Guildford
    Surrey
    Administrateur
    The Linde Group The Priestley
    Centre 10 Priestley Rd The Surrey, Research Park
    GU2 7XY Guildford
    Surrey
    United KingdomBritishDirector Acquisitions & New Vent146324340001
    MASTERS JR, Jerry Kent
    The Linde Group The Priestley Centre
    10 Priestley Rd, The Surrey Research Park
    GU2 7XY Guildford
    Surrey
    Administrateur
    The Linde Group The Priestley Centre
    10 Priestley Rd, The Surrey Research Park
    GU2 7XY Guildford
    Surrey
    AmericanChief Executive I & Sp103851600002
    MEDORI, Rene
    Woodhaven Green
    Wood Lane St George's Hill
    KT13 0JU Weybridge
    Surrey
    Administrateur
    Woodhaven Green
    Wood Lane St George's Hill
    KT13 0JU Weybridge
    Surrey
    FrenchGroup Finance Director106115110001
    MOSTYN, Gareth
    The Linde Group The Priestley Centre
    10 Priestley Road Surrey Research Park
    GU2 7XY Guildford
    Surrey
    Administrateur
    The Linde Group The Priestley Centre
    10 Priestley Road Surrey Research Park
    GU2 7XY Guildford
    Surrey
    BritishAccountant126699160001
    PALMER, Nathan
    The Priestley Centre, 10 Priestley Road
    GU2 7XY Guildford
    The Linde Group
    Surrey
    England
    Administrateur
    The Priestley Centre, 10 Priestley Road
    GU2 7XY Guildford
    The Linde Group
    Surrey
    England
    EnglandBritishHead Of Regional Sales & Marketing168273890001
    PATTERSON, Benjamin
    43 Church Street West
    GU21 6HT Woking
    Linde, Forge
    Surrey
    England
    Administrateur
    43 Church Street West
    GU21 6HT Woking
    Linde, Forge
    Surrey
    England
    EnglandBritishSolicitor208185060037
    PAVEY, David Gordon
    28 Malthouse Close
    Church Crookham
    GU13 0TB Fleet
    Hampshire
    Administrateur
    28 Malthouse Close
    Church Crookham
    GU13 0TB Fleet
    Hampshire
    BritishChartered Secretary3878440002
    PREBBLE, John Mark Selwyn
    Carbery Mount Pleasant
    Hartley Wintney
    RG27 8PW Basingstoke
    Hampshire
    Administrateur
    Carbery Mount Pleasant
    Hartley Wintney
    RG27 8PW Basingstoke
    Hampshire
    British/New ZealanderLawyer75270780001
    ROSENKRANZ, Franklin Daniel
    Windrush
    Coombe End
    KT2 7DQ Kingston-Upon-Thames
    Surrey
    Administrateur
    Windrush
    Coombe End
    KT2 7DQ Kingston-Upon-Thames
    Surrey
    United KingdomBritishChief Executive3878460001
    SAITH, Vijay Kumar
    Pendennis
    Pyrford Road
    KT14 6RQ West Byfleet
    Surrey
    Administrateur
    Pendennis
    Pyrford Road
    KT14 6RQ West Byfleet
    Surrey
    BritishDeputy Finance Director23840930001
    SMALL, Jeremy Peter
    Cherry Trees
    West Heath
    GU24 0JQ Pirbright
    Surrey
    Administrateur
    Cherry Trees
    West Heath
    GU24 0JQ Pirbright
    Surrey
    EnglandBritishAssistant Secretary67168210001
    SPENCE, Patrick Charles Gordon
    The Linde Group The Priestley Centre
    10 Priestley Road
    GU2 7XY Surrey Research Park
    Surrey
    Administrateur
    The Linde Group The Priestley Centre
    10 Priestley Road
    GU2 7XY Surrey Research Park
    Surrey
    BritishChartered Accountant79853340013
    STUART, Gloria Jean
    Appin Lodge
    Long Hill The Sands
    GU10 1NQ Farnham
    Surrey
    Administrateur
    Appin Lodge
    Long Hill The Sands
    GU10 1NQ Farnham
    Surrey
    United KingdomBritishSolicitor39220810002
    WALSH, John Lawrence
    The Boc Group
    Chertsey Road
    GU20 6HJ Windlesham
    Surrey
    Administrateur
    The Boc Group
    Chertsey Road
    GU20 6HJ Windlesham
    Surrey
    AmericanChief Executive I&Sp77090210003

    Qui sont les personnes ayant un contrôle significatif sur HANDIGAS LIMITED ?

    Personnes ayant un contrôle significatif
    NomNotifié leAdresseCessé
    The Boc Group Limited
    43 Church Street West
    GU21 6HT Woking
    Forge
    Surrey
    England
    06 avr. 2016
    43 Church Street West
    GU21 6HT Woking
    Forge
    Surrey
    England
    Non
    Forme juridiquePrivate Company Limited By Shares
    Pays d'enregistrementUnited Kingdom
    Autorité légaleThe Companies Act 2006
    Lieu d'enregistrementEngland & Wales
    Numéro d'enregistrement00022096
    Nature du contrôle
    • La personne détient, directement ou indirectement, plus de 75 % des actions de la société.
    • La personne détient, directement ou indirectement, plus de 75 % des droits de vote dans la société.
    • La personne détient, directement ou indirectement, le droit de nommer ou de révoquer une majorité des membres du conseil d'administration de la société.

    Source de données

    • Companies House du Royaume-Uni
      Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers.
    • Licence: CC0