SUNNYLAND NORTH LIMITED

  • Vue d'ensemble
  • Résumé
  • Objet social
  • Adresse
  • Dénominations sociales précédentes
  • Comptes
  • Dépôts
  • Dirigeants
  • Charges
  • Insolvabilité
  • Source de données
  • Vue d'ensemble

    Nom de la sociétéSUNNYLAND NORTH LIMITED
    Statut de la sociétéDissoute
    Forme juridiqueSociété à responsabilité limitée
    Numéro de société 00132891
    JuridictionAngleterre/Pays de Galles
    Date de création
    Date de cessation d'activité

    Résumé

    A des PSCs super sécurisésNon
    A des chargesOui
    A un historique d'insolvabilitéOui
    Le siège social est contestéNon

    Quel est l'objet de SUNNYLAND NORTH LIMITED ?

    • (5190) /

    Où se situe SUNNYLAND NORTH LIMITED ?

    Adresse du siège social
    Station House
    Midland Drive
    B72 1TU Sutton Coldfield
    West Midlands
    Adresse du siège social non livrableNon

    Quels étaient les noms précédents de SUNNYLAND NORTH LIMITED ?

    Dénominations sociales précédentes
    Nom de la sociétéDeJusqu'au
    BENJAMIN SHAW DISPENSE LIMITED15 mars 200515 mars 2005
    BENJAMIN SHAW & SONS,LIMITED19 déc. 191319 déc. 1913

    Quels sont les derniers comptes de SUNNYLAND NORTH LIMITED ?

    Derniers comptes
    Derniers comptes arrêtés au31 déc. 2008

    Quels sont les derniers dépôts pour SUNNYLAND NORTH LIMITED ?

    Dépôts
    DateDescriptionDocumentType

    Gazette finale dissoute à la suite d'une liquidation

    1 pagesGAZ2

    Retour de la réunion finale dans une liquidation volontaire des créanciers

    8 pages4.72

    Déclaration des reçus et paiements des liquidateurs jusqu'à 26 sept. 2012

    9 pages4.68

    Déclaration des reçus et paiements des liquidateurs jusqu'à 26 sept. 2011

    8 pages4.68

    Changement d'adresse du siège social de Gelderd Point Gelderd Raod Gildersome Leeds West Yorkshie LS27 7JP le 12 oct. 2010

    2 pagesAD01

    Résolutions

    Resolutions
    1 pagesRESOLUTIONS
    Résolutions
    CatégorieDateDescriptionType
    liquidation

    Résolution extraordinaire pour la liquidation au 27 sept. 2010

    LRESEX

    Déclaration des affaires avec le formulaire 4.19 attaché

    5 pages4.20

    Nomination d'un liquidateur volontaire

    2 pages600

    Déclaration annuelle jusqu'au 30 juin 2010 avec liste complète des actionnaires

    6 pagesAR01
    Dépôts associés
    CatégorieDateDescriptionType
    capital02 juil. 2010

    État du capital au 02 juil. 2010

    • Capital: GBP 50,000
    SH01

    Modification des coordonnées de l'administrateur Abbasgholi Bayat le 26 mars 2010

    2 pagesCH01

    Changement d'adresse du siège social de Unit 2 Fieldhouse Park Old Fieldhouse Lane Huddersfield West Yorkshire HD2 1FA le 05 févr. 2010

    1 pagesAD01

    Cessation de la nomination de Gholamreza Bayat en tant que directeur

    1 pagesTM01

    Comptes annuels établis au 31 déc. 2008

    22 pagesAA

    Certificat de changement de nom

    Company name changed benjamin shaw dispense LIMITED\certificate issued on 29/01/10
    3 pagesCERTNM
    Résolutions
    CatégorieDateDescriptionType
    change-of-name

    Résolution de changement de nom

    RES15

    Avis de changement de nom"

    1 pagesCONNOT

    Modification des coordonnées de l'administrateur Abbasgholi Bayat le 01 oct. 2009

    2 pagesCH01

    legacy

    5 pages363a

    Comptes annuels établis au 31 déc. 2007

    23 pagesAA

    legacy

    2 pages403a

    Statuts

    44 pagesMA

    legacy

    5 pages363a

    legacy

    1 pages391

    Comptes annuels établis au 31 déc. 2006

    19 pagesAA

    legacy

    3 pages363a

    legacy

    1 pages288c

    Qui sont les dirigeants de SUNNYLAND NORTH LIMITED ?

    Dirigeants
    NomNommé leDate de démissionRôleAdresseIdentification de la sociétéPays de résidenceNationalitéDate de naissanceProfessionNuméro
    HERBERT, Susan
    114 Green Park Road
    HX3 0SW Halifax
    West Yorkshire
    Secrétaire
    114 Green Park Road
    HX3 0SW Halifax
    West Yorkshire
    British62773400001
    BAYAT, Abbasgholi
    Midland Drive
    B72 1TU Sutton Coldfield
    Station House
    West Midlands
    Administrateur
    Midland Drive
    B72 1TU Sutton Coldfield
    Station House
    West Midlands
    UsaAmerican & IranianDirector62773100009
    NOUWEN, Jan Christian Delfina
    St Antonfuspaan 5
    Zoersel
    2980
    Belgium
    Administrateur
    St Antonfuspaan 5
    Zoersel
    2980
    Belgium
    BelgiumBelgianDirector94710600001
    HERBERT, Susan
    114 Green Park Road
    HX3 0SW Halifax
    West Yorkshire
    Secrétaire
    114 Green Park Road
    HX3 0SW Halifax
    West Yorkshire
    BritishAccountant62773400001
    HOLT, David Julian
    Flat 3 53 Windsor Road
    Ealing
    W5 3UP London
    Secrétaire
    Flat 3 53 Windsor Road
    Ealing
    W5 3UP London
    British39624950001
    WHITTAKER, William Jack
    179 Newchurch Road
    BB4 7SU Rossendale
    Lancashire
    Secrétaire
    179 Newchurch Road
    BB4 7SU Rossendale
    Lancashire
    British68027450001
    HACKWOOD SECRETARIES LIMITED
    One Silk Street
    EC2Y 8HQ London
    Secrétaire désigné
    One Silk Street
    EC2Y 8HQ London
    900004790001
    BAYAT, Gholamreza
    Suite 2006
    1115 Sherbrooke West
    FOREIGN Montreal Quebec Canada
    H3a 1h3
    Administrateur
    Suite 2006
    1115 Sherbrooke West
    FOREIGN Montreal Quebec Canada
    H3a 1h3
    CanadaIranianDirector62773170002
    CARTWRIGHT, Paul Ian
    195 Highbury Quadrant
    N5 2TE London
    Administrateur
    195 Highbury Quadrant
    N5 2TE London
    BritishChartered Accountant40873830002
    CLEGG, Martin John
    Park Farm
    Lower End Road Wavendon
    MK17 8AA Milton Keynes
    Bucks
    Administrateur
    Park Farm
    Lower End Road Wavendon
    MK17 8AA Milton Keynes
    Bucks
    BritishChief Executive51749550001
    DOWLING, Christopher Bruce
    Rutland House
    Rutland Gardens
    SW7 1BX Knightsbridge
    London
    Administrateur
    Rutland House
    Rutland Gardens
    SW7 1BX Knightsbridge
    London
    AustralianChartered Accountant28868820001
    GIBBS, Ian Henry Frank
    The Cleveland
    Westbourne Road Glrdholt
    HD1 4LA Huddersfield
    West Yorkshire
    Administrateur
    The Cleveland
    Westbourne Road Glrdholt
    HD1 4LA Huddersfield
    West Yorkshire
    BritishProduction Director62773500002
    GIBBS, Ian Henry Frank
    60 Luck Lane
    HD1 4QX Huddersfield
    Administrateur
    60 Luck Lane
    HD1 4QX Huddersfield
    BritishProduction Director62773500001
    GREEN, Andrew Raymond
    The Crest Main Road
    Hallow
    WR2 6LD Worcester
    Worcestershire
    Administrateur
    The Crest Main Road
    Hallow
    WR2 6LD Worcester
    Worcestershire
    BritishFinancial Director24492610001
    LANGDON, Michael Robert Finch
    29 Sumner Place
    SW7 3NT London
    Administrateur
    29 Sumner Place
    SW7 3NT London
    EnglandBritishChartered Accountant1483050001
    PASSMORE, Neil Robert
    20 Shaftesbury Avenue
    BD9 6AJ Bradford
    West Yorkshire
    Administrateur
    20 Shaftesbury Avenue
    BD9 6AJ Bradford
    West Yorkshire
    BritishTechnical Director14792300001
    SHAW, Christopher John
    Bray House Woodhead Road
    Holmfirth
    HD7 1PX Huddersfield
    West Yorkshire
    Administrateur
    Bray House Woodhead Road
    Holmfirth
    HD7 1PX Huddersfield
    West Yorkshire
    BritishSoft Drinks Manufacturer1480370001
    SHAW, John Martin
    Fox House Farm
    Netherthong
    HD7 2UP Huddersfield
    West Yorkshire
    Administrateur
    Fox House Farm
    Netherthong
    HD7 2UP Huddersfield
    West Yorkshire
    BritishSoft Drinks Manufacturer1480350001
    SHAW, Robert Benjamin
    Gawthorpe Green Farmhouse
    Gawthorpe Green Lane
    HD5 0NX Kirkheaton
    Huddersfield
    Administrateur
    Gawthorpe Green Farmhouse
    Gawthorpe Green Lane
    HD5 0NX Kirkheaton
    Huddersfield
    United KingdomBritishSoft Drinks Manufacturer14792280003
    SHAW, Robert Michael
    336 Birkby Road
    HD2 2DB Huddersfield
    West Yorkshire
    Administrateur
    336 Birkby Road
    HD2 2DB Huddersfield
    West Yorkshire
    BritishSoft Drinks Manufacturer1480340001
    VAVEDIN, Roland
    Hasseltsesteenweg 374
    3800 Sint-Truiden
    FOREIGN Belgium
    Administrateur
    Hasseltsesteenweg 374
    3800 Sint-Truiden
    FOREIGN Belgium
    BelgianDirector62773280001

    SUNNYLAND NORTH LIMITED a-t-elle des charges ?

    Charges
    ClassificationDatesStatutDétails
    Composite all assets guarantee and debenture
    Créé le 08 févr. 2005
    Livré le 14 févr. 2005
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company and the obligors to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Ge Commercial Finance Limited
    Transactions
    • 14 févr. 2005Enregistrement d'une charge (395)
    • 21 janv. 2009Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Guarantee and debenture
    Créé le 10 déc. 1998
    Livré le 21 déc. 1998
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to any of the secured parties (as defined) under or pursuant to any of the financing documents (as defined)
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland,as Facility Agent for the Secured Parties
    Transactions
    • 21 déc. 1998Enregistrement d'une charge (395)
    • 09 avr. 2005Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Legal charge
    Créé le 02 juin 1994
    Livré le 10 juin 1994
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    L/H property k/a land north west side of willow lane huddersfield west yorkshire title no YWE56368 tog with all buildings and fixtures. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment and an assignment of the goodwill and connection of any business together with the full benefit of all licences.
    Personnes ayant droit
    • Lloyds Bank PLC
    Transactions
    • 10 juin 1994Enregistrement d'une charge (395)
    • 27 févr. 2004Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Legal charge
    Créé le 02 juin 1994
    Livré le 10 juin 1994
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    L/H property k/a land lying to north west of willow lane & to the north east of st johns road huddersfield title no YWE7959 tog with all buildings and fixtures. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment and an assignment of the goodwill and connection of any business together with the full benefit of all licences.
    Personnes ayant droit
    • Lloyds Bank PLC
    Transactions
    • 10 juin 1994Enregistrement d'une charge (395)
    • 12 oct. 2002Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Debenture
    Créé le 22 mai 1991
    Livré le 23 mai 1991
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personnes ayant droit
    • Lloyds Bank PLC
    Transactions
    • 23 mai 1991Enregistrement d'une charge
    • 27 sept. 2001Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Mortgage
    Créé le 15 févr. 1991
    Livré le 20 févr. 1991
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Soft drinks factory and distribution centre with warehouseing and office accomodation situate at bondgate pontefract in the county of west yorkshire now or from time to time placed on or used in or about the said property.& The goodwill of the business (if any).. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Personnes ayant droit
    • Lloyds Bank PLC
    Transactions
    • 20 févr. 1991Enregistrement d'une charge
    • 30 sept. 2004Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)

    SUNNYLAND NORTH LIMITED a-t-elle des procédures d'insolvabilité ?

    Numéro de dossierDatesTypePraticiensAutre
    1
    DateType
    27 sept. 2010Commencement of winding up
    28 févr. 2014Dissolved on
    Creditors voluntary liquidation
    NomRôleAdresseNommé leCessé le
    Gerald Irwin
    Station House Midland Drive
    B72 1TU Sutton Coldfield
    West Midlands
    practitioner
    Station House Midland Drive
    B72 1TU Sutton Coldfield
    West Midlands

    Source de données

    • Companies House du Royaume-Uni
      Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers.
    • Licence: CC0